BROADHURST ESTATES LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBROADHURST ESTATES LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03694130
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BROADHURST ESTATES LTD ?

    • (7020) /

    Où se situe BROADHURST ESTATES LTD ?

    Adresse du siège social
    The Officers Mazars Llp The Lexicon
    Mount Street
    N2 5NT Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BROADHURST ESTATES LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BROADHURST ESTATES LTD ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour BROADHURST ESTATES LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de compte final avant dissolution

    1 pages4.43

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:liquidator's annual progress report 12/12/12 - 11/12/13
    8 pagesLIQ MISC

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:liquidator's progress report
    9 pagesLIQ MISC

    legacy

    2 pagesLQ02

    Changement d'adresse du siège social de Independence House 43 Oldham Road Rochdale Lancashire OL12 6AA le 22 déc. 2011

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur

    1 pages4.31

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    2 pagesCOCOMP

    legacy

    3 pagesLQ01

    legacy

    3 pagesLQ01

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 janv. 2011

    État du capital au 18 janv. 2011

    • Capital: GBP 1
    SH01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2009

    3 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    legacy

    5 pagesMG01

    legacy

    6 pagesMG02

    legacy

    5 pagesMG01

    legacy

    5 pagesMG01

    legacy

    3 pagesMG02

    Changement d'adresse du siège social de Independence House 43 Oldham Road Rochdale Lancashire OL12 6AA le 11 févr. 2010

    2 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de Bridge House Mellor Street Rochdale Lancashire OL12 6AA le 28 janv. 2010

    1 pagesAD01

    legacy

    5 pagesMG01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    10 pages363a

    Qui sont les dirigeants de BROADHURST ESTATES LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EHRENTREU, Aryeh
    4 Cubley Road
    M7 4GN Salford
    Manchester
    Secrétaire
    4 Cubley Road
    M7 4GN Salford
    Manchester
    British53812040001
    EHRENTREU, Aryeh
    4 Cubley Road
    M7 4GN Salford
    Manchester
    Administrateur
    4 Cubley Road
    M7 4GN Salford
    Manchester
    United KingdomBritish53812040001
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Secrétaire désigné
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900014000001
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Administrateur désigné
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900013990001

    BROADHURST ESTATES LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage deed
    Créé le 22 oct. 2010
    Livré le 05 nov. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H units 10,11 and 12 enterprise park reliance street manchester t/no GM313508; by way of floating charge all the undertaking and all the property and assets, assigns the goodwill of any business. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aldermore Bank PLC
    Transactions
    • 05 nov. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 207 oct. 2011Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (LQ01)
    • 208 août 2012Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (LQ02)
      • Numéro de dossier 2
    Debenture
    Créé le 24 août 2010
    Livré le 03 sept. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aldermore Bank PLC
    Transactions
    • 03 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Mortgage
    Créé le 24 août 2010
    Livré le 03 sept. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The horse shoe inn 2A back hope street and land on the north east side of back hope street salford and 325 and 327 great clowes street salford t/nos LA187845 LA72183 and LA294673 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aldermore Bank PLC
    Transactions
    • 03 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 107 oct. 2011Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (LQ01)
      • Numéro de dossier 1
    Deed of charge
    Créé le 11 nov. 2009
    Livré le 27 nov. 2009
    En cours
    Montant garanti
    £100,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Flat 25 roston court roston road salford see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Graf Financial and Investment Services Limited
    Transactions
    • 27 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    Mortgage
    Créé le 15 mai 2001
    Livré le 17 mai 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage 6 york avenue, prestwich, manchester.
    Personnes ayant droit
    • Woolwich PLC
    Transactions
    • 17 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage
    Créé le 20 sept. 2000
    Livré le 23 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property k/a 25 roston court roston road salford manchester and garage 14 roston court roston road salford manchester, the benefit of all rental income. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Woolwich PLC
    Transactions
    • 23 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Floating charge
    Créé le 20 sept. 2000
    Livré le 23 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the borrowers present and future. Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • Woolwich PLC
    Transactions
    • 23 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage deed
    Créé le 09 juin 1999
    Livré le 29 juin 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of this mortgage
    Brèves mentions
    74 abbotsford rd,t/no GM705636; 11 broadway st,oldham; GM752028; 28 county st,oldham; t/no LA88256 plus 7 other properties listed; all rental income and all right title and interest. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Woolwich PLC
    Transactions
    • 29 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage deed
    Créé le 08 juin 1999
    Livré le 24 juin 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Properties at 51,78,84 and 92 villa road oldham with respective t/o's;-GM697176, LA159577, GM581204 and LA207806. 2 cummings street oldham t/no;-LA63333, 5 pump street oldham LA42211, 23 alton street oldham t/no;-GM616866, 13 darwin street oldham t/no;-GM771921, 33 suffolk street oldham GM672678, 90 crete street oldham GM719102 and 2 devon street oldham GM583156 together with benefit of all rental income all goodwill of business at the property benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Woolwich PLC
    Transactions
    • 24 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)

    BROADHURST ESTATES LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Beverley Jane Robinson
    Scanlans House High Street
    Knowle
    B93 0LL Solihull
    receiver manager
    Scanlans House High Street
    Knowle
    B93 0LL Solihull
    Neil Martin Inman
    Scanlans Consultant Surveyors Llp 618 Warwick Road
    Solihull
    B91 1AA Birmingham
    receiver manager
    Scanlans Consultant Surveyors Llp 618 Warwick Road
    Solihull
    B91 1AA Birmingham
    2Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Beverley Jane Robinson
    Scanlans House High Street
    Knowle
    B93 0LL Solihull
    receiver manager
    Scanlans House High Street
    Knowle
    B93 0LL Solihull
    Neil Martin Inman
    Scanlans Consultant Surveyors Llp 618 Warwick Road
    Solihull
    B91 1AA Birmingham
    receiver manager
    Scanlans Consultant Surveyors Llp 618 Warwick Road
    Solihull
    B91 1AA Birmingham
    3
    DateType
    12 févr. 2015Conclusion of winding up
    20 juil. 2011Petition date
    03 oct. 2011Commencement of winding up
    24 mai 2015Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Tim Alan Askham
    The Lexicon Mount Street
    M2 5NT Manchester
    practitioner
    The Lexicon Mount Street
    M2 5NT Manchester
    The Official Receiver Or Manchester
    2nd Floor, 3 Piccadilly Place
    London Road
    M1 3BN Manchester
    practitioner
    2nd Floor, 3 Piccadilly Place
    London Road
    M1 3BN Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0