DUNEDIN PROPERTY (27 DOVER STREET) LIMITED

DUNEDIN PROPERTY (27 DOVER STREET) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDUNEDIN PROPERTY (27 DOVER STREET) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03697819
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DUNEDIN PROPERTY (27 DOVER STREET) LIMITED ?

    • (7487) /

    Où se situe DUNEDIN PROPERTY (27 DOVER STREET) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O BDO STOY HAYWOOD LLP
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DUNEDIN PROPERTY (27 DOVER STREET) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INVESTEC PROPERTY INVESTMENTS (27 DOVER ST) LIMITED25 févr. 199925 févr. 1999
    LEMONSHAKE LIMITED19 janv. 199919 janv. 1999

    Quels sont les derniers comptes de DUNEDIN PROPERTY (27 DOVER STREET) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour DUNEDIN PROPERTY (27 DOVER STREET) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 janv. 2010

    5 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    legacy

    1 pages287

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 18 juin 2009

    LRESSP

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    6 pages363a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    4 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    pages363(288)

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    4 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes établis au 31 déc. 2005

    4 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    8 pages363s

    legacy

    pages363(288)

    Comptes établis au 31 déc. 2004

    4 pagesAA

    legacy

    8 pages363s

    Comptes établis au 31 déc. 2003

    4 pagesAA

    legacy

    1 pages225

    Qui sont les dirigeants de DUNEDIN PROPERTY (27 DOVER STREET) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SCOTT, Keith
    Clarendon Road
    HP16 0PL Prestwood
    Michaelmas Farm
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Clarendon Road
    HP16 0PL Prestwood
    Michaelmas Farm
    Buckinghamshire
    British141163370001
    KASCH, Peter Carwile
    Filston Oast
    Filston Lane
    TN14 5JU Shoreham
    Kent
    Administrateur
    Filston Oast
    Filston Lane
    TN14 5JU Shoreham
    Kent
    United KingdomBritish61386600003
    NEWISS, Julian Ralph Stewart
    Steanbridge House
    Slad
    GL6 7QE Stroud
    Gloucestershire
    Administrateur
    Steanbridge House
    Slad
    GL6 7QE Stroud
    Gloucestershire
    EnglandBritish25776880001
    WILSON, Guy Ian Swinburn
    Culham House
    High Street Culham
    OX14 4NA Abingdon
    Oxfordshire
    Administrateur
    Culham House
    High Street Culham
    OX14 4NA Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritish141163410001
    DAVIES-RATCLIFF, Grant Ashley
    18 Priory Street
    BN7 1HH Lewes
    East Sussex
    Secrétaire
    18 Priory Street
    BN7 1HH Lewes
    East Sussex
    British68762490001
    FULLERTON, Albert Smyth
    37 Granby Road
    Newington
    EH16 5NP Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    37 Granby Road
    Newington
    EH16 5NP Edinburgh
    Midlothian
    British76362700001
    THOMAS, Kerry Anne Abigail
    25a Danby Street
    East Dulwich
    SE15 4BS London
    Secrétaire
    25a Danby Street
    East Dulwich
    SE15 4BS London
    British61457700001
    TRIBE, Nicholas John Grove
    Yew Tree Cottage
    Sherbourne Street, Edwardstone
    CO10 5PD Sudbury
    Suffolk
    Secrétaire
    Yew Tree Cottage
    Sherbourne Street, Edwardstone
    CO10 5PD Sudbury
    Suffolk
    British141163390001
    KEY LEGAL SERVICES (SECRETARIAL) LIMITED
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    Secrétaire désigné
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    900004240001
    ARNOLD, John Anthony
    4 Beaufort Close
    RH2 9DG Reigate
    Surrey
    Administrateur
    4 Beaufort Close
    RH2 9DG Reigate
    Surrey
    EnglandBritish12419330001
    BARRY, Roun Brendan
    Saracens
    Saunders Lane
    GU22 0NU Woking
    Surrey
    Administrateur
    Saracens
    Saunders Lane
    GU22 0NU Woking
    Surrey
    EnglandIrish26177120002
    BERMEL, Hans Roland
    93 Park Avenue
    EN1 2BB Enfield
    Middlesex
    Administrateur
    93 Park Avenue
    EN1 2BB Enfield
    Middlesex
    British60740950001
    DONOVAN, Michael Thomas
    31 Clearwater Place
    KT6 4ET Long Ditton
    Surrey
    Administrateur
    31 Clearwater Place
    KT6 4ET Long Ditton
    Surrey
    British25402190002
    FULLERTON, Albert Smyth
    37 Granby Road
    Newington
    EH16 5NP Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    37 Granby Road
    Newington
    EH16 5NP Edinburgh
    Midlothian
    British76362700001
    GIBSON, Scott
    9 Harelaw Road
    EH13 0DR Edinburgh
    Administrateur
    9 Harelaw Road
    EH13 0DR Edinburgh
    British48147540001
    LOMAS, Ian Paul
    Caledon Road
    HP9 2BX Beaconsfield
    21
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Caledon Road
    HP9 2BX Beaconsfield
    21
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish94970360001
    PLANK, Colin Andrew
    42 Leasway
    SS12 0HE Wickford
    Essex
    Administrateur
    42 Leasway
    SS12 0HE Wickford
    Essex
    British12419690001
    SCOULAR, Guy William Noel
    83 Cathles Road
    SW12 9LF London
    Administrateur
    83 Cathles Road
    SW12 9LF London
    British79481880001
    STEVENS, Paul Francis
    13 Kearton Place
    169-171 Croydon Road
    CR3 6PH Caterham
    Surrey
    Administrateur
    13 Kearton Place
    169-171 Croydon Road
    CR3 6PH Caterham
    Surrey
    British35887670002
    TRIBE, Nicholas John Grove
    Yew Tree Cottage
    Sherbourne Street, Edwardstone
    CO10 5PD Sudbury
    Suffolk
    Administrateur
    Yew Tree Cottage
    Sherbourne Street, Edwardstone
    CO10 5PD Sudbury
    Suffolk
    United KingdomBritish141163390001
    KEY LEGAL SERVICES (NOMINEES) LIMITED
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    Administrateur désigné
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    900004230001

    DUNEDIN PROPERTY (27 DOVER STREET) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 01 juil. 2003
    Livré le 04 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 juin 2003
    Livré le 04 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land being 27 dover street, piccadilly t/no. 20956. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland ("the Security Trustee")
    Transactions
    • 04 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 janv. 2002
    Livré le 15 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    27 dover st,london; t/no 20956. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 janv. 2002
    Livré le 06 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company (formerly investec property investments (27 dover street) limited) to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 05 mars 1999
    Livré le 25 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property known as 27 dover street, westminster london title 20956 all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery goodwill licences patent applications trademarks copyrights bookdebts and other monetary debts stocks shares first floating charge all plant machinery implements utensils vehicles goods and other equipment.
    Personnes ayant droit
    • Bradford & Bingley Building Society
    Transactions
    • 25 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    DUNEDIN PROPERTY (27 DOVER STREET) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    25 avr. 2010Dissolved on
    18 juin 2009Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0