TNR COMMUNICATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTNR COMMUNICATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03704364
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TNR COMMUNICATIONS LIMITED ?

    • Activités de production de programmes de télévision (59113) / Information et communication

    Où se situe TNR COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Pa Newscentre
    292 Vauxhall Bridge Road
    SW1V 1AE London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TNR COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TELEVISION NEWS RELEASE LIMITED29 janv. 199929 janv. 1999

    Quels sont les derniers comptes de TNR COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour TNR COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 01 mai 2013

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 mars 2013

    État du capital au 27 mars 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Steven Brown le 23 févr. 2012

    1 pagesCH03

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    16 pagesAA

    Cessation de la nomination de Claire Southeard en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Steven Brown en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Susanna Ross en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Clive Paul Marshall en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Cessation de la nomination de David Campbell en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy William Kerr le 01 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Amanda Jane Richards le 30 oct. 2009

    2 pagesCH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Nomination de Mr Timothy William Kerr en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de TNR COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BROWN, Steven John
    Pa Newscentre
    292 Vauxhall Bridge Road
    SW1V 1AE London
    Secrétaire
    Pa Newscentre
    292 Vauxhall Bridge Road
    SW1V 1AE London
    159526640001
    BROWN, Steven John
    7 Broadwater Lane
    Aston
    SG2 7EN Stevenage
    Hertfordshire
    Administrateur
    7 Broadwater Lane
    Aston
    SG2 7EN Stevenage
    Hertfordshire
    United KingdomBritishManaging Director Chartered Ac3379480001
    KERR, Timothy William
    Holmewood Road
    SW2 3RR London
    24
    United Kingdom
    Administrateur
    Holmewood Road
    SW2 3RR London
    24
    United Kingdom
    EnglandBritishHead Of Photography147995740002
    MARSHALL, Clive Paul
    Pa Newscentre
    292 Vauxhall Bridge Road
    SW1V 1AE London
    Administrateur
    Pa Newscentre
    292 Vauxhall Bridge Road
    SW1V 1AE London
    EnglandBritishChief Executive, Pa Group148973430001
    RICHARDS, Amanda Jane
    Elsenham Street
    SW18 5NY London
    111
    United Kingdom
    Administrateur
    Elsenham Street
    SW18 5NY London
    111
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector Of Production & Operations133461500003
    DOCKRAY, Dawn Tracy
    12 Park Lane
    Burn
    YO8 8LW Selby
    North Yorkshire
    Secrétaire
    12 Park Lane
    Burn
    YO8 8LW Selby
    North Yorkshire
    British35663000002
    MAJORIBANKS, Richard John Bradley
    8 Tewit Well Avenue
    HG2 8AP Harrogate
    North Yorkshire
    Secrétaire
    8 Tewit Well Avenue
    HG2 8AP Harrogate
    North Yorkshire
    BritishCompany Secretary83362640001
    ROSS, Susanna Helena
    Tudor Close
    NW3 4AG London
    25
    United Kingdom
    Secrétaire
    Tudor Close
    NW3 4AG London
    25
    United Kingdom
    Other129565780001
    WALLACE, David Adair
    72l Randolph Avenue
    Little Venice
    W9 1BG London
    Secrétaire
    72l Randolph Avenue
    Little Venice
    W9 1BG London
    EnglishManagement Consultant39911770003
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secrétaire désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BOYNTON, Simon Stuart
    Harlequin Lane
    TN6 1HU Crowborough
    Lavander Lodge
    East Sussex
    United Kingdom
    Administrateur
    Harlequin Lane
    TN6 1HU Crowborough
    Lavander Lodge
    East Sussex
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director, Pa Business129575320001
    CAMPBELL, David Ian
    85 The Village
    Haxby
    YO32 2JE York
    North Yorkshire
    Administrateur
    85 The Village
    Haxby
    YO32 2JE York
    North Yorkshire
    EnglandBritishEditor104602970001
    CURTIS-WARD, Sean Anthony Bernard
    35 King Edwards Gardens
    W3 9RF London
    Administrateur
    35 King Edwards Gardens
    W3 9RF London
    EnglandBritishTelevision Producer19391430002
    GARDNER, Stephen
    Sparrows Cottage
    Cage End, Hatfield Broad Oak
    CM22 7HN Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Administrateur
    Sparrows Cottage
    Cage End, Hatfield Broad Oak
    CM22 7HN Bishops Stortford
    Hertfordshire
    BritishJournalist83971540001
    SOUTHEARD, Claire Helen
    Flat 4
    71 West Hill
    SW15 2UL London
    Administrateur
    Flat 4
    71 West Hill
    SW15 2UL London
    United KingdomBritishManaging Director99610640003
    TEUNON, Nicholas John
    29 Monro Drive
    GU2 9PS Guildford
    Surrey
    Administrateur
    29 Monro Drive
    GU2 9PS Guildford
    Surrey
    BritishAccountant80035420001
    WALLACE, David Adair
    72l Randolph Avenue
    Little Venice
    W9 1BG London
    Administrateur
    72l Randolph Avenue
    Little Venice
    W9 1BG London
    EnglandEnglishDirector39911770003
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Administrateur désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    TNR COMMUNICATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 27 oct. 2008
    Livré le 29 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 29 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juin 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 27 oct. 2008
    Livré le 29 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 29 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juin 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 05 juil. 2002
    Livré le 09 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Pa News Limited
    Transactions
    • 09 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 23 mars 2000
    Livré le 28 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    TNR COMMUNICATIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    07 avr. 2014Dissolved on
    01 mai 2013Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0