TRANSOFT LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TRANSOFT LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03705750 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TRANSOFT LIMITED ?
| Adresse du siège social | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TRANSOFT LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 28 févr. 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour TRANSOFT LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour TRANSOFT LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 6 pages | 4.71 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2013 | 6 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Ms Vinodka Murria en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Denise Williams en tant que secrétaire | 3 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kerry Crompton en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Neal Roberts en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Preedy en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Neal Roberts en tant que secrétaire | 2 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mrs Barbara Ann Firth en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Paul David Gibson en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Booths Park 4 Chelford Road Knutsford Cheshire WA16 8GS* le 25 mars 2013 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 30 avr. 2013 au 28 févr. 2013 | 3 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 02 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2012 | 6 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Richard Ian Preedy le 16 août 2012 | 3 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Richard Ian Preedy en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Neal Anthony Roberts le 20 mai 2012 | 4 pages | CH01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Riding Court House Riding Court Road Datchet Slough Berkshire SL3 9JT United Kingdom* le 18 mai 2012 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Neal Anthony Roberts le 16 mai 2012 | 2 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Kerry Jane Crompton le 16 mai 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 02 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de TRANSOFT LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS, Denise | Secrétaire | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | British | 176952950001 | ||||||
| FIRTH, Barbara Ann | Administrateur | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 73934790009 | |||||
| GIBSON, Paul David | Administrateur | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 192439290001 | |||||
| MURRIA, Vinodka | Administrateur | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 57998050002 | |||||
| BAKER, Geoffrey St George | Secrétaire | 6 Sheridan Place TW12 2SB Hampton Middlesex | British | 12812660001 | ||||||
| CHALLINGER, Sara | Secrétaire | Hollyoak 2a Cricket Hill Finchampstead RG40 3TN Wokingham Berkshire | British | 123713140001 | ||||||
| DOBLE, David John | Secrétaire | 47a Oatlands Avenue KT13 9SS Weybridge Surrey | British | 86978140001 | ||||||
| FIRTH, Barbara Ann | Secrétaire | Bryher Cottage Lynx Hill KT24 5AX East Horsley Surrey | British | 73934790001 | ||||||
| GRIX, Jonathan Philip | Secrétaire | Woodside Wood Lane, Beech Hill RG7 2BE Reading Berkshire | British | 65382720001 | ||||||
| HOLLAND, Paul James | Secrétaire | 2738 Kingsburgh Court FOREIGN Marietta 30066 Georgia U.S.A. | British | 65412630001 | ||||||
| ROBERTS, Neal Anthony | Secrétaire | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | British | 140194900001 | ||||||
| PITSEC LIMITED | Secrétaire désigné | 47 Castle Street RG1 7SR Reading Berkshire | 900005210001 | |||||||
| BAKER, Geoffrey St George | Administrateur | 6 Sheridan Place TW12 2SB Hampton Middlesex | United Kingdom | British | 12812660001 | |||||
| CROMPTON, Kerry Jane | Administrateur | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | United Kingdom | British | 158261930001 | |||||
| DIAZ, David | Administrateur | 52 Highway Road SL6 5AE Maidenhead Berkshire | United Kingdom | British | 12812670001 | |||||
| DOBLE, David John | Administrateur | 47a Oatlands Avenue KT13 9SS Weybridge Surrey | England | British | 86978140001 | |||||
| EDWARDS, Michael Geoffrey | Administrateur | Samovar West End Lane Stoke Poges SL2 4NA Slough Berkshire | British | 12812680001 | ||||||
| ENGLAND, David Michael | Administrateur | 119 Teddington Park Road TW11 8NG Teddington Middlesex | England | British | 76796250002 | |||||
| FIRTH, Barbara Ann | Administrateur | Bryher Cottage Lynx Hill KT24 5AX East Horsley Surrey | England | British | 73934790001 | |||||
| GRIX, Jonathan Philip | Administrateur | Woodside Wood Lane, Beech Hill RG7 2BE Reading Berkshire | British | 65382720001 | ||||||
| HOLLAND, Paul James | Administrateur | 2738 Kingsburgh Court FOREIGN Marietta 30066 Georgia U.S.A. | British | 65412630001 | ||||||
| HOLLAND, Paul James | Administrateur | 2738 Kingsburgh Court FOREIGN Marietta 30066 Georgia U.S.A. | British | 65412630001 | ||||||
| JONES, Owen Morgan | Administrateur | 88 The Hawthorns Charvil RG10 9TS Reading Berkshire | British | 49137840002 | ||||||
| LEUW, Martin Philip | Administrateur | Riding Court Road Datchet SL3 9JT Slough Riding Court House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141644370001 | |||||
| MURRIA, Vinodka | Administrateur | Furran 16 Barham Close KT13 9PR Weybridge Surrey | United Kingdom | British | 57998050002 | |||||
| PREEDY, Richard Ian | Administrateur | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | England | British | 123433610003 | |||||
| PRISCOTT, David | Administrateur | 6 Chandlers Reach Itchenor PO20 7BD Chichester West Sussex | British | 63862470001 | ||||||
| ROBERTS, Neal Anthony | Administrateur | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey | England | British | 12470210004 | |||||
| SIMPSON, Jim | Administrateur | 9 Lindsay Drive TW17 8JU Shepperton Middlesex | British | 85221240001 | ||||||
| VELUSSI, Luca | Administrateur | 123 Hepworth Court 30 Gatliff Road SW1W 8QP London | United Kingdom | Italian | 113413330002 | |||||
| CASTLE NOTORNIS LIMITED | Administrateur désigné | 47 Castle Street RG1 7SR Reading Berkshire | 900005200001 |
TRANSOFT LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 02 oct. 2007 Livré le 15 oct. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 21 sept. 2000 Livré le 28 sept. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or transoft group limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 28 sept. 1999 Livré le 04 oct. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
TRANSOFT LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0