SOVEREIGN PROPERTY SOLUTIONS LIMITED

SOVEREIGN PROPERTY SOLUTIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSOVEREIGN PROPERTY SOLUTIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03710519
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SOVEREIGN PROPERTY SOLUTIONS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe SOVEREIGN PROPERTY SOLUTIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Cross House
    Westgate Road
    NE1 4XX Newcastle Upon Tyne
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SOVEREIGN PROPERTY SOLUTIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    H & C NOMINEE CO (NO 8) LIMITED 24 mars 199924 mars 1999
    AREASECOND LIMITED09 févr. 199909 févr. 1999

    Quels sont les derniers comptes de SOVEREIGN PROPERTY SOLUTIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour SOVEREIGN PROPERTY SOLUTIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2017

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 05 janv. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Third Floor One London Square Cross Lanes Guildford Surrey GU1 1UN à Cross House Westgate Road Newcastle upon Tyne NE1 4XX

    1 pagesAD02

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Cross House Westgate Road Newcastle upon Tyne NE1 4XX

    1 pagesAD04

    Modification des détails de Sovereign Reversions Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 juil. 2017

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de 17 Dominion Street London EC2M 2EF United Kingdom à Cross House Westgate Road Newcastle upon Tyne NE1 4XX le 07 juil. 2017

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Antony Lewis Pierce en tant qu'administrateur le 05 juil. 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Paul Trevor Barber en tant qu'administrateur le 05 juil. 2017

    2 pagesAP01

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 déc. 2017 au 30 sept. 2017

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Neal Morar en tant que secrétaire le 05 juil. 2017

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Robert John Calnan en tant que directeur le 05 juil. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Neal Morar en tant que directeur le 05 juil. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2016

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 févr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    5 pagesAA

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Third Floor One London Square Cross Lanes Guildford Surrey GU1 1UN

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Third Floor One London Square Cross Lanes Guildford Surrey GU1 1UN

    2 pagesAD02

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 févr. 2016

    État du capital au 22 févr. 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Changement de date de référence comptable

    3 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Nicholas Peter On en tant que directeur le 01 juin 2015

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Paul Trevor Barber en tant que directeur le 01 juin 2015

    2 pagesTM01

    Nomination de Neal Morar en tant que secrétaire le 01 juin 2015

    3 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de SOVEREIGN PROPERTY SOLUTIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BARBER, Paul Trevor
    Westgate Road
    NE1 4XX Newcastle Upon Tyne
    Cross House
    United Kingdom
    Administrateur
    Westgate Road
    NE1 4XX Newcastle Upon Tyne
    Cross House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive230642640001
    PIERCE, Antony Lewis
    Westgate Road
    NE1 4XX Newcastle Upon Tyne
    Cross House
    United Kingdom
    Administrateur
    Westgate Road
    NE1 4XX Newcastle Upon Tyne
    Cross House
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director156315340001
    CAVES, John Edward
    27 Northill Road
    Cople
    MK44 3TU Bedford
    Bedfordshire
    Secrétaire
    27 Northill Road
    Cople
    MK44 3TU Bedford
    Bedfordshire
    BritishChartered Accountant2580410002
    MORAR, Neal
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Secrétaire
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    198675350001
    WINDLE, Michael Patrick
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    Secrétaire
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    British156112630001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARBER, Paul Trevor
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Administrateur
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director121775760002
    BURGESS, Susan Ann
    22 Tyburn Lane
    MK45 5HG Pulloxhill
    Bedfordshire
    Administrateur
    22 Tyburn Lane
    MK45 5HG Pulloxhill
    Bedfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant46558140002
    CALNAN, Robert John
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor197408030001
    CAVES, John Edward
    27 Northill Road
    Cople
    MK44 3TU Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    27 Northill Road
    Cople
    MK44 3TU Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant2580410002
    COUCH, Peter Quentin Patrick
    GL5 5AG Amberley
    Follifoot House
    Gloucestershire
    Administrateur
    GL5 5AG Amberley
    Follifoot House
    Gloucestershire
    UkBritishCompany Director156117090001
    HARE-SCOTT, Nigel Trewren
    3 Staffords
    Churchgate Street
    CM17 0JR Old Harlow
    Essex
    Administrateur
    3 Staffords
    Churchgate Street
    CM17 0JR Old Harlow
    Essex
    EnglandBritishBusiness Development & Client4555820001
    INSKIP, John Geoffrey
    Tostock House
    Tostock
    IP30 9PR Bury St Edmunds
    Suffolk
    Administrateur
    Tostock House
    Tostock
    IP30 9PR Bury St Edmunds
    Suffolk
    United KingdomBritishCompany Director2580430001
    LITTLE, Simon
    4 Yeates Close
    Off Byford Way
    MK18 3RH Winslow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    4 Yeates Close
    Off Byford Way
    MK18 3RH Winslow
    Buckinghamshire
    EnglandBritishBusiness Development Director123953930001
    MARSHALL, Graeme Calder Walker
    Black Knoll House Rhinefield Road
    SO42 7QE Brockenhurst
    Hampshire
    Administrateur
    Black Knoll House Rhinefield Road
    SO42 7QE Brockenhurst
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director56957920002
    MARSHALL, Graeme Calder Walker
    Black Knoll House Rhinefield Road
    SO42 7QE Brockenhurst
    Hampshire
    Administrateur
    Black Knoll House Rhinefield Road
    SO42 7QE Brockenhurst
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director56957920002
    MCDONALD, Ian Alexander
    Pheasants Nest Farm
    Weston Underwood
    MK46 5LA Olney
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Pheasants Nest Farm
    Weston Underwood
    MK46 5LA Olney
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant56350370001
    MORAR, Neal
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director173110500001
    ODHAMS, James Leonard
    The Pines 27 Corfe Way
    BH18 9ND Broadstone
    Dorset
    Administrateur
    The Pines 27 Corfe Way
    BH18 9ND Broadstone
    Dorset
    BritishSolicitor62815400001
    ON, Nicholas Peter
    St. James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    Administrateur
    St. James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    United KingdomBritishLawyer135860930002
    SIDWELL, Graham Robert
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Administrateur
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    United KingdomBritishNone72844280004
    TAYLOR, David Michael
    11 Preston Road
    MK40 4DU Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    11 Preston Road
    MK40 4DU Bedford
    Bedfordshire
    BritishOperations Director108648900001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SOVEREIGN PROPERTY SOLUTIONS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Westgate Road
    NE1 4XX Newcastle Upon Tyne
    Cross House
    United Kingdom
    25 mai 2016
    Westgate Road
    NE1 4XX Newcastle Upon Tyne
    Cross House
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement07619855
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    SOVEREIGN PROPERTY SOLUTIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage (third party)
    Créé le 25 sept. 2008
    Livré le 11 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £98,430.12 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The property k/a 17 witley crescent new addington croydon.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC
    Transactions
    • 11 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage (third party)
    Créé le 25 sept. 2008
    Livré le 11 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £85,405.12 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The property k/a 57 rowland greenhill herne bay kent.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC
    Transactions
    • 11 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage (third party)
    Créé le 25 sept. 2008
    Livré le 11 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £36,465.12 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The property k/a 8 scafell avenue ashton-under-lyme manchester.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC
    Transactions
    • 11 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage (third party)
    Créé le 25 sept. 2008
    Livré le 11 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £100391.12 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The property k/a 7 litherland avenue wirral merseyside.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC
    Transactions
    • 11 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage (third party)
    Créé le 25 sept. 2008
    Livré le 11 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £82,505.12 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The property k/a 49 charlotte close mount hawke truro cornwall.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC
    Transactions
    • 11 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage (third party)
    Créé le 25 sept. 2008
    Livré le 11 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £56,380.25 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The property k/a flat 45 homecolne house louden road cromer.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC
    Transactions
    • 11 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage (third party)
    Créé le 25 sept. 2008
    Livré le 11 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £70,987.12 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The property k/a flat 39 mayhall court westway maghull liverpool.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC
    Transactions
    • 11 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage (third party)
    Créé le 25 sept. 2008
    Livré le 11 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    349,205.12 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The property k/a 1 deacon road bridgwater somerset.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC
    Transactions
    • 11 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage (third party)
    Créé le 25 sept. 2008
    Livré le 11 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £63,265.12 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The property k/a 75 thames road skelton redacar & cleveland.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC
    Transactions
    • 11 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage (third party)
    Créé le 25 sept. 2008
    Livré le 11 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £114,340.12 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The property k/a 22 plymouth place lemington spa warwickshire.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC
    Transactions
    • 11 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage (third party)
    Créé le 25 sept. 2008
    Livré le 11 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £72,431.25 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The property k/a 4 chase gardens chingford and garage 4 london.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC
    Transactions
    • 11 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage (third party)
    Créé le 25 sept. 2008
    Livré le 11 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £118,641.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The property k/a 6 carn close beighton norfolk.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC
    Transactions
    • 11 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage (third party)
    Créé le 25 sept. 2008
    Livré le 11 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £40,625.12 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The property k/a 169 queensway wellingborough abd garage northamptonshire.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC
    Transactions
    • 11 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage (thrd party)
    Créé le 25 sept. 2008
    Livré le 11 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £75,485.12 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The property k/a 33 grange road geddington northamptonshire.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC
    Transactions
    • 11 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage (third party)
    Créé le 25 sept. 2008
    Livré le 11 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £83,545.12 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The property k/a 50 the avenue goring by sea worthing west sussex.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC
    Transactions
    • 11 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgege (third party)
    Créé le 01 août 2007
    Livré le 10 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Rev 6696 6 greenacres westfield hastings east sussex t/no sx 3249, rev 6700 11 top road barnby dun doncaster south yorkshire t/no syk 406642 and rev 6744 6 dorset close attleborough norfolk t/no nk 157144 for details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC
    Transactions
    • 10 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 juin 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 06 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0