SOVEREIGN PROPERTY SOLUTIONS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | SOVEREIGN PROPERTY SOLUTIONS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03710519 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SOVEREIGN PROPERTY SOLUTIONS LIMITED ?
Adresse du siège social | Cross House Westgate Road NE1 4XX Newcastle Upon Tyne United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SOVEREIGN PROPERTY SOLUTIONS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour SOVEREIGN PROPERTY SOLUTIONS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2017 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 janv. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Third Floor One London Square Cross Lanes Guildford Surrey GU1 1UN à Cross House Westgate Road Newcastle upon Tyne NE1 4XX | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Cross House Westgate Road Newcastle upon Tyne NE1 4XX | 1 pages | AD04 | ||||||||||
Modification des détails de Sovereign Reversions Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 juil. 2017 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 17 Dominion Street London EC2M 2EF United Kingdom à Cross House Westgate Road Newcastle upon Tyne NE1 4XX le 07 juil. 2017 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Mr Antony Lewis Pierce en tant qu'administrateur le 05 juil. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Paul Trevor Barber en tant qu'administrateur le 05 juil. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Période comptable actuelle raccourcie du 31 déc. 2017 au 30 sept. 2017 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Neal Morar en tant que secrétaire le 05 juil. 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robert John Calnan en tant que directeur le 05 juil. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Neal Morar en tant que directeur le 05 juil. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2016 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 févr. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 5 pages | AA | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Third Floor One London Square Cross Lanes Guildford Surrey GU1 1UN | 2 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Third Floor One London Square Cross Lanes Guildford Surrey GU1 1UN | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 10 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement de date de référence comptable | 3 pages | AA01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nicholas Peter On en tant que directeur le 01 juin 2015 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Trevor Barber en tant que directeur le 01 juin 2015 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Neal Morar en tant que secrétaire le 01 juin 2015 | 3 pages | AP03 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SOVEREIGN PROPERTY SOLUTIONS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARBER, Paul Trevor | Administrateur | Westgate Road NE1 4XX Newcastle Upon Tyne Cross House United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Executive | 230642640001 | ||||
PIERCE, Antony Lewis | Administrateur | Westgate Road NE1 4XX Newcastle Upon Tyne Cross House United Kingdom | England | British | Finance Director | 156315340001 | ||||
CAVES, John Edward | Secrétaire | 27 Northill Road Cople MK44 3TU Bedford Bedfordshire | British | Chartered Accountant | 2580410002 | |||||
MORAR, Neal | Secrétaire | Dominion Street EC2M 2EF London 17 United Kingdom | 198675350001 | |||||||
WINDLE, Michael Patrick | Secrétaire | St James' Boulevard NE1 4JE Newcastle Upon Tyne Citygate | British | 156112630001 | ||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BARBER, Paul Trevor | Administrateur | St James' Boulevard NE1 4JE Newcastle Upon Tyne Citygate United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 121775760002 | ||||
BURGESS, Susan Ann | Administrateur | 22 Tyburn Lane MK45 5HG Pulloxhill Bedfordshire | England | British | Chartered Accountant | 46558140002 | ||||
CALNAN, Robert John | Administrateur | Dominion Street EC2M 2EF London 17 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 197408030001 | ||||
CAVES, John Edward | Administrateur | 27 Northill Road Cople MK44 3TU Bedford Bedfordshire | England | British | Chartered Accountant | 2580410002 | ||||
COUCH, Peter Quentin Patrick | Administrateur | GL5 5AG Amberley Follifoot House Gloucestershire | Uk | British | Company Director | 156117090001 | ||||
HARE-SCOTT, Nigel Trewren | Administrateur | 3 Staffords Churchgate Street CM17 0JR Old Harlow Essex | England | British | Business Development & Client | 4555820001 | ||||
INSKIP, John Geoffrey | Administrateur | Tostock House Tostock IP30 9PR Bury St Edmunds Suffolk | United Kingdom | British | Company Director | 2580430001 | ||||
LITTLE, Simon | Administrateur | 4 Yeates Close Off Byford Way MK18 3RH Winslow Buckinghamshire | England | British | Business Development Director | 123953930001 | ||||
MARSHALL, Graeme Calder Walker | Administrateur | Black Knoll House Rhinefield Road SO42 7QE Brockenhurst Hampshire | England | British | Company Director | 56957920002 | ||||
MARSHALL, Graeme Calder Walker | Administrateur | Black Knoll House Rhinefield Road SO42 7QE Brockenhurst Hampshire | England | British | Company Director | 56957920002 | ||||
MCDONALD, Ian Alexander | Administrateur | Pheasants Nest Farm Weston Underwood MK46 5LA Olney Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 56350370001 | |||||
MORAR, Neal | Administrateur | Dominion Street EC2M 2EF London 17 United Kingdom | England | British | Finance Director | 173110500001 | ||||
ODHAMS, James Leonard | Administrateur | The Pines 27 Corfe Way BH18 9ND Broadstone Dorset | British | Solicitor | 62815400001 | |||||
ON, Nicholas Peter | Administrateur | St. James Boulevard NE1 4JE Newcastle Upon Tyne Citygate Tyne And Wear United Kingdom | United Kingdom | British | Lawyer | 135860930002 | ||||
SIDWELL, Graham Robert | Administrateur | St James' Boulevard NE1 4JE Newcastle Upon Tyne Citygate United Kingdom | United Kingdom | British | None | 72844280004 | ||||
TAYLOR, David Michael | Administrateur | 11 Preston Road MK40 4DU Bedford Bedfordshire | British | Operations Director | 108648900001 | |||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SOVEREIGN PROPERTY SOLUTIONS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sovereign Reversions Holdings Limited | 25 mai 2016 | Westgate Road NE1 4XX Newcastle Upon Tyne Cross House United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
SOVEREIGN PROPERTY SOLUTIONS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Legal mortgage (third party) | Créé le 25 sept. 2008 Livré le 11 oct. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti £98,430.12 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions The property k/a 17 witley crescent new addington croydon. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage (third party) | Créé le 25 sept. 2008 Livré le 11 oct. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti £85,405.12 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions The property k/a 57 rowland greenhill herne bay kent. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage (third party) | Créé le 25 sept. 2008 Livré le 11 oct. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti £36,465.12 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions The property k/a 8 scafell avenue ashton-under-lyme manchester. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage (third party) | Créé le 25 sept. 2008 Livré le 11 oct. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti £100391.12 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions The property k/a 7 litherland avenue wirral merseyside. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage (third party) | Créé le 25 sept. 2008 Livré le 11 oct. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti £82,505.12 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions The property k/a 49 charlotte close mount hawke truro cornwall. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage (third party) | Créé le 25 sept. 2008 Livré le 11 oct. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti £56,380.25 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions The property k/a flat 45 homecolne house louden road cromer. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage (third party) | Créé le 25 sept. 2008 Livré le 11 oct. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti £70,987.12 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions The property k/a flat 39 mayhall court westway maghull liverpool. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage (third party) | Créé le 25 sept. 2008 Livré le 11 oct. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti 349,205.12 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions The property k/a 1 deacon road bridgwater somerset. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage (third party) | Créé le 25 sept. 2008 Livré le 11 oct. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti £63,265.12 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions The property k/a 75 thames road skelton redacar & cleveland. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage (third party) | Créé le 25 sept. 2008 Livré le 11 oct. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti £114,340.12 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions The property k/a 22 plymouth place lemington spa warwickshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage (third party) | Créé le 25 sept. 2008 Livré le 11 oct. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti £72,431.25 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions The property k/a 4 chase gardens chingford and garage 4 london. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage (third party) | Créé le 25 sept. 2008 Livré le 11 oct. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti £118,641.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions The property k/a 6 carn close beighton norfolk. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage (third party) | Créé le 25 sept. 2008 Livré le 11 oct. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti £40,625.12 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions The property k/a 169 queensway wellingborough abd garage northamptonshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage (thrd party) | Créé le 25 sept. 2008 Livré le 11 oct. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti £75,485.12 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions The property k/a 33 grange road geddington northamptonshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage (third party) | Créé le 25 sept. 2008 Livré le 11 oct. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti £83,545.12 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions The property k/a 50 the avenue goring by sea worthing west sussex. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgege (third party) | Créé le 01 août 2007 Livré le 10 août 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Rev 6696 6 greenacres westfield hastings east sussex t/no sx 3249, rev 6700 11 top road barnby dun doncaster south yorkshire t/no syk 406642 and rev 6744 6 dorset close attleborough norfolk t/no nk 157144 for details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0