ACCORD LEASING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéACCORD LEASING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03710856
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ACCORD LEASING LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe ACCORD LEASING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    West Point
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ACCORD LEASING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 déc. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour ACCORD LEASING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 juin 2016

    11 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 25 juin 2015

    9 pages4.68

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Changement d'adresse du siège social de Lancaster House Centurion Way Leyland Lancashire PR26 6TX à West Point Old Trafford Manchester M16 9HU le 18 juil. 2014

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 26 juin 2014

    LRESSP

    Nomination de Mr Andrew Michael Eastwood en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Paul Birch en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Nelson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Melvyn Ewell en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 févr. 2014

    État du capital au 13 févr. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 déc. 2012

    6 pagesAA

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    Nomination de Sherard Secretariat Services Limited en tant que secrétaire

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Paul Birch en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Melvyn Ewell en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Andrew Latham Nelson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Arnold en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ian Fraser en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Stuart Chaston en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Atherton en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Ian Ellis Fraser en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de ACCORD LEASING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Secrétaire
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement5615519
    109588620001
    BIRCH, Paul
    Lancashire Enterprise Business Park
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    England
    Administrateur
    Lancashire Enterprise Business Park
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    England
    EnglandBritish76116640003
    EASTWOOD, Andrew Michael
    Lancashire Enterprise Business Park
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    England
    Administrateur
    Lancashire Enterprise Business Park
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    England
    EnglandBritish160883820001
    BIRCH, Paul
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    British76116640002
    HARVEY, Stephen George
    163 High Road
    EN10 7BT Broxbourne
    Hertfordshire
    Secrétaire
    163 High Road
    EN10 7BT Broxbourne
    Hertfordshire
    British67162750001
    KELLY, Paula Frona
    12 Chells Lane
    SG2 7AA Stevenage
    Herts
    Secrétaire
    12 Chells Lane
    SG2 7AA Stevenage
    Herts
    British95469920001
    MILLER, Paul Sydney
    26 Mardley Hill
    AL6 0TS Welwyn
    Hertfordshire
    Secrétaire
    26 Mardley Hill
    AL6 0TS Welwyn
    Hertfordshire
    British39022040001
    PRYOR, Peter David
    Jay Cottage
    Little Hormead
    SG9 0LZ Buntingford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Jay Cottage
    Little Hormead
    SG9 0LZ Buntingford
    Hertfordshire
    British67736270003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ARNOLD, David Llewelyn
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish181213200001
    ATHERTON, David
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish109058740001
    CHASTON, Stuart Paul
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish126271790001
    EWELL, Melvyn
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Administrateur
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    EnglandBritish61515760002
    FARRAR, Roland Martin
    40 Chiltern Road
    SL6 1XA Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    40 Chiltern Road
    SL6 1XA Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritish29009510002
    FELLOWES PRYNNE, Philip Windover
    76 The Shearers
    St Michaels Mead
    CM23 4AZ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Administrateur
    76 The Shearers
    St Michaels Mead
    CM23 4AZ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British80861440001
    FOLBIGG, David Stanley
    The Old School House
    Felmersham
    MK43 7HN Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    The Old School House
    Felmersham
    MK43 7HN Bedford
    Bedfordshire
    British14310300001
    FRASER, Ian Ellis
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    ScotlandUk28393850006
    JOYCE, Martin John
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish72254420003
    KIRKBY, Neil Robert Ernest
    5 Dashwood Close
    Grappenhall
    WA4 3JA Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    5 Dashwood Close
    Grappenhall
    WA4 3JA Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish51438040006
    MCLAUGHLIN, Owen Gerard
    Lancaster House
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancashire
    Administrateur
    Lancaster House
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancashire
    United KingdomBritish17129800004
    MILLER, Paul Sydney
    26 Mardley Hill
    AL6 0TS Welwyn
    Hertfordshire
    Administrateur
    26 Mardley Hill
    AL6 0TS Welwyn
    Hertfordshire
    British39022040001
    NELSON, Andrew Latham
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Administrateur
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    United KingdomBritish36191090003
    PRYOR, Peter David
    Jay Cottage
    Little Hormead
    SG9 0LZ Buntingford
    Hertfordshire
    Administrateur
    Jay Cottage
    Little Hormead
    SG9 0LZ Buntingford
    Hertfordshire
    EnglandBritish67736270003
    SHUTKEVER, Adam Emmanuel
    11 Oakfield Road
    AL5 2NJ Harpenden
    Herts
    Administrateur
    11 Oakfield Road
    AL5 2NJ Harpenden
    Herts
    United KingdomBritish81455510002
    STEFANOU, Stelio Haralambos
    1 Tewin Water House
    Tewin Water
    AL6 0AA Welwyn
    Hertfordshire
    Administrateur
    1 Tewin Water House
    Tewin Water
    AL6 0AA Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritish2749630007

    ACCORD LEASING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 12 nov. 2007
    Livré le 28 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become from each obligor and each grantor of security to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee, Richard Butcher as Pension Trustee, Pitman Trusteeslimited as Pension Trustee, Philip Bridge as Pension Trustee and Each of Their Assignors Transferees and Successiors from Time to Time
    Transactions
    • 28 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Chattels mortgage
    Créé le 14 juin 2000
    Livré le 15 juin 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Chattels k/a motor vehicles k/a 2 x volkswagen passat reg no W82 yor, W83 yor chassis no 3BYP290388 & 3BYP291905 for further chattels please refer to form 395.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 15 juin 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 08 déc. 1999
    Livré le 23 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the financing documents
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ACCORD LEASING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    26 juin 2014Commencement of winding up
    11 janv. 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Beverley Ellice Budsworth
    The Debt Advisor West Point 501 Chester Road
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester
    practitioner
    The Debt Advisor West Point 501 Chester Road
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0