CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED

CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03712018
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED ?

    • (6603) /

    Où se situe CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Yorkshire House
    18 Chapel Street
    L3 9AG Liverpool
    Merseyside
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CBS INSURANCE HOLDINGS PLC24 mars 199924 mars 1999
    FORECASTWIN PUBLIC LIMITED COMPANY11 févr. 199911 févr. 1999

    Quels sont les derniers comptes de CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pages4.71

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 15 févr. 2012

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 15 févr. 2012

    LRESSP

    Changement d'adresse du siège social de Unit C25 Jacks Place 6 Corbet Place London E1 6NN le 21 févr. 2012

    2 pagesAD01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2010

    32 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    18 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 mars 2011

    État du capital au 03 mars 2011

    • Capital: GBP 4,593.86
    SH01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2009

    36 pagesAA

    État du capital au 18 août 2010

    • Capital: GBP 4,559.3855
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Reduce share prem 14/07/2010
    RES13

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 févr. 2010. La liste des actionnaires a été modifiée

    22 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    22 pagesAR01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2008

    35 pagesAA

    legacy

    13 pages363a

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-MDSC

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduction of share premium account 17/12/2008
    RES13

    Certificat de réimmatriculation de société anonyme à responsabilité limitée

    1 pagesCERT10

    Réenregistrement des statuts

    48 pagesMAR

    Qui sont les dirigeants de CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FOX, Andrew Staley
    4 Dukes Road
    RH16 2JH Haywards Heath
    West Sussex
    Secrétaire
    4 Dukes Road
    RH16 2JH Haywards Heath
    West Sussex
    British43073160004
    EWART, David John
    Courthill House
    Potterne
    SN10 5PN Devizes
    Wiltshire
    Administrateur
    Courthill House
    Potterne
    SN10 5PN Devizes
    Wiltshire
    United KingdomBritish23635320001
    HARBORD-HAMOND, Charles Anthony Assheton
    45 Alderbrook Road
    SW12 8AD London
    Administrateur
    45 Alderbrook Road
    SW12 8AD London
    United KingdomBritish56874210004
    CRAWFORD SMITH, Neil Leslie
    11 Manor Rise
    ME14 4DB Bearsted
    Kent
    Secrétaire
    11 Manor Rise
    ME14 4DB Bearsted
    Kent
    British97197960001
    HILL, Jeremy Grahame
    Orwell Cottage
    School Hill, Nacton
    IP10 0EH Ipswich
    Suffolk
    Secrétaire
    Orwell Cottage
    School Hill, Nacton
    IP10 0EH Ipswich
    Suffolk
    British69062000004
    MCMULLEN, Gerald Phipps
    Little Broomhall Warnham
    RH12 3PA Horsham
    West Sussex
    Secrétaire
    Little Broomhall Warnham
    RH12 3PA Horsham
    West Sussex
    British19668600001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CASTELL, Andrew Sean
    13 Chantry Street
    N1 8NR London
    Administrateur
    13 Chantry Street
    N1 8NR London
    British85990150001
    FABER, Robin Henry Grey
    Kingsmead House
    Didmarton
    GL9 1DT Badminton
    South Gloucestershire
    Administrateur
    Kingsmead House
    Didmarton
    GL9 1DT Badminton
    South Gloucestershire
    EnglandBritish104985010001
    HILL, Jeremy Grahame
    Orwell Cottage
    School Hill, Nacton
    IP10 0EH Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    Orwell Cottage
    School Hill, Nacton
    IP10 0EH Ipswich
    Suffolk
    British69062000004
    HOLBECH, Timothy Hugh
    64 Geraldine Road
    SW18 2NL London
    Administrateur
    64 Geraldine Road
    SW18 2NL London
    British19390190001
    LEE, Michael Alan
    4 Wilona Avenue
    North Sydney
    FOREIGN Nsw
    2060
    Australia
    Administrateur
    4 Wilona Avenue
    North Sydney
    FOREIGN Nsw
    2060
    Australia
    Australian92794500001
    MCCLEAN, Michael Hugh Patrick
    33b Cornwall Crescent
    W11 1PJ London
    Administrateur
    33b Cornwall Crescent
    W11 1PJ London
    British57912890001
    ROYDS, Emma Louise
    4 Lysias Road
    SW12 8BP London
    Administrateur
    4 Lysias Road
    SW12 8BP London
    British30320080003
    SPARROW, Andrew James
    Eye Kettleby Hall
    LE14 2TS Melton Mowbray
    Leicestershire
    Administrateur
    Eye Kettleby Hall
    LE14 2TS Melton Mowbray
    Leicestershire
    EnglandBritish19390170004
    WATSON, Michael John Bannatyne
    3 Edenhurst Avenue
    SW6 3PD London
    Administrateur
    3 Edenhurst Avenue
    SW6 3PD London
    British64292610002
    WHITE, Graham John
    Toad Hall Glebe House
    38 High Street Melbourn
    SG8 6DZ Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    Toad Hall Glebe House
    38 High Street Melbourn
    SG8 6DZ Royston
    Hertfordshire
    EnglandBritish116735630001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Administrateur désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 14 oct. 2004
    Livré le 25 oct. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the trustee or any of the other beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company, the investments, the shares, all dividends, interest and other moneys payable in respect of the shares; and all monetary claims and all related rights. Assignment of the proceeds of any insurance policy and all related rights; and all rights and claims in relation to any assigned account. First floating charge over the whole of the company's undertaking and assets, both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 25 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Share charge
    Créé le 11 oct. 2004
    Livré le 25 oct. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all right title and interest in and to the shares all dividends interest and other monies payable in respect of the shares and all other related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 11 oct. 2004
    Livré le 25 oct. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed charge the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company, the investments, the shares, all dividends, interest and other moneys payable in respect of the shares; and all monetary claims and all related rights. Assignment of the proceeds of any insurance policy and all related rights; and all rights and claims in relation to any assigned account. First floating charge over the whole of the company's undertaking and assets, both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 nov. 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Floating charge
    Créé le 21 févr. 2002
    Livré le 07 mars 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge. Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • The Society Incorporated by Lloyd's Act 1871
    Transactions
    • 07 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 15 janv. 2002
    Livré le 16 janv. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 nov. 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Debenture
    Créé le 26 nov. 1999
    Livré le 03 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 nov. 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 18 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    04 mars 2013Dissolved on
    15 févr. 2012Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Paul J Fleming
    Yorkshire House 18 Chapel Street
    L3 9AG Liverpool
    practitioner
    Yorkshire House 18 Chapel Street
    L3 9AG Liverpool

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0