PLATFORM CONSUMER SERVICES LIMITED

PLATFORM CONSUMER SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPLATFORM CONSUMER SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03720213
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PLATFORM CONSUMER SERVICES LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PLATFORM CONSUMER SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PLATFORM CONSUMER SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CABOT CONSUMER SERVICES LIMITED 26 août 199926 août 1999
    CROCUSBRIGHT LIMITED25 févr. 199925 févr. 1999

    Quels sont les derniers comptes de PLATFORM CONSUMER SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour PLATFORM CONSUMER SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    15 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 21 sept. 2017

    15 pagesLIQ03

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal

    10 pagesLIQ10

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Secretariat Miller Street Tower Miller Street Manchester M60 0AL

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Secretariat Miller Street Tower Miller Street Manchester M60 0AL

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Secretariat Miller Street Tower Miller Street Manchester England M60 0AL à Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR le 06 oct. 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 22 sept. 2016

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    État du capital au 20 sept. 2016

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    4 pagesSH20

    legacy

    4 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 mai 2016

    État du capital au 25 mai 2016

    • Capital: GBP 5,000,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    22 pagesAA

    Nomination de Mr Nicholas Gibson Websdell en tant qu'administrateur le 20 août 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Isabel Mary Chadwick en tant qu'administrateur le 20 août 2015

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 juil. 2015

    État du capital au 08 juil. 2015

    • Capital: GBP 5,000,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Clare Louise Gosling en tant que directeur le 15 juin 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Daniel Mundy en tant qu'administrateur le 15 juin 2015

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de Newton House Cheadle Road Leek Staffordshire ST13 5RG à Secretariat Miller Street Tower Miller Street Manchester England M60 0AL le 12 mai 2015

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr David Clive Whitehead en tant que secrétaire le 30 mars 2015

    2 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de PLATFORM CONSUMER SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WHITEHEAD, David Clive
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    Secrétaire
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    196735240001
    CHADWICK, Isabel Mary
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    Administrateur
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    EnglandBritishHead Of Costs174564650002
    MCGIRR, Grahame George Scott
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    Administrateur
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    EnglandBritishCompany Director184111130001
    MUNDY, Daniel
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    Administrateur
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    United KingdomBritishDirector Of Strategic Planning189420920001
    WEBSDELL, Nicholas Gibson
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    United Kingdom
    Administrateur
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    United Kingdom
    EnglandBritishHead Of Business Banking And Commercial Sales201065000001
    ARCKLESS, Jane Alison
    36 Pondfield Crescent
    AL4 9PF St. Albans
    Hertfordshire
    Secrétaire
    36 Pondfield Crescent
    AL4 9PF St. Albans
    Hertfordshire
    British67947660001
    ARNOLD, Katy Jane
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Secrétaire
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    192244560001
    GREEN, Robin Sinclair
    9 Buckland Grove
    New Park
    ST4 8UG Trentham
    Staffordshire
    Secrétaire
    9 Buckland Grove
    New Park
    ST4 8UG Trentham
    Staffordshire
    BritishBuilding Society Executive5782770001
    HUDSON, Matthew Donald Jeremy
    14a South Hill Park Gardens
    NW3 2TG London
    Secrétaire
    14a South Hill Park Gardens
    NW3 2TG London
    British72420070002
    HYLTON, Rosemarie
    Silverdene
    Shirley Church Road
    CR0 5AF Shirley
    Surrey
    Secrétaire
    Silverdene
    Shirley Church Road
    CR0 5AF Shirley
    Surrey
    British115762060001
    MCKEOWN, Brona Rose
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    Secrétaire
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    193735850001
    MILLS, Paul Andrew
    Woodcote 8 Hall Orchard
    Bramshall
    ST14 5DF Uttoxeter
    Staffordshire
    Secrétaire
    Woodcote 8 Hall Orchard
    Bramshall
    ST14 5DF Uttoxeter
    Staffordshire
    BritishGroup Secretary34173070002
    MOSS, Susan
    9th Floor
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Corporate Governance
    United Kingdom
    Secrétaire
    9th Floor
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Corporate Governance
    United Kingdom
    151801210001
    OWEN, Robert James Holland
    Waterside Close
    DE22 1JT Derby
    7
    Derbyshire
    Secrétaire
    Waterside Close
    DE22 1JT Derby
    7
    Derbyshire
    British73708980005
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire désigné
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    CHARLTON, Peter John
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur désigné
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    British900005610001
    CLARK, James Roy
    21 Ladbroke Square
    W11 3NA London
    Administrateur
    21 Ladbroke Square
    W11 3NA London
    United KingdomAmericanInvestment Banker65072010002
    GODDARD, Richard Thomas
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Administrateur
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant63087570001
    GOSLING, Clare Louise
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    Administrateur
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    EnglandBritishCompany Director204863170001
    GREEN, Peter
    21 Main Street
    YO10 5EA Heslington
    York
    Administrateur
    21 Main Street
    YO10 5EA Heslington
    York
    BritishHead Of Treasury74913270001
    GREEN, Robin Sinclair
    9 Buckland Grove
    New Park
    ST4 8UG Trentham
    Staffordshire
    Administrateur
    9 Buckland Grove
    New Park
    ST4 8UG Trentham
    Staffordshire
    BritishDeputy Secretary5782770001
    GREGORY, Gerald Arthur
    Gatepiece House
    Quarry Bank
    DE4 3LF Matlock
    Derbyshire
    Administrateur
    Gatepiece House
    Quarry Bank
    DE4 3LF Matlock
    Derbyshire
    EnglandBritishBuilding Society Director31843730001
    HUGHES, John Richard
    9th Floor
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Corporate Governance
    United Kingdom
    Administrateur
    9th Floor
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Corporate Governance
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector Of Retail Banking146426540002
    KERNS, Peter William
    26 Swinhoe Place
    Hob Hey Lane
    WA3 4NE Culcheth
    Cheshire
    Administrateur
    26 Swinhoe Place
    Hob Hey Lane
    WA3 4NE Culcheth
    Cheshire
    United KingdomBritishSolicitor67171290002
    LEE, Phillip Andrew
    11 Badger Road
    SK10 4JG Prestbury
    Cheshire
    Administrateur
    11 Badger Road
    SK10 4JG Prestbury
    Cheshire
    United KingdomBritishBuilding Society Director89215420001
    MCCARTHY, David James
    Far End
    Sheepscombe
    GL6 7RL Stroud
    Knapp House
    Gloucestershire
    Administrateur
    Far End
    Sheepscombe
    GL6 7RL Stroud
    Knapp House
    Gloucestershire
    EnglandBritishExecutive Director91557750002
    MILLS, Paul Andrew
    Woodcote 8 Hall Orchard
    Bramshall
    ST14 5DF Uttoxeter
    Staffordshire
    Administrateur
    Woodcote 8 Hall Orchard
    Bramshall
    ST14 5DF Uttoxeter
    Staffordshire
    EnglandBritishCompany Secretary34173070002
    NEWBY, William Edward
    c/o Governance Dept, 5th Floor
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Governance Dept, 5th Floor
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    United KingdomBritishBusiness Leader140446620001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Administrateur désigné
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    RICHARDSON, Neville Brian
    Doone Cottage 37 Hough Lane
    SK9 2LH Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    Doone Cottage 37 Hough Lane
    SK9 2LH Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritishGroup Finance Director73311810001
    RUSSELL, Andrew Nicholas
    5th Floor New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Administrateur
    5th Floor New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant91395820001
    TWEEDY, David
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Administrateur
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)BritishManaging Director109457050001
    CS SCF MANAGEMENT LIMITED
    PO BOX 474
    Helvetia Court
    GY1 6AZ St Peter Port Guernsey
    Channel Islands
    Administrateur
    PO BOX 474
    Helvetia Court
    GY1 6AZ St Peter Port Guernsey
    Channel Islands
    83374930001
    PCSL SERVICES NO.2 LIMITED
    Exchange Tower
    2 Harbour Exchange Square
    E14 9FR London
    Administrateur
    Exchange Tower
    2 Harbour Exchange Square
    E14 9FR London
    66769670003

    PLATFORM CONSUMER SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage of shares (as defined)
    Créé le 29 sept. 1999
    Livré le 15 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the facility documents (as defined) and this mortgage
    Brèves mentions
    The entire issued ordinary share capital from time to time and all other securities,rights,moneys and property whatsoever. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Stanley Mortgasge Servicing Limited,as Security Trustee
    Transactions
    • 15 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)

    PLATFORM CONSUMER SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    22 sept. 2016Commencement of winding up
    29 mars 2018Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ian Harvey Dean
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0