GOLDFISH CARD SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | GOLDFISH CARD SERVICES LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03722587 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GOLDFISH CARD SERVICES LIMITED ?
Adresse du siège social | Hil House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GOLDFISH CARD SERVICES LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 nov. 2007 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour GOLDFISH CARD SERVICES LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour GOLDFISH CARD SERVICES LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Résolution d'insolvabilité Resolution INSOLVENCY:liquidators approval of accounts | 1 pages | LIQ MISC RES | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 3 pages | 4.71 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 24 mars 2015 | 5 pages | 4.68 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 24 sept. 2014 | 5 pages | 4.68 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 24 mars 2014 | 5 pages | 4.68 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 24 sept. 2013 | 5 pages | 4.68 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 24 mars 2013 | 5 pages | 4.68 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 24 sept. 2012 | 5 pages | 4.68 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 24 mars 2012 | 5 pages | 4.68 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 24 sept. 2011 | 5 pages | 4.68 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ali Chaudhry en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Dépôt d'insolvabilité Insolvency:FORM4.33 Resignation of liquidator | 1 pages | LIQ MISC | ||||||||||
Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire | 1 pages | 4.40 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 24 mars 2011 | 5 pages | 4.68 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * 1 Churchill Place London E14 5HP* le 22 avr. 2010 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 2 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | 4.70 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
Cessation de la nomination d'un directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Amer Ahmed Sajed le 17 févr. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de GOLDFISH CARD SERVICES LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARCOSEC LIMITED | Secrétaire | 1 Churchill Place E14 5HP London | 49004930002 | |||||||
MONROE, Sheila Ann | Administrateur | 1 Churchill Place E14 5HP London | England | American | Banker | 120794250003 | ||||
SAJED, Amer Ahmed | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 England | American | Banker | 133033540001 | |||||
GLEDHILL, Mary Elizabeth | Secrétaire | Crown Cottage 11 Crown Hill Ropsley NG33 4BH Grantham Lincolnshire | British | 60726470001 | ||||||
MARVIN, Lisa Anne | Secrétaire | 15 Wolfington Road SE27 0JF London | British | 74669600002 | ||||||
MCCAHON, David John | Secrétaire | Graham Road IP1 3QF Ipswich 49 Suffolk | British | 70634290003 | ||||||
MCCAHON, David John | Secrétaire | South House 25 Creffield Road CO3 3JA Colchester Essex | British | 70634290002 | ||||||
ROSENTHAL, Richard Scott | Secrétaire | 19 Heath Drive NW3 7SL London | United States | Company Director | 63113560002 | |||||
WALTER, Kimbra | Secrétaire | 2500 Lake Cook 60015 Riverwoods Il. Usa | British | 71119100001 | ||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
CHAUDHRY, Ali Riaz | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | Pakistani | Banker | 135128530001 | ||||
COANE, John James | Administrateur | 15 Lichfield Road TW9 3JR Kew Surrey | American | Cfo | 77159280001 | |||||
COLEMAN, Nicholas Charles | Administrateur | Ashdown House East Tanyard Lane RH17 7JW Danehill East Sussex | England | British | Accountant | 191831630001 | ||||
DUTT, Ashoke | Administrateur | 1121 Gavin Court 60045 Lake Forest Illinois Usa | Indian | Bank Executive | 70634190003 | |||||
FISHER, Colin Michael | Administrateur | Lovelaces Spinney Gardeners Lane, East Wellow SO51 6AD Romsey Hampshire | United Kingdom | British | Retired Controller Director Ll | 66553680002 | ||||
HILL, John Nathan | Administrateur | 7 Ramsay Garden EH1 2NA Edinburgh | American | Head Of Operations Cbgi | 94917090001 | |||||
HOGG, Charlotte Mary | Administrateur | 16 Victoria Square SW1W 0RA London | United Kingdom | British | Banker | 102522080002 | ||||
HOGG, Charlotte Mary | Administrateur | 16 Victoria Square SW1W 0RA London | United Kingdom | British | Banker | 102522080002 | ||||
LAZELL, Antony Mark | Administrateur | The Hayloft Falla Farm ML11 8LH Carnwath South Lanarkshire | British | Risk Officer | 106440980002 | |||||
MCCAHON, David John | Administrateur | Graham Road IP1 3QF Ipswich 49 Suffolk | England | British | Lawyer | 70634290003 | ||||
MCHUGH, Daniel Anthony | Administrateur | 301 Sovereign Court 29 Wrights Lane W8 5SN London | Us | Controller/Treasurer | 5524560005 | |||||
NELMS, David Warren | Administrateur | 620 S. Broadsmoore Drive Lake Forest 60045 Il Usa | Us Citizen | President & Coo Discover Finan | 123035490001 | |||||
O'HARA, William | Administrateur | 26 Tournament Way Austin 78738 FOREIGN Texas United States Of America | American | Company Director | 64412200002 | |||||
OLLASON, Gail Morven | Administrateur | 64 Monreith Road Newlands G43 2PE Glasgow Lanarkshire | British | Hr Director | 119911690001 | |||||
PRITCHARD, David Peter | Administrateur | 17 Thorney Crescent SW11 3TT London | England | British | Banker | 57244610001 | ||||
RUTHERFORD, Diane | Administrateur | Eaton Place SW1X 8LW London 94a Garden Flat | American | Chief Technology Officer | 119911590002 | |||||
TALWAR, Harit | Administrateur | 620 Leland Court Lake Forest Il 60045 Usa | Indian | Investment Banker | 75095300002 | |||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
GOLDFISH CARD SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Rent deposit deed | Créé le 29 juin 2007 Livré le 05 juil. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed charge the sum of £4,465. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Rent deposit deed | Créé le 29 juin 2007 Livré le 05 juil. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions First fixed charge the sum of £332,948. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A standard security which was presented for registation in scotland on the 6TH july 1999 | Créé le 02 juil. 1999 Livré le 21 juil. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions All and whole that plot or area of ground at orchardton woods cumbernauld in the county of dumbarton t/n-DMB51002.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
GOLDFISH CARD SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0