E.ON RUHRGAS UK HOLDING LIMITED

E.ON RUHRGAS UK HOLDING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéE.ON RUHRGAS UK HOLDING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03722631
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de E.ON RUHRGAS UK HOLDING LIMITED ?

    • (1120) /

    Où se situe E.ON RUHRGAS UK HOLDING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hil House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de E.ON RUHRGAS UK HOLDING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CALEDONIA ENERGY LIMITED07 nov. 200307 nov. 2003
    CONSORT RESOURCES LIMITED14 mai 199914 mai 1999
    BURGINHALL 1094 LIMITED01 mars 199901 mars 1999

    Quels sont les derniers comptes de E.ON RUHRGAS UK HOLDING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour E.ON RUHRGAS UK HOLDING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Résolution d'insolvabilité

    Resolution insolvency:- re. Books
    1 pagesLIQ MISC RES

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 09 juin 2009

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    7 pages4.70

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages190

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    16 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    Qui sont les dirigeants de E.ON RUHRGAS UK HOLDING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BUSS, Judith
    24 Hardstrasse
    D-40629
    Dusseldorf
    Germany
    Administrateur
    24 Hardstrasse
    D-40629
    Dusseldorf
    Germany
    German126797980001
    COLE, Martin
    15 Cuddington Park Close
    SM7 1RF Banstead
    Surrey
    Administrateur
    15 Cuddington Park Close
    SM7 1RF Banstead
    Surrey
    British59419030002
    ASHMORE, Richard John
    14 Willowmead Close
    Ealing
    W5 1PT London
    Secrétaire
    14 Willowmead Close
    Ealing
    W5 1PT London
    British84884080001
    BATE, Christopher Malcolm
    Bryn Y Mor
    LL57 2HG Bangor
    Gwynedd
    Secrétaire
    Bryn Y Mor
    LL57 2HG Bangor
    Gwynedd
    British77942170001
    GROOM, Malcolm David John
    Westlodge
    169 Burwood Road
    KT12 4AT Walton On Thames
    Surrey
    Secrétaire
    Westlodge
    169 Burwood Road
    KT12 4AT Walton On Thames
    Surrey
    British29602720001
    GRAY'S INN SECRETARIES LIMITED
    5 Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Secrétaire désigné
    5 Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900002550001
    GRAYS INN SECRETARIES LIMITED
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Secrétaire
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    81652080001
    LEDINGHAM CHALMERS LLP
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    Secrétaire
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    73896680003
    BELL, Andrew Stewart
    178 Clonmore Street
    SW18 5HB London
    Administrateur
    178 Clonmore Street
    SW18 5HB London
    United KingdomBritish95066820001
    BENKE, Eike, Dr
    Kantorie 89 D-45134
    FOREIGN Essen
    Germany
    Administrateur
    Kantorie 89 D-45134
    FOREIGN Essen
    Germany
    German32474820002
    BLAKEY, Peter
    Halstead Chestnut Walk
    B95 5JN Henley-In-Arden
    West Midlands
    Administrateur
    Halstead Chestnut Walk
    B95 5JN Henley-In-Arden
    West Midlands
    British3754730001
    CARVER, Lesley Jean
    Flat 4 136 Sutherland Avenue
    W9 1HP London
    Administrateur
    Flat 4 136 Sutherland Avenue
    W9 1HP London
    British54021290001
    CARVER, Lesley Jean
    Flat 4 136 Sutherland Avenue
    W9 1HP London
    Administrateur
    Flat 4 136 Sutherland Avenue
    W9 1HP London
    British54021290001
    EARL, Peter Richard Stephen
    Shipton Lodge
    OX7 6DG Shipton-Under-Wychwood
    Oxfordshire
    Administrateur
    Shipton Lodge
    OX7 6DG Shipton-Under-Wychwood
    Oxfordshire
    United KingdomBritish7799770001
    EDGLEY, Steven Neville
    83 Loom Lane
    WD7 8NY Radlett
    Hertfordshire
    Administrateur
    83 Loom Lane
    WD7 8NY Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish85718530001
    FERGUSON, Donald
    6 Cresswell Gardens
    Kensington
    SW5 0BJ London
    Administrateur
    6 Cresswell Gardens
    Kensington
    SW5 0BJ London
    British88767730001
    GROOM, Malcolm David John
    Westlodge
    169 Burwood Road
    KT12 4AT Walton On Thames
    Surrey
    Administrateur
    Westlodge
    169 Burwood Road
    KT12 4AT Walton On Thames
    Surrey
    EnglandBritish29602720001
    HAMMOND, Philip
    Send Barns
    Send Barns Lane, Send
    GU23 7BT Ripley
    Administrateur
    Send Barns
    Send Barns Lane, Send
    GU23 7BT Ripley
    EnglandBritish287139780001
    HAWKINS, Warren
    4225 Milton
    Houston
    Harris Texas
    77005
    Usa
    Administrateur
    4225 Milton
    Houston
    Harris Texas
    77005
    Usa
    American94520330001
    HOGAN, John Anthony
    The Malthouse Heaverham Road
    Kemsing
    TN15 6NE Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    The Malthouse Heaverham Road
    Kemsing
    TN15 6NE Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish94257040001
    HONEYBOURNE, John William Gervase
    614 Regentview Drive
    Houston
    Texas
    77079
    U S A
    Administrateur
    614 Regentview Drive
    Houston
    Texas
    77079
    U S A
    UsaBritish94265940001
    HUNTER, Alexander
    64 Contlaw Road
    Milltimber
    AB13 0EJ Aberdeen
    Administrateur
    64 Contlaw Road
    Milltimber
    AB13 0EJ Aberdeen
    British73259250003
    LEGG, Jonathan Victor Lewis
    188a Sutherland Avenue
    W9 1HR London
    Administrateur
    188a Sutherland Avenue
    W9 1HR London
    United KingdomBritish67082340002
    MACAULAY, William E.
    7 Hill Road
    Greenwich
    06830 Connecticut
    Usa
    Administrateur
    7 Hill Road
    Greenwich
    06830 Connecticut
    Usa
    United StatesAmerican238080500001
    MACDONALD, Jeffrey Saunders
    18114 Langsbury Drive
    Houston
    Texas
    77084
    Usa
    Administrateur
    18114 Langsbury Drive
    Houston
    Texas
    77084
    Usa
    British87467740001
    MARIS, Antony Wayne
    16 Brighton Road
    GU7 1NS Godalming
    Surrey
    Administrateur
    16 Brighton Road
    GU7 1NS Godalming
    Surrey
    EnglandBritish78957850001
    MOYNIHAN, Colin Berkeley, Lord
    Regency Cottage
    The Esplanade, Sandgate
    CT20 3DP Folkestone
    Kent
    Administrateur
    Regency Cottage
    The Esplanade, Sandgate
    CT20 3DP Folkestone
    Kent
    British78913240003
    MURCHISON, John Hardy
    6200 Burgoyne Road
    77057 Houston
    Texas
    Usa
    Administrateur
    6200 Burgoyne Road
    77057 Houston
    Texas
    Usa
    American88904040001
    PRIEN, Nicolo
    Oberkasseler Strasse 64
    Duesseldorf
    40545
    Germany
    Administrateur
    Oberkasseler Strasse 64
    Duesseldorf
    40545
    Germany
    German108803940001
    PRINGLE, Keith James
    The Nelmes
    Munsley
    HR8 2SH Ledbury
    Herefordshire
    Administrateur
    The Nelmes
    Munsley
    HR8 2SH Ledbury
    Herefordshire
    UkUk61942150003
    REICHETSEDER, Peter, Prof Dr
    Tippelstr. 100
    45529
    Hattingen
    Germany
    Administrateur
    Tippelstr. 100
    45529
    Hattingen
    Germany
    Austrian93247640002
    ROTHERMUND, Heinz Charles
    Aufdorfstrasse
    Mannedorf
    146
    Ch 8708
    Switzerland
    Administrateur
    Aufdorfstrasse
    Mannedorf
    146
    Ch 8708
    Switzerland
    Swiss122144690001
    SHAW, Sandra Nan Demby
    21 Harcourt Road
    SL6 0DT Dorney Reach
    Berkshire
    Administrateur
    21 Harcourt Road
    SL6 0DT Dorney Reach
    Berkshire
    EnglandBritish78957930001
    SIVERTSEN, Frank Allan
    Fjellfruebakken
    N-4070 Randaberg
    2
    Norway
    Administrateur
    Fjellfruebakken
    N-4070 Randaberg
    2
    Norway
    Norwegian109251340002
    TAYLOR, Peter
    10 Blackheath Park
    SE3 9RP London
    Administrateur
    10 Blackheath Park
    SE3 9RP London
    EnglandBritish3754740001

    E.ON RUHRGAS UK HOLDING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Second-ranking borrowing base asset security agreement
    Créé le 24 nov. 2004
    Livré le 07 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (the security trustee) as agent and trustee for the undeveloped asset backed finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second-ranking undeveloped asset backed security agreement
    Créé le 24 nov. 2004
    Livré le 07 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (the security trustee) as agent and trustee for the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    First-ranking undeveloped asset backed security agreement
    Créé le 24 nov. 2004
    Livré le 07 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (the security trustee) as agent and trustee for the undeveloped asset backed finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 23 oct. 2003
    Livré le 12 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as consort resources limited to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of an equitable mortgage all shares in any member of the group, by way of a floating charge its interest in all shares stocks debentures bonds or other securities owned by it or held by any nominee on its behalf.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Trustee Fore Itself and the Secured Creditors
    Transactions
    • 12 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 oct. 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 12 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 févr. 2001
    Livré le 13 févr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under each finance document (as defined) to which the company is a party
    Brèves mentions
    Fixed charge all of the assigned assets, all group shares and related rights accruing to the group shares. Floating charge all its undertaking and assets (all terms defined therein).
    Personnes ayant droit
    • Txu Europe Group PLC
    Transactions
    • 13 févr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 févr. 2001
    Livré le 16 févr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under each finance document (as defined) and on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dynergy Marketing and Trading Sarl
    Transactions
    • 16 févr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 07 févr. 2001
    Livré le 15 févr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities of the company to any finance party under each finance document to which the company is a party (and for the avoidance of doubt the term finance document includes all amendments and supplements including supplements providing for further advances)
    Brèves mentions
    1) assignment all of the assigned assets except in the case of any rights under any project documents. 2) the fixed charge over all of the assigned assets to the extent (if any) not effectively assigned under clause 2.1 (assignment) of the security agreement. All group shares held by it and/or any nominee on its behalf and all related rights accruing to the group shares; and all property specified in schedule 1 to the security agreement. 3) floating charge all its undertaking and assets both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Facility Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 15 févr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Subordination agreement
    Créé le 30 juin 2000
    Livré le 11 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future liabilities of the obligor to each finance party, under or in connection with, or on rescission of, the finance documents (the "senior debt")
    Brèves mentions
    The subordination agreement provides that if the chargor receives a payment or distribution in respect of any of the junior debt (other than a permitted payment) from the obligor or any other source. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 févr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Share charge
    Créé le 30 juin 2000
    Livré le 11 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under each finance document (as defined)
    Brèves mentions
    The share charge provides that the chargor as security for the payment of all the secured liabilities and with full title gurantee charges in favour of the agent by way of a first fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 févr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 06 avr. 2000
    Livré le 19 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £294,925 due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Rent deposit £294,925. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hutton Development Limited
    Transactions
    • 19 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    E.ON RUHRGAS UK HOLDING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    28 févr. 2010Dissolved on
    09 juin 2009Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Christopher Richard Frederick Day
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Nicholas James Dargan
    Deloitte & Touche
    Po Box 810, Athene Place
    EC4A 3WA 66 Shoe Lane
    London
    practitioner
    Deloitte & Touche
    Po Box 810, Athene Place
    EC4A 3WA 66 Shoe Lane
    London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0