NPI LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNPI LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03725037
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NPI LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe NPI LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1020 Eskdale Road
    RG41 5TS Winnersh
    Wokingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NPI LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    941ST SHELF TRADING COMPANY LIMITED03 mars 199903 mars 1999

    Quels sont les derniers comptes de NPI LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour NPI LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de 1 Wythall Green Way Wythall Birmingham B47 6WG à 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham RG41 5TS le 16 mai 2018

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    4 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 23 avr. 2018

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Moss le 18 avr. 2018

    2 pagesCH01

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Nomination de Mr Rizwan Sheriff en tant qu'administrateur le 30 sept. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Shamira Mohammed en tant que directeur le 30 sept. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 02 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    7 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Moss le 12 juil. 2016

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Moss le 12 juil. 2016

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 mai 2016

    État du capital au 05 mai 2016

    • Capital: GBP 250,000,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Andrew Moss le 13 juil. 2015

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 mai 2015

    État du capital au 08 mai 2015

    • Capital: GBP 250,000,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    15 pagesAA

    Cessation de la nomination de Michael Merrick en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Shamira Mohammed en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 mai 2014

    État du capital au 08 mai 2014

    • Capital: GBP 250,000,000
    SH01

    Qui sont les dirigeants de NPI LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PEARL GROUP SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Secrétaire
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement3588041
    146249030001
    MOSS, Andrew
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Administrateur
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    EnglandBritish151524430063
    SHERIFF, Rizwan
    Wythall Green Way
    Wythall Green
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    England
    Administrateur
    Wythall Green Way
    Wythall Green
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    England
    EnglandBritish238986770001
    O'BRIEN, Steven John
    10 Ryders
    Langton Green
    TN3 0DX Tunbridge Wells
    Kent
    Secrétaire
    10 Ryders
    Langton Green
    TN3 0DX Tunbridge Wells
    Kent
    British9964050001
    WATSON, Gerald Alistair
    43 Abbotts Grove
    Werrington
    PE4 5BP Peterborough
    Secrétaire
    43 Abbotts Grove
    Werrington
    PE4 5BP Peterborough
    British47729060001
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Secrétaire désigné
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001770001
    BATCHELOR, Paul John
    Flat H
    9 Eaton Square
    SW1W 9DB London
    Administrateur
    Flat H
    9 Eaton Square
    SW1W 9DB London
    Australian64778980003
    BATES, Malcolm Rowland, Sir
    Mulberry Close
    Croft Road
    RG8 9ES Goring-On-Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    Mulberry Close
    Croft Road
    RG8 9ES Goring-On-Thames
    Oxfordshire
    British13829970002
    CORMACK, Ian Donald
    24 Kensington Court Gardens
    Kensington Court Place
    W8 5QF London
    Administrateur
    24 Kensington Court Gardens
    Kensington Court Place
    W8 5QF London
    EnglandBritish114870300001
    COSTAIN, Peter John
    Heronden Smallhythe Road
    TN30 7LN Tenterden
    Kent
    Administrateur
    Heronden Smallhythe Road
    TN30 7LN Tenterden
    Kent
    EnglandBritish45321580001
    CROSS BROWN, Tom
    Shipton Old Farm
    MK18 3JL Winslow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Shipton Old Farm
    MK18 3JL Winslow
    Buckinghamshire
    United KingdomEnglish154509390001
    CUSINS, John Robert
    High Gables
    Holly Lane
    AL5 5DY Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    High Gables
    Holly Lane
    AL5 5DY Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish107782060002
    DALE, Manjit
    84 Highgate
    West Hill
    N6 6LU London
    Administrateur
    84 Highgate
    West Hill
    N6 6LU London
    EnglandBritish69966070002
    DAVIDSON, Anthony Beverley
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Administrateur
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    United KingdomBritish61933730002
    DRABBLE, John Alexander
    7 Altenburg Gardens
    Battersea
    SW11 1JH London
    Administrateur
    7 Altenburg Gardens
    Battersea
    SW11 1JH London
    British Australian88349990002
    DUNN, Craig William
    52 Douglas Street
    2076 St Ives
    New South Wales
    Australia
    Administrateur
    52 Douglas Street
    2076 St Ives
    New South Wales
    Australia
    AustraliaBritish198499280001
    EDMANS, Laurence Michael
    Allens Oast
    Old Road
    TN12 5ER East Peckham
    Kent
    Administrateur
    Allens Oast
    Old Road
    TN12 5ER East Peckham
    Kent
    EnglandBritish145578560001
    EVANS, Jonathan Peter
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Administrateur
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    United KingdomBritish70566830001
    EVANS, Jonathan Peter
    The Red House 122 Heol Isaf
    Radyr
    CF15 8EA Cardiff
    South Glamorgan
    Administrateur
    The Red House 122 Heol Isaf
    Radyr
    CF15 8EA Cardiff
    South Glamorgan
    United KingdomBritish70566830001
    FERGUSON, Duncan George Robin
    Clive Wood Farm
    Clive
    SY4 5PR Shrewsbury
    Shropshire
    Administrateur
    Clive Wood Farm
    Clive
    SY4 5PR Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritish144264940001
    FRASER, Thomas Aird
    40 Elmbourne Road
    Tooting
    SW17 8JR London
    Administrateur
    40 Elmbourne Road
    Tooting
    SW17 8JR London
    United KingdomAustralian74112910001
    GORMAN, William Richard
    25 Towerside
    150 Wapping High Street
    E1W 3PH Wapping
    London
    Administrateur
    25 Towerside
    150 Wapping High Street
    E1W 3PH Wapping
    London
    Australian59757440001
    GUPTA, Ashok Kumar
    26 Parsons Green
    SW6 4UH London
    Administrateur
    26 Parsons Green
    SW6 4UH London
    EnglandBritish68708650004
    HAWKES, Edward Jonathan Cameron
    10 Hillgate Street
    W8 7SR London
    Administrateur
    10 Hillgate Street
    W8 7SR London
    United KingdomBritish93239900003
    HOTSON, Anthony Charles
    Church Street
    Wadenhoe
    PE8 5ST Peterborough
    Aubrey House
    Cambridgeshire
    Uk
    Administrateur
    Church Street
    Wadenhoe
    PE8 5ST Peterborough
    Aubrey House
    Cambridgeshire
    Uk
    British30112390003
    HUNTLEY, David Charles
    Burwood Park Road
    Hersham
    KT12 5LJ Walton On Thames
    7
    Surrey
    Administrateur
    Burwood Park Road
    Hersham
    KT12 5LJ Walton On Thames
    7
    Surrey
    United KingdomBritish133958530001
    LAUGHLIN, Ian William
    32 Melvinshaw
    KT22 8SX Leatherhead
    Administrateur
    32 Melvinshaw
    KT22 8SX Leatherhead
    Australian86985820003
    LEVER, Colin David
    38 Oakleigh Park South
    N20 9JN London
    Administrateur
    38 Oakleigh Park South
    N20 9JN London
    British14678320001
    LUSCOMBE, Kerr
    Melbourne Court, Braidpark Drive
    Giffnock
    G46 6LA Glasgow
    3e
    United Kingdom
    Administrateur
    Melbourne Court, Braidpark Drive
    Giffnock
    G46 6LA Glasgow
    3e
    United Kingdom
    ScotlandBritish83541890001
    LYONS, Alastair David
    Tolhurst Barn
    Birchetts Green Lane
    TN5 7LJ Ticehurst
    East Sussex
    Administrateur
    Tolhurst Barn
    Birchetts Green Lane
    TN5 7LJ Ticehurst
    East Sussex
    British75697200001
    MAIDENS, Ian Graham
    TN5
    Administrateur
    TN5
    United KingdomBritish103576480002
    MCGLASHAM, Christopher
    7 Shepperton Close
    Great Billing
    NN3 9NT Northampton
    Administrateur
    7 Shepperton Close
    Great Billing
    NN3 9NT Northampton
    EnglandBritish45546750001
    MEEHAN, Brendan Joseph
    24 Kirby Close
    NN4 6AB Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    24 Kirby Close
    NN4 6AB Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish98270380001
    MERRICK, Michael John
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Administrateur
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    EnglandBritish74114060001
    MOHAMMED, Shamira
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Administrateur
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    United KingdomBritish253534040001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NPI LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    West Midlands
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    West Midlands
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement1016269
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    NPI LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge
    Créé le 14 janv. 2008
    Livré le 17 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right, title and interest in or in respect of the property meaning cash and securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Opal Reassurance Limited
    Transactions
    • 17 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 25 mai 2007
    Livré le 13 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge all right title and interest in respect of the property being cash and securities all other property and all rights cash and the collateral accounts. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Opal Reassurance Limited
    Transactions
    • 13 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 30 sept. 1999
    Livré le 09 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    In favour of the chargee all money and liabilities due or to become due from the company to the purchaser under the reversion sale programme agreement and under the debenture and all money and liabilities due or to become due from the company to the security trustee under the mortality policy agreement in whatsoever manner
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all monies from time to time standing to the credit of the specific house price account. By way of first floating charge the charged property to the extent not effectively charged by way of first fixed charge or assigned by way of security.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abbey National Treasury Services PLC(As Security Trustee for the Purchaser)
    Transactions
    • 09 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)

    NPI LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    23 avr. 2018Commencement of winding up
    08 avr. 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0