HARMONY PUB ESTATE B LIMITED

HARMONY PUB ESTATE B LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHARMONY PUB ESTATE B LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03727569
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HARMONY PUB ESTATE B LIMITED ?

    • Vente au détail de boissons en magasin spécialisé (47250) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Débits de boissons et bars (56302) / Hébergement et restauration
    • Location et exploitation de biens immobiliers des sociétés de logement (68201) / Activités immobilières

    Où se situe HARMONY PUB ESTATE B LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HARMONY PUB ESTATE B LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HERITAGE PUB ESTATE B LIMITED15 avr. 200315 avr. 2003
    ATLASWAY 2 LIMITED26 mars 199926 mars 1999
    ROBINWELL LTD05 mars 199905 mars 1999

    Quels sont les derniers comptes de HARMONY PUB ESTATE B LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au01 juin 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour HARMONY PUB ESTATE B LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour HARMONY PUB ESTATE B LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    9 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 mai 2015

    8 pages4.68

    Cessation de la nomination de Kevin Georgel en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Clifford en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Glenn Pearson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de * 150 Aldersgate Street London EC1A 4EJ* le 05 juin 2014

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolution d'insolvabilité

    Resolution insolvency:re liquidator business & remuneration
    1 pagesLIQ MISC RES

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Satisfaction de la charge 037275690024 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 037275690025 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 avr. 2014

    État du capital au 28 avr. 2014

    • Capital: GBP 1,500,100
    SH01

    Cessation de la nomination de Jonathan Paveley en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 01 juin 2013

    16 pagesAA

    Statuts

    10 pagesMEM/ARTS

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Inscription de la charge 037275690025

    54 pagesMR01

    Inscription de la charge 037275690024

    86 pagesMR01

    Comptes annuels établis au 26 mai 2012

    19 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    legacy

    6 pagesMG02

    legacy

    4 pagesMG02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Glenn Pearson le 28 sept. 2012

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de HARMONY PUB ESTATE B LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secrétaire
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    INGHAM, Michael Harry Peter
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    Secrétaire
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    British2739650001
    NIEDERMAN, Rivka
    Jessam Avenue
    E5 9DU London
    30
    Secrétaire
    Jessam Avenue
    E5 9DU London
    30
    British113503670001
    SCHREIBER, David
    143 Upper Clapton Road
    E5 9DB London
    Secrétaire
    143 Upper Clapton Road
    E5 9DB London
    BritishDirector75594970001
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Secrétaire désigné
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900014000001
    BROWN, Aaron Maxwell
    11 Carlyle Close
    N2 0QU London
    Administrateur
    11 Carlyle Close
    N2 0QU London
    AmericanDirector98928830001
    CLIFFORD, Andrew Francis James
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    Administrateur
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    EnglandBritishProperty Director119327230001
    D'ARCY, Lynne
    5 Winwick Park Avenue
    WA2 8XB Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    5 Winwick Park Avenue
    WA2 8XB Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director106840540001
    FINNEY, Francis John
    Summers End
    8 Weaverlake
    DE13 8AD Yoxall
    Staffordshire
    Administrateur
    Summers End
    8 Weaverlake
    DE13 8AD Yoxall
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector89286280002
    GEORGEL, Kevin Roger
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 The Steam Mill Business Centre
    Administrateur
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 The Steam Mill Business Centre
    United KingdomBritishManaging Director153480970001
    GROSS, Milton
    86 Filey Avenue
    N16 6JJ London
    Administrateur
    86 Filey Avenue
    N16 6JJ London
    UsaDirector2986750004
    HARRISON, David John
    Main Street
    Winster
    DE4 2DH Matlock
    The Archway
    Derbyshire
    Administrateur
    Main Street
    Winster
    DE4 2DH Matlock
    The Archway
    Derbyshire
    United KingdomBritishChartered Accountant62175190001
    LANDESBERG, Alan
    Allingham Court
    44 The Bishops Avenue Hampstead
    N2 OBA London
    Flat 3,
    Administrateur
    Allingham Court
    44 The Bishops Avenue Hampstead
    N2 OBA London
    Flat 3,
    EnglandBritishCompany Director142883260001
    LANDESBERG, Gary Mitchell
    122 Wigmore Street
    W1U 3RX London
    Administrateur
    122 Wigmore Street
    W1U 3RX London
    United KingdomBritishCompany Director54137480002
    O'NEILL, John
    Westbourne
    Gorse Bank Lane, Baslow
    DE45 1SG Bakewell
    Derbyshire
    Administrateur
    Westbourne
    Gorse Bank Lane, Baslow
    DE45 1SG Bakewell
    Derbyshire
    BritishDirector89254470001
    PAVELEY, Jonathan David, Dr
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    Administrateur
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    United KingdomBritishCompany Director100582600002
    PEARSON, Glenn
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    Administrateur
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant Cfo123243570001
    PERCY, Andrew Graeme
    5 Carlton Avenue
    SK9 4EP Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    5 Carlton Avenue
    SK9 4EP Wilmslow
    Cheshire
    BritishCompany Director53017070002
    ROSENBERG, David
    Green Verges
    Priory Drive
    HA7 3HL Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    Green Verges
    Priory Drive
    HA7 3HL Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Director2541410004
    ROSENBERG, Elliot Simon
    Brooklands 33 Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    Brooklands 33 Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishDirector2541420006
    SCHREIBER, David
    143 Upper Clapton Road
    E5 9DB London
    Administrateur
    143 Upper Clapton Road
    E5 9DB London
    EnglandBritishDirector75594970001
    SCHREIBER, Jacob
    10 Gilda Crescent
    N16 6JP London
    Administrateur
    10 Gilda Crescent
    N16 6JP London
    United KingdomBritishDirector67574090001
    SMALLEY, Timothy John
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    Administrateur
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    United KingdomBritishDirector102593650002
    WILSON, Hugh Wingate
    The Home Farm
    Fenton Road Stubton
    NG23 5DB Newark
    Nottinghamshire
    Administrateur
    The Home Farm
    Fenton Road Stubton
    NG23 5DB Newark
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director89126810001
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Administrateur désigné
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900013990001

    HARMONY PUB ESTATE B LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 27 juin 2013
    Livré le 12 juil. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Admiral Taverns Bidco Limited
    Transactions
    • 12 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 27 juin 2013
    Livré le 09 juil. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited (As Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 09 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 17 nov. 2009
    Livré le 02 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H the atlas bawtry road brinsworth t/no SYK326894, f/h the bell & crown bell hill warminster t/no WT139116, f/h the black lion broad lane bramley t/no WYK526202, for details of further properties charged please refer to the form MG01, fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC in Its Capacity as Security Trustee
    Transactions
    • 02 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 11 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 11 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 11 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 11 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 11 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 11 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 11 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 11 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 15 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 15 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 15 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 28 mars 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 17 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 17 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 17 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 17 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 17 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 17 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 17 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 27 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 17 nov. 2009
    Livré le 02 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage the original property: (for details of original property please refer to document image) and all estates or interests in f/h, l/h or commonhold property and which is owned by the chargor as at the date of the debenture, and in each case, all premises and fixtures on such property for the time being. By way of fixed charge all other estates or interests in f/h, l/h or commonhold property: the proceeds of sale of its secured property and all licences to enter on or use any secured property see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Admiral Taverns Bidco Limited
    Transactions
    • 02 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 11 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 28 mars 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 17 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 17 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 17 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 17 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 17 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 17 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 17 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 27 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 30 janv. 2009
    Livré le 07 févr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 24 juil. 2007
    Livré le 04 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 04 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 oct. 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 02 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 24 juil. 2007
    Livré le 04 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H snooty fox brunswick street wakefield t/NWYK507262 f/h ravensthorpe hotel 652 huddersfield road ravensthorpe t/n WYK566234 f/h davy lamp lausdale road rotherham t/n SYK329171 for further details of the properties charged please refer to form 395 any moneys received or to be received. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 04 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 oct. 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 02 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 24 juil. 2007
    Livré le 02 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery for details of properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 oct. 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 02 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 09 févr. 2006
    Livré le 22 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First legal charge over pegasus greystok. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 22 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 08 août 2005
    Livré le 13 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Acorn lindhurst road athersley barnsley s yorks t/n SYK343804. Allan fold burnley road halifax w yorks t/n's WYK297781 WYK358368 WYK342882. Atlas bawtry road brinsworth rotherham s yorks t/n SYK326894. For further details of property charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 13 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 août 2005
    Livré le 13 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 13 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 avr. 2004
    Livré le 08 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a the new inn public house, thrumpton lane, nottinghamshire t/n NT294494. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 févr. 2004
    Livré le 28 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property being the builder arms moor street burton upon trent t/n SF365516, the gough arms public house upper gough street birmingham t/n WM216717, the duke of sussex 77 friary road camberwell southark london t/n 96466 for further details of the properties charged please refer to the form 395. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 avr. 2003
    Livré le 19 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 avr. 2003
    Livré le 19 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H land being the acorn lindhurst road athersley north S71 3DG t/n SYK343804, f/h land being "the second best" burnley road kings cross halifax and f/h land on the south west of warley road kings cross halifax t/n's WYK297781 & WYK358368, for details of further properties charged please refer to the form 395. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture between the company and european loan conduit no 2 b v (the security trustee) (supplemental to a debenture dated 16 june 1999)
    Créé le 28 nov. 2000
    Livré le 05 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under each finance document
    Brèves mentions
    Burlington vaults 57 oldham road ashton-under-lyne t/n GM58918 and all rental income, barrelage income and gaming machine income.
    Personnes ayant droit
    • European Loan Conduit No. 2 Bv(As Agent and Trustee for the Secured Parties ("the Security Trustee"))
    Transactions
    • 05 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture between the company and european loan conduct no.2 Bv ("the security trustee"), as defined
    Créé le 31 oct. 2000
    Livré le 08 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under each finance document (as defined)
    Brèves mentions
    The half moon inn 57-59 (odd) heaton street gainsborough t/n LL92349. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Security Trustee, as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 08 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture
    Créé le 31 août 2000
    Livré le 06 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    In favour of the chargee all obligations and liabilities whatsoever of the company to morgan stanley mortgage capital inc (now morgan stanley dean witter mortgage capital inc) and any other person designated as a secured party and their respective successors and assigns under each finance document (as defined in the loan agreement dated 16 june 1999)
    Brèves mentions
    The acorn public house lindhurst road athersley north barnsley - SYK343804; the highlander public house heywood - GM687587. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • European Loan Conduit No.2 Bv (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 06 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture between the company and european loan conduct no.2 Bv ("the security trustee"), as defined
    Créé le 16 août 2000
    Livré le 24 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under each finance document (as defined)
    Brèves mentions
    The coach and horses public house,doncaster rd,ardsley,south yorkshire; SYK376163; all rental income,etc. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Security Trustee, as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 24 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture between the company and european loan conduct no.2 Bv ("the security trustee"), as defined
    Créé le 16 août 2000
    Livré le 24 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under each finance document (as defined)
    Brèves mentions
    The prince of wales public house,crafton street west,leicester; LT248362; all rights in respect of rental income,etc. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Security Trustee, as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 24 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture between the company and european loan conduct no.2 Bv ("the security trustee"), as defined
    Créé le 16 août 2000
    Livré le 24 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under each finance document (as defined)
    Brèves mentions
    Corporation hotel,wharncliffe rd,loughborough,charnwood; t/no LT242190; all rights in respect of rental income,the barrelage income and the gaming machine income. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Security Trustee, as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 24 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture between the company and european loan conduct no.2 Bv ("the security trustee"), as defined
    Créé le 16 août 2000
    Livré le 24 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under each finance document (as defined)
    Brèves mentions
    The greyhound,73 cemetery rd,danesmoor,derbyshire; t/no DY231685; all rights in respect of rental income,etc. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Security Trustee, as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 24 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture between the company and european loan conduit no 2 b v (the security trustee)
    Créé le 11 août 2000
    Livré le 14 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities of the company to morgan stanley mortgage capital inc (now morgan stanley dean witter mortgage capital inc) and any other person designated as a secured party and their respective successors and assigns under each finance document (as defined)
    Brèves mentions
    Property k/a the double six public house (formerly k/a the flying childers whitmore way basildon - EX562924 and all rights under the sale and purchase agreement dated 8TH march 1999 (as defined) the rental income the barrelage income and the gaming machine income. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • European Loan Conduit No 2 B V
    Transactions
    • 14 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture
    Créé le 11 juil. 2000
    Livré le 12 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to all or any of the seucred parties from time to time under each finance document (as defined)
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage, land lying to the south west of overend street west bromwich (known as ye old wine shoppe) title numbers WM590136 and SF56354, the dale inn poulton road seacombe title MS11630, the firbank, firbank road wythenshawe title number LA144979 for further details see ch microfiche.
    Personnes ayant droit
    • European Loan Conduit No. 2 B.V.
    Transactions
    • 12 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 juin 1999
    Livré le 22 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to all or any of the secured parties from time to time under each finance document (as defined)
    Brèves mentions
    10496 duke of cornwall brixton t/n SGL18607; 10501 earl spencer roehampton t/n SGL18614; 11168 firbank manchester t/n LA144979: 11184 griffin cheetham hill t/n GM616589 (for details of furhter properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Stanley Mortgage Capital Inc.(As Agent and Security Trustee for the Secured Parties)
    Transactions
    • 22 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    HARMONY PUB ESTATE B LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    19 mai 2014Commencement of winding up
    15 juin 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Derek Hyslop
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    practitioner
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Colin Peter Dempster
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    practitioner
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0