IGROUP3 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéIGROUP3 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03730890
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de IGROUP3 LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe IGROUP3 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de IGROUP3 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    OCWEN 3 LIMITED08 mars 199908 mars 1999

    Quels sont les derniers comptes de IGROUP3 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 nov. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour IGROUP3 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pagesLIQ13
    A72WY8SJ

    Cessation de la nomination de Kalpna Shah en tant que secrétaire le 31 janv. 2018

    2 pagesTM02
    A6ZF7HDN

    Changement d'adresse du siège social de PO Box 2497 Building 4 Hatters Lane Watford WD18 1YY United Kingdom à 30 Finsbury Square London EC2P 2YU le 01 déc. 2017

    2 pagesAD01
    A6J5JBEJ

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600
    A6J5JBEB

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 06 nov. 2017

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01
    A6J5JBE3

    Cessation de la nomination de Richard William Bird en tant que directeur le 29 sept. 2017

    1 pagesTM01
    X6G9FMEG

    Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2016

    7 pagesAA
    A64TYTPN

    Déclaration de confirmation établie le 08 mars 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01
    X62930M7

    Cessation de la nomination de Laurence Anne Renee Perrin en tant que directeur le 30 déc. 2016

    1 pagesTM01
    X5XSY95N

    Nomination de Miss Samantha Jones en tant qu'administrateur le 10 oct. 2016

    2 pagesAP01
    X5HX3W5L

    Cessation de la nomination de Bernardus Petrus Maria Van Bunnik en tant que directeur le 01 oct. 2016

    1 pagesTM01
    X5HK56DL

    Changement d'adresse du siège social de Building 4 Hatters Lane Croxley Green Business Park Watford Hertfordshire WD18 8YF à PO Box 2497 Building 4 Hatters Lane Watford WD18 1YY le 23 août 2016

    1 pagesAD01
    X5DZL93C

    Cessation de la nomination de Manuel Uria-Fernandez en tant que directeur le 14 juin 2016

    1 pagesTM01
    X59P1NC4

    Nomination de Mr Richard William Bird en tant qu'administrateur le 14 juin 2016

    2 pagesAP01
    X59P1NK3

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 mars 2016

    État du capital au 14 mars 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01
    X52RZ0U0

    Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2015

    6 pagesAA
    A523CLZT

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Manuel Uria-Fernandez le 17 déc. 2015

    2 pagesCH01
    X4MHHK7L

    Cessation de la nomination de Steven Mark Pickering en tant que directeur le 11 sept. 2015

    1 pagesTM01
    X4G8C8ZN

    Nomination de Mrs Kalpna Shah en tant que secrétaire le 10 juil. 2015

    2 pagesAP03
    X4BOLGCY

    Cessation de la nomination de Fn Secretary Limited en tant que secrétaire le 10 juil. 2015

    1 pagesTM02
    X4BOJ9C3

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 mars 2015

    État du capital au 27 mars 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01
    X442X2LV

    Nomination de Mrs Laurence Anne Renee Perrin en tant qu'administrateur le 16 févr. 2015

    2 pagesAP01
    X424FE5E

    Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2014

    7 pagesAA
    A40IPYKB

    Qui sont les dirigeants de IGROUP3 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JONES, Samantha
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Administrateur
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    United KingdomBritishDirector216074420001
    SHAH, Kalpna
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Secrétaire
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    199403800001
    SHAH, Kalpna
    18 Vicarage Road
    WD18 0EH Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    18 Vicarage Road
    WD18 0EH Watford
    Hertfordshire
    British80753870001
    FN SECRETARY LIMITED
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    88740300002
    RUTLAND SECRETARIES LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Secrétaire
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    38851450001
    AINSWORTH, Keith
    76 Howes Lane
    Finham
    CV3 6PJ Coventry
    Warwickshire
    Administrateur
    76 Howes Lane
    Finham
    CV3 6PJ Coventry
    Warwickshire
    United KingdomBritishSolicitor46161840001
    BELLORA, Michael Richard
    Russet House
    1a Latchmoor Avenue
    SL9 8LL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Russet House
    1a Latchmoor Avenue
    SL9 8LL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    AmericanChief Financial Officer98453650001
    BERRY, Duncan Gee
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    EnglandBritishChief Executive Officer107695600022
    BIRD, Richard William
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    Administrateur
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant209298590001
    BOAKES, Jeremy Edward
    41 Sherrards Park Road
    AL8 7LD Welwyn Garden City
    Herts
    Administrateur
    41 Sherrards Park Road
    AL8 7LD Welwyn Garden City
    Herts
    BritishSolicitor106122240001
    BRENNAN, Peter
    10 Ardross Avenue
    HA6 3DS Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    10 Ardross Avenue
    HA6 3DS Northwood
    Middlesex
    BritishOperations Director84912240001
    CRICHTON, Susan Elizabeth
    The Pheasantries
    Ley Hill
    HP5 3QR Chesham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Pheasantries
    Ley Hill
    HP5 3QR Chesham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishSolicitor69358970001
    DE RIDDER, Kimon Celicourt Macris, Dr
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor131081660001
    DEANE JOHNS, Simon Joshua
    61 Stanlake Road
    W12 7HG London
    Administrateur
    61 Stanlake Road
    W12 7HG London
    AustralianLawyer80748330001
    DLUTOWSKI, Joseph Arthur
    13127 Silver Fox Lane
    Palm Beach Gardens
    Palm Beach County 33418
    United States Of America
    Administrateur
    13127 Silver Fox Lane
    Palm Beach Gardens
    Palm Beach County 33418
    United States Of America
    AmericanDirector66506120001
    ERBEY, William Charles
    110 Sunset Avenue Apartment 2b
    3947 Palm Beach
    Florida 33480-3947
    United Statesof America
    Administrateur
    110 Sunset Avenue Apartment 2b
    3947 Palm Beach
    Florida 33480-3947
    United Statesof America
    AmericanDirector58072470001
    EVANS, Kellie Victoria
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director167417000001
    FERGUSON, Ian George
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Operating Officer133318850001
    FLYNN, William John
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    BritishLegal & Compliance Director99330320002
    GARDEN, Robert James
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director152764360001
    GUNNIGLE, Clodagh
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIrishChief Risk Officer138244630002
    HARRIS, Jeffrey
    9 Northaw Place
    Coopers Lane
    EN6 4NQ Northaw
    Hertfordshire
    Administrateur
    9 Northaw Place
    Coopers Lane
    EN6 4NQ Northaw
    Hertfordshire
    AmericanRisk Director98233530002
    HARVEY, David
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishSales & Marketing Director97086950001
    HEESE, Bruno
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    BritishSales Director115371680001
    HUNKIN, Ricky David
    2 Hockeridge View
    Oakwood
    HP4 3NB Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 Hockeridge View
    Oakwood
    HP4 3NB Berkhamsted
    Hertfordshire
    BritishChief Risk Officer115390900001
    JOHAR, Mandeep Singh
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIndianChief Financial Officer127046380002
    JOHNSON, Alec David
    12 The Witherings, Emerson Park
    RM11 2RA Hornchurch
    Essex
    Administrateur
    12 The Witherings, Emerson Park
    RM11 2RA Hornchurch
    Essex
    United KingdomBritishManagement Consultant103446140001
    KAGAN, Jeffrey Allan
    14 Norrice Lea
    N2 0RE London
    Administrateur
    14 Norrice Lea
    N2 0RE London
    AustralianChartered Accountant78535300001
    MILLWARD, Keith Roger
    Le Marque Manor Close
    Penn
    HP10 8HZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Le Marque Manor Close
    Penn
    HP10 8HZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Accountant80388420001
    PARROTT, Marc Richard
    30 Robin Hood Road
    CM15 9EN Brentwood
    Essex
    Administrateur
    30 Robin Hood Road
    CM15 9EN Brentwood
    Essex
    BritishUnderwriting Consultant30126180001
    PERRIN, Laurence Anne Renee
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    Administrateur
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    United KingdomFrenchCompany Director183220720001
    PICKERING, Steven Mark
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director164833430002
    PUNCH, Andrew Robert
    Pepys Way
    6 Ford Road
    GU24 9EJ Bisley
    Surrey
    Administrateur
    Pepys Way
    6 Ford Road
    GU24 9EJ Bisley
    Surrey
    United KingdomBritishChief Operating Officer147703850001
    SANDERS, Colin George
    Burleigh Grange
    Nightingales Lane
    HP8 4SR Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Burleigh Grange
    Nightingales Lane
    HP8 4SR Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    BritishDirector81421480002
    SHAVE, Colin John Varnell
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandUsa And BritishDirector90360350002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur IGROUP3 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497 Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497 Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement3770776
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    IGROUP3 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of charge
    Créé le 03 nov. 2000
    Livré le 21 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The aggregate of all indebtedness liabilities and obligations due or to become due or to become due from the company to the chargee or to the secured creditors (as defined) on any account whatsoever pursuant to the facility documents (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited(The "Security Trustee")
    Transactions
    • 21 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignation in security (incorporating intimation thereof)
    Créé le 16 août 2000
    Livré le 29 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The payment and discharge of the secured obligations due or to become due from the company to the chargee in accordance with clause 2 of the deed of charge
    Brèves mentions
    The whole right title and interest present and future of the company in and to the beneficial interest in the scottish mortgage loans and the collateral security pertaining thereto please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited(In It's Capacity as Security Trustee in Terms of the Deed of Charge)
    Transactions
    • 29 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignation in security by the chargor and ocwen limited
    Créé le 19 juil. 2000
    Livré le 25 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The payment and discharge of the secured obligations in accordance with the terms of clause 2 of the deed of charge dated 22 september 1999 (as defined)
    Brèves mentions
    All right,title and interest in the scottish mortgage loans for £10,000.00 dated 14/7/00,account no.4003140 In favour of mr/mrs S.black and the collateral security (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited,as Security Trustee in Terms of the Deed of Charge
    Transactions
    • 25 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignation in security (incorporating intimation thereof) by the chargor and ocwen
    Créé le 20 juin 2000
    Livré le 22 juin 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The payment and discharge of the secured obligations (as defined) pursuant to the facility documents (as defined) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The whole right,title and interest in and to the beneficial interest in the scottish mortgage loans and the collateral security thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited, as Security Trustee in Terms of the Deed of Charge(The "Security Trustee")
    Transactions
    • 22 juin 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed of charge to a deed of charge dated 22 september 1999
    Créé le 02 juin 2000
    Livré le 13 juin 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All right title and interest in the new origination and sale agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited (As Security Trustee)
    Transactions
    • 13 juin 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignation in security (incorporating intimation thereof) by the chargor and ocwen limited
    Créé le 24 mai 2000
    Livré le 26 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The payment and discharge of the secured obligations (as defined) pursuant to the facility documents (as defined) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The whole right,title and interest in and to the beneficial interest in the scottish mortgage loans and the collateral security thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited,as Security Trustee in Terms of the Deed of Charge
    Transactions
    • 26 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignation in security (incorporating intimation thereof) by the chargor and ocwen limited
    Créé le 21 avr. 2000
    Livré le 22 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility documents (as defined) and in accordance with the terms of clause 2 of the deed of charge
    Brèves mentions
    All right,title and interest in the scottish mortgage loans and the collateral security thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited,as Security Trustee in Terms of the Deed of Charge
    Transactions
    • 22 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 22 sept. 1999
    Livré le 02 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The aggregate of all indebtedness liabilities and obligations due or to become due or to become due from the company to the chargee or to the secured creditors (as defined) on any account whatsoever pursuant to the facility documents (as defined)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited (As Security Trustee)
    Transactions
    • 02 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mars 2000Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 03 mars 2000Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 16 juin 2000Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 30 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    IGROUP3 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    06 nov. 2017Commencement of winding up
    13 juil. 2018Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0