CHASE DESIGN GROUP LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCHASE DESIGN GROUP LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03739716
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CHASE DESIGN GROUP LTD ?

    • Activités d'architecture (71111) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CHASE DESIGN GROUP LTD ?

    Adresse du siège social
    19-20 Vine Street
    WR11 4RL Evesham
    Worcestershire
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CHASE DESIGN GROUP LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    C M FRAME LIMITED23 avr. 199923 avr. 1999
    INGLEBY (1178) LIMITED24 mars 199924 mars 1999

    Quels sont les derniers comptes de CHASE DESIGN GROUP LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour CHASE DESIGN GROUP LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 24 mars 2023 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2021

    1 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 mars 2022 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2020

    1 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 mars 2021 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2019

    1 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 mars 2020 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 2 the Courtyard Timothys Bridge Road Stratford Enterprise Park Stratford-upon-Avon Warwickshire CV37 9NP à 19-20 Vine Street Evesham Worcestershire WR11 4RL le 10 oct. 2019

    1 pagesAD01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2018

    1 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 mars 2019 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2017

    1 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 mars 2018 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Julian Ronald Meredith en tant que directeur le 26 juil. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Gail Ackrill en tant qu'administrateur le 26 juil. 2017

    2 pagesAP01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2016

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 mars 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2015

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 mars 2016

    État du capital au 24 mars 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cessation de la nomination de Timothy Guy Haslam en tant que directeur le 31 déc. 2015

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 mars 2015

    État du capital au 27 mars 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2013

    7 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CHASE DESIGN GROUP LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ACKRILL, Gail
    Vine Street
    WR11 4RL Evesham
    19-20
    Worcestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Vine Street
    WR11 4RL Evesham
    19-20
    Worcestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector215880670001
    ALLKINS, Stephen Philip
    Badgers House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Secrétaire
    Badgers House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    BritishFinance Director56899810002
    MILLER, Jane
    4 Poplar Rise
    Wappenham
    NN12 8RR Towcester
    Northamptonshire
    Secrétaire
    4 Poplar Rise
    Wappenham
    NN12 8RR Towcester
    Northamptonshire
    BritishDirector89678850001
    INGLEBY NOMINEES LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    Secrétaire désigné
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007860001
    ACKRILL, Roderick Mark
    Cedar Lawn
    Packwood Lane Lapworth
    B94 6AU Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Cedar Lawn
    Packwood Lane Lapworth
    B94 6AU Solihull
    West Midlands
    BritishDirector17633980002
    ALLKINS, Stephen Philip
    Badgers House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Administrateur
    Badgers House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    EnglandBritishFinance Director56899810002
    GRIFFITHS, Paul Malcolm
    46 Croftwood Road
    Wollescote
    DY9 7EY Stourbridge
    West Midlands
    Administrateur
    46 Croftwood Road
    Wollescote
    DY9 7EY Stourbridge
    West Midlands
    BritishDirector95325090001
    HASLAM, Timothy Guy
    The Courtyard Timothys Bridge Road
    Stratford Enterprise Park
    CV37 9NP Stratford-Upon-Avon
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    Administrateur
    The Courtyard Timothys Bridge Road
    Stratford Enterprise Park
    CV37 9NP Stratford-Upon-Avon
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor54650230002
    MEREDITH, Julian Ronald
    The Courtyard Timothys Bridge Road
    Stratford Enterprise Park
    CV37 9NP Stratford-Upon-Avon
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    Administrateur
    The Courtyard Timothys Bridge Road
    Stratford Enterprise Park
    CV37 9NP Stratford-Upon-Avon
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector108679210001
    MILLER, Jane
    4 Poplar Rise
    Wappenham
    NN12 8RR Towcester
    Northamptonshire
    Administrateur
    4 Poplar Rise
    Wappenham
    NN12 8RR Towcester
    Northamptonshire
    BritishDirector89678850001
    INGLEBY HOLDINGS LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    Administrateur désigné
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007850001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CHASE DESIGN GROUP LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mrs Gail Ackrill
    Vine Street
    WR11 4RL Evesham
    19-20
    Worcestershire
    United Kingdom
    30 juin 2016
    Vine Street
    WR11 4RL Evesham
    19-20
    Worcestershire
    United Kingdom
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    CHASE DESIGN GROUP LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 20 avr. 2001
    Livré le 20 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 20 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment of the benefit of a guarantee
    Créé le 08 févr. 2000
    Livré le 18 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All rights benefits and interests of the company both present and future under the guarantee as from time to time varied or extended and all other rights or remedies accorded to it all debts and claims present and future in relation to land at conwy road llandudno conwy.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of the benefit of an agreement
    Créé le 08 févr. 2000
    Livré le 18 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All rights benefits and interests of the company both present and future under the agreement.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of the benefit of an agreement
    Créé le 08 févr. 2000
    Livré le 18 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All rights benefits and interests under the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of the benefit of an agreement
    Créé le 08 févr. 2000
    Livré le 18 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All rights benefits and interests of the company both present and future under the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of the benefit of an agreement
    Créé le 08 févr. 2000
    Livré le 18 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All rights benefits and interests of the company both present and future under the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment of the benefit of an agreement
    Créé le 08 févr. 2000
    Livré le 18 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All rights benefits and interests of the company both present and future under the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 févr. 2000
    Livré le 17 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0