CHASE DESIGN GROUP LTD
Vue d'ensemble
Nom de la société | CHASE DESIGN GROUP LTD |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03739716 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CHASE DESIGN GROUP LTD ?
Adresse du siège social | 19-20 Vine Street WR11 4RL Evesham Worcestershire United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CHASE DESIGN GROUP LTD ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2021 |
Quels sont les derniers dépôts pour CHASE DESIGN GROUP LTD ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 mars 2023 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2021 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 mars 2022 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2020 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 mars 2021 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2019 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 mars 2020 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 2 the Courtyard Timothys Bridge Road Stratford Enterprise Park Stratford-upon-Avon Warwickshire CV37 9NP à 19-20 Vine Street Evesham Worcestershire WR11 4RL le 10 oct. 2019 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2018 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 mars 2019 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2017 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 mars 2018 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Julian Ronald Meredith en tant que directeur le 26 juil. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Gail Ackrill en tant qu'administrateur le 26 juil. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2016 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 mars 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2015 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 mars 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy Guy Haslam en tant que directeur le 31 déc. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 mars 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2013 | 7 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CHASE DESIGN GROUP LTD ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACKRILL, Gail | Administrateur | Vine Street WR11 4RL Evesham 19-20 Worcestershire United Kingdom | England | British | Director | 215880670001 | ||||
ALLKINS, Stephen Philip | Secrétaire | Badgers House Stourton CV36 5HG Shipston On Stour Warwickshire | British | Finance Director | 56899810002 | |||||
MILLER, Jane | Secrétaire | 4 Poplar Rise Wappenham NN12 8RR Towcester Northamptonshire | British | Director | 89678850001 | |||||
INGLEBY NOMINEES LIMITED | Secrétaire désigné | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham | 900007860001 | |||||||
ACKRILL, Roderick Mark | Administrateur | Cedar Lawn Packwood Lane Lapworth B94 6AU Solihull West Midlands | British | Director | 17633980002 | |||||
ALLKINS, Stephen Philip | Administrateur | Badgers House Stourton CV36 5HG Shipston On Stour Warwickshire | England | British | Finance Director | 56899810002 | ||||
GRIFFITHS, Paul Malcolm | Administrateur | 46 Croftwood Road Wollescote DY9 7EY Stourbridge West Midlands | British | Director | 95325090001 | |||||
HASLAM, Timothy Guy | Administrateur | The Courtyard Timothys Bridge Road Stratford Enterprise Park CV37 9NP Stratford-Upon-Avon 2 Warwickshire United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 54650230002 | ||||
MEREDITH, Julian Ronald | Administrateur | The Courtyard Timothys Bridge Road Stratford Enterprise Park CV37 9NP Stratford-Upon-Avon 2 Warwickshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 108679210001 | ||||
MILLER, Jane | Administrateur | 4 Poplar Rise Wappenham NN12 8RR Towcester Northamptonshire | British | Director | 89678850001 | |||||
INGLEBY HOLDINGS LIMITED | Administrateur désigné | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham | 900007850001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CHASE DESIGN GROUP LTD ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
---|---|---|---|
Mrs Gail Ackrill | 30 juin 2016 | Vine Street WR11 4RL Evesham 19-20 Worcestershire United Kingdom | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
|
CHASE DESIGN GROUP LTD a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 20 avr. 2001 Livré le 20 avr. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Assignment of the benefit of a guarantee | Créé le 08 févr. 2000 Livré le 18 févr. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All rights benefits and interests of the company both present and future under the guarantee as from time to time varied or extended and all other rights or remedies accorded to it all debts and claims present and future in relation to land at conwy road llandudno conwy. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Assignment of the benefit of an agreement | Créé le 08 févr. 2000 Livré le 18 févr. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All rights benefits and interests of the company both present and future under the agreement.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Assignment of the benefit of an agreement | Créé le 08 févr. 2000 Livré le 18 févr. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All rights benefits and interests under the agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Assignment of the benefit of an agreement | Créé le 08 févr. 2000 Livré le 18 févr. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All rights benefits and interests of the company both present and future under the agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Assignment of the benefit of an agreement | Créé le 08 févr. 2000 Livré le 18 févr. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All rights benefits and interests of the company both present and future under the agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Assignment of the benefit of an agreement | Créé le 08 févr. 2000 Livré le 18 févr. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All rights benefits and interests of the company both present and future under the agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 03 févr. 2000 Livré le 17 févr. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0