VINCEHIRE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéVINCEHIRE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03751335
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de VINCEHIRE LIMITED ?

    • Location et location d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (77390) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe VINCEHIRE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    100 Cheapside
    EC2V 6DT London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de VINCEHIRE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2015

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour VINCEHIRE LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour VINCEHIRE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2015

    5 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Kings House 36-37 King Street London EC2V 8BB à 100 Cheapside London EC2V 6DT le 23 sept. 2015

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 avr. 2015

    État du capital au 21 avr. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2014

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 juin 2014

    État du capital au 03 juin 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 mars 2014 au 30 avr. 2014

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Christopher Lowton en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ricky Barnett en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013

    6 pagesAA

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    10 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    Changement d'adresse du siège social de * Bramley Vale Chesterfield Derbyshire S44 5GA* le 24 juin 2013

    2 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Christopher Lowton en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Nomination de Eric Watkins en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Nomination de Satpal Singh Dhaiwal en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Mr Richard David Thomas en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Mr Michael Richard Pratt en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2012

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2011

    6 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de VINCEHIRE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WATKINS, Eric
    Cheapside
    EC2V 6DT London
    100
    England
    Secrétaire
    Cheapside
    EC2V 6DT London
    100
    England
    British178773180001
    DHAIWAL, Satpal Singh
    Cheapside
    EC2V 6DT London
    100
    England
    Administrateur
    Cheapside
    EC2V 6DT London
    100
    England
    United KingdomBritishCeo Director58977720002
    PRATT, Michael Richard
    Cheapside
    EC2V 6DT London
    100
    England
    Administrateur
    Cheapside
    EC2V 6DT London
    100
    England
    EnglandBritishAccountant37254010002
    THOMAS, Richard David
    Cheapside
    EC2V 6DT London
    100
    England
    Administrateur
    Cheapside
    EC2V 6DT London
    100
    England
    EnglandBritishAccountant171245630001
    LOWTON, Christopher John
    Bramley Vale
    S44 5GA Chesterfield
    Derbyshire
    Secrétaire
    Bramley Vale
    S44 5GA Chesterfield
    Derbyshire
    British112106310001
    MORRIS, Janet
    Bowenhurst Yard
    Mill Lane, Crondall
    GU10 5RP Farnham
    Surrey
    Secrétaire
    Bowenhurst Yard
    Mill Lane, Crondall
    GU10 5RP Farnham
    Surrey
    British63480360002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARNETT, Ricky John
    Chatsworth Road
    Brampton
    S40 3NU Chesterfield
    668
    Derbyshire
    Administrateur
    Chatsworth Road
    Brampton
    S40 3NU Chesterfield
    668
    Derbyshire
    United KingdomBritishDirector131916840002
    LOWTON, Christopher John
    King Street
    EC2V 8BB London
    Kings House 36-37
    Administrateur
    King Street
    EC2V 8BB London
    Kings House 36-37
    EnglandBritishFinance Director112106310003
    MORRIS, Vincent
    Bowenhurst Yard
    Mill Lane, Crondall
    GU10 5RP Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Bowenhurst Yard
    Mill Lane, Crondall
    GU10 5RP Farnham
    Surrey
    BritishProposed Director63480350002

    VINCEHIRE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27 june 2008 and
    Créé le 20 août 2009
    Livré le 25 août 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 25 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 27 avr. 2009
    Livré le 06 mai 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 06 mai 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 27 avr. 2009
    Livré le 06 mai 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 06 mai 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0