PRO-LINE SECURITIES (UK) LIMITED

PRO-LINE SECURITIES (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPRO-LINE SECURITIES (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03753675
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PRO-LINE SECURITIES (UK) LIMITED ?

    • Activités de sécurité privée (80100) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe PRO-LINE SECURITIES (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Sanderling House Springbrook Lane
    Earlswood
    B94 5SG Solihull
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de PRO-LINE SECURITIES (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour PRO-LINE SECURITIES (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    9 pages4.72

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    7 pages4.20

    Changement d'adresse du siège social de 13N Queensway House Business Centre Queensway Middlesbrough Cleveland TS3 8TF à Sanderling House Springbrook Lane Earlswood Solihull B94 5SG le 01 mars 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 17 févr. 2016

    LRESEX

    Cessation de la nomination de Kah Mey Phang en tant que directeur le 20 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alan Harry Wilkinson en tant que directeur le 20 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 037536750008 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 037536750011 en totalité

    1 pagesMR04

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Agreement 30/10/2015
    RES13

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    9 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Ann Marie Hope en tant que secrétaire le 06 juil. 2015

    1 pagesTM02

    Inscription de la charge 037536750011, créée le 18 juin 2015

    35 pagesMR01

    Nomination de Ms Kah Mey Phang en tant qu'administrateur le 18 juin 2015

    2 pagesAP01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2014

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 juil. 2014

    État du capital au 16 juil. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Satisfaction de la charge 037536750009 en totalité

    1 pagesMR04

    Inscription de la charge 037536750010

    5 pagesMR01

    Nomination de Mr Stephen Richard Key en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2013

    7 pagesAA

    Inscription de la charge 037536750009

    20 pagesMR01

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    6 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de PRO-LINE SECURITIES (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KEY, Stephen Richard
    Gleneagles
    B77 4NS Tamworth
    24
    Staffordshire
    England
    Administrateur
    Gleneagles
    B77 4NS Tamworth
    24
    Staffordshire
    England
    United KingdomBritishCompany Director135441420001
    AGHOLOR, Joseph
    49 Sunbury Avenue
    Jesmond
    NE2 3HD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    49 Sunbury Avenue
    Jesmond
    NE2 3HD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British59876880001
    HOPE, Ann Marie
    41 Lumley Road
    TS10 2BA Redcar
    Cleveland
    Secrétaire
    41 Lumley Road
    TS10 2BA Redcar
    Cleveland
    British89614420002
    TEASDALE, Karen
    21 High Street
    Marske By The Sea
    TS11 6JQ Redcar
    Cleveland
    Secrétaire
    21 High Street
    Marske By The Sea
    TS11 6JQ Redcar
    Cleveland
    BritishAccountant61983630001
    WILKINSON, Andrea
    70 Overdale Road
    TS3 7NH Middlesbrough
    Cleveland
    Secrétaire
    70 Overdale Road
    TS3 7NH Middlesbrough
    Cleveland
    BritishPersonell Manager68608600001
    KEY, Stephen Richard
    Queensway House Business Centre
    Queensway
    TS3 8TF Middlesbrough
    13n
    Cleveland
    United Kingdom
    Administrateur
    Queensway House Business Centre
    Queensway
    TS3 8TF Middlesbrough
    13n
    Cleveland
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector135441420001
    LIVINGSTONE, Joseph
    7 Woodvale
    Coulby Newham
    TS8 0SH Middlesbrough
    Cleveland
    Administrateur
    7 Woodvale
    Coulby Newham
    TS8 0SH Middlesbrough
    Cleveland
    United KingdomBritishManager52228010003
    O'DONNELL, Julie Catherine
    7 Woodvale
    Coulby Newham
    TS8 0SH Middlesbrough
    Cleveland
    Administrateur
    7 Woodvale
    Coulby Newham
    TS8 0SH Middlesbrough
    Cleveland
    United KingdomBritishHr Manager107567700001
    PHANG, Kah Mey
    Queensway House Business Centre
    Queensway
    TS3 8TF Middlesbrough
    13n
    Cleveland
    Administrateur
    Queensway House Business Centre
    Queensway
    TS3 8TF Middlesbrough
    13n
    Cleveland
    EnglandMalaysianDirector183202180001
    WILKINSON, Alan Harry
    Queensway House Business Centre
    Queensway
    TS3 8TF Middlesbrough
    13n
    Cleveland
    United Kingdom
    Administrateur
    Queensway House Business Centre
    Queensway
    TS3 8TF Middlesbrough
    13n
    Cleveland
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector161568230001
    WILKINSON, Andrea
    70 Overdale Road
    TS3 7NH Middlesbrough
    Cleveland
    Administrateur
    70 Overdale Road
    TS3 7NH Middlesbrough
    Cleveland
    BritishPersonell Manager68608600001

    PRO-LINE SECURITIES (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 18 juin 2015
    Livré le 24 juin 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    As continuing security for payment and discharge of the secured liabilities a fixed charge over all properties acquired by the borrower in the future; a fixed charge over all present and future interests of the borrower not effectively mortgaged or charged in or over freehold or leasehold property and a fixed charge over all intellectual property.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Venture Capital (Europe) Limited
    Transactions
    • 24 juin 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 04 févr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 20 mars 2014
    Livré le 21 mars 2014
    En cours
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Liberty Leasing PLC
    Transactions
    • 21 mars 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 23 déc. 2013
    Livré le 23 déc. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Fieldhouse Electrical Limited (In Administration) (Crn: 07401208)
    Transactions
    • 23 déc. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 17 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 14 oct. 2013
    Livré le 04 nov. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Stephen Richard Key
    Transactions
    • 04 nov. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 04 févr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 10 oct. 2013
    Livré le 24 oct. 2013
    En cours
    Brève description
    As continuing security for the payment and discharge of the secured liabilities a first legal mortgage over all properties listed in SCHEDULE1; a first fixed charge over all properties acquired by the borrower in the future; all present and future interests of the borrower not effectively mortgaged or charged under the preceding provisions of clause 3 of the charging instrument in or over freehold or leasehold property and all intellectual property. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Venture Capital (Europe) Limited
    Transactions
    • 24 oct. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Debenture
    Créé le 12 déc. 2012
    Livré le 13 déc. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bibby Financial Services LTD (As Security Trustee)
    Transactions
    • 13 déc. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 26 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 30 nov. 2012
    Livré le 18 déc. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due
    Brèves mentions
    First fixed charge all properties, f/h or l/h property, goodwill and uncalled capital, all book debts. By way of floating charge over the whole of undertaking property and assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Venture Capital (Europe) Limited
    Transactions
    • 18 déc. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 04 févr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 18 nov. 2011
    Livré le 25 nov. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bibby Financial Services Limited (As Security Trustee)
    Transactions
    • 25 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 01 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 20 juil. 2010
    Livré le 28 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Sme Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 28 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 07 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bibby Financial Services Limited, as Security Trustee
    Transactions
    • 07 janv. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed charge on all debts and related rights and floating charge on all other property
    Créé le 17 oct. 2003
    Livré le 31 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed charge all specified debts being any book debts all other debts by way of floating charge all the property (being the undertaking and all the property rights and assets and its uncalled capital). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abbey National Business Cashflow Finance LTD
    Transactions
    • 31 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    PRO-LINE SECURITIES (UK) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    17 févr. 2016Commencement of winding up
    19 juil. 2017Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Andrew Fender
    Sanderlings
    Sanderling House
    B94 5SG Springbrook Lane
    Earlswood Solihull
    practitioner
    Sanderlings
    Sanderling House
    B94 5SG Springbrook Lane
    Earlswood Solihull

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0