PANDA SECURITY UK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPANDA SECURITY UK LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03760287
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PANDA SECURITY UK LIMITED ?

    • Développement de logiciels professionnels et grand public (62012) / Information et communication

    Où se situe PANDA SECURITY UK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Begbies Traynor (Central) Llp Town Wall House
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PANDA SECURITY UK LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PANDA SOFTWARE (UK) LTD16 avr. 200816 avr. 2008
    PANDA SECURITY (UK) LTD30 nov. 200730 nov. 2007
    PANDA SOFTWARE (UK) LTD27 avr. 199927 avr. 1999

    Quels sont les derniers comptes de PANDA SECURITY UK LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour PANDA SECURITY UK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    14 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 déc. 2022

    15 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de 500 Bourne Business Park 5 Dashwood Lang Road Weybridge KT15 2HJ England à Begbies Traynor (Central) Llp Town Wall House Balkerne Hill Colchester Essex CO3 3AD le 07 janv. 2022

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Déclaration de solvabilité

    6 pagesLIQ01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 21 déc. 2021

    LRESSP

    legacy

    56 pagesPARENT_ACC

    legacy

    4 pagesGUARANTEE2

    Déclaration de confirmation établie le 27 avr. 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Notification d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif

    2 pagesPSC08

    Cessation de Gala Capital Partners Equity Scr S. A. en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 avr. 2021

    1 pagesPSC07

    Cessation de Jose Sancho Garcia en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 janv. 2018

    1 pagesPSC07

    Cessation de la nomination de Antony Richard Lee en tant que directeur le 01 août 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Oscar Del Pozo Menor en tant que directeur le 31 juil. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Juan Santamaria Uriarte en tant que directeur le 31 juil. 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Cy Stefan Hersch en tant qu'administrateur le 06 juil. 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Kathryn Elizabeth Coffey en tant qu'administrateur le 06 juil. 2020

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 27 avr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes audités abrégés arrêtés au 31 déc. 2019

    8 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 3000 Hillswood Drive Chertsey KT16 0RS England à 500 Bourne Business Park 5 Dashwood Lang Road Weybridge KT15 2HJ le 13 mai 2019

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 27 avr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes audités abrégés arrêtés au 31 déc. 2018

    7 pagesAA

    Nomination de Mr Oscar Del Pozo Menor en tant qu'administrateur le 04 mars 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Santiago Mayoralas Alises en tant que directeur le 28 févr. 2019

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de PANDA SECURITY UK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COFFEY, Kathryn Elizabeth
    Town Wall House
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Begbies Traynor (Central) Llp
    Essex
    Administrateur
    Town Wall House
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Begbies Traynor (Central) Llp
    Essex
    United StatesAmericanVp, Corporate Controller271650810001
    HERSCH, Cy Stefan
    Town Wall House
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Begbies Traynor (Central) Llp
    Essex
    Administrateur
    Town Wall House
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Begbies Traynor (Central) Llp
    Essex
    United StatesAmericanSenior Director, Corporate Counsel271679340001
    BATES, Samantha
    19 Milner Road
    KT1 2AU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secrétaire
    19 Milner Road
    KT1 2AU Kingston Upon Thames
    Surrey
    British68740950001
    HOLMES, Peter James
    Meadow View
    5a Mill Common
    PE29 3AU Huntingdon
    Cambs
    Secrétaire
    Meadow View
    5a Mill Common
    PE29 3AU Huntingdon
    Cambs
    BritishAccountant97375340001
    LEE, Antony Richard
    12 St Elizabeth Drive
    KT18 7LA Epsom
    Surrey
    Secrétaire
    12 St Elizabeth Drive
    KT18 7LA Epsom
    Surrey
    British109740640001
    PORTEUS, Emmaly Jayne
    19 Fairfield Road
    RH15 8QB Burgess Hill
    West Sussex
    Secrétaire
    19 Fairfield Road
    RH15 8QB Burgess Hill
    West Sussex
    British122692590001
    CATER BARNARD PLC
    Dean House
    Sovereign Court Ermine Business Park
    PE29 6WA Huntingdon
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    Dean House
    Sovereign Court Ermine Business Park
    PE29 6WA Huntingdon
    Cambridgeshire
    74425930001
    ENVESTA PLC
    6 Lloyds Avenue
    EC2N 3AX London
    Secrétaire
    6 Lloyds Avenue
    EC2N 3AX London
    78013300001
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Secrétaire désigné
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900014000001
    SOFTWARE DIALOG PLC
    Unit 5 Signet Court
    Swann Road
    CB5 8LA Cambridge
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    Unit 5 Signet Court
    Swann Road
    CB5 8LA Cambridge
    Cambridgeshire
    90782490001
    ANSON, Nicola
    3 Swan Grove
    Exning
    CB8 7HX Newmarket
    Suffolk
    Administrateur
    3 Swan Grove
    Exning
    CB8 7HX Newmarket
    Suffolk
    EnglandBritishFinancial Director49308560001
    BATES, Jeremy Nicholas
    19 Milner Road
    KT1 2AU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    19 Milner Road
    KT1 2AU Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritishI T Consultant51202980001
    CHAPMAN, Lyndon Douglas
    2 Greenmead Cottage
    Henfield Road
    BN6 9DB Albourne
    West Sussex
    Administrateur
    2 Greenmead Cottage
    Henfield Road
    BN6 9DB Albourne
    West Sussex
    United KingdomBritishCompany Chairman95006010001
    CHAPMAN, Lyndon Douglas
    2 Greenmead Cottage
    Henfield Road
    BN6 9DB Albourne
    West Sussex
    Administrateur
    2 Greenmead Cottage
    Henfield Road
    BN6 9DB Albourne
    West Sussex
    United KingdomBritishDirector95006010001
    CROSBY, Julie
    311 Newmarket Road
    CB5 8JE Cambridge
    Administrateur
    311 Newmarket Road
    CB5 8JE Cambridge
    BritishMarketing Manager97478920001
    DEL POZO MENOR, Oscar
    Santiago De Compostela 12
    1st Floor 48003
    Bilbao
    Panda Security S.L.
    Spain
    Administrateur
    Santiago De Compostela 12
    1st Floor 48003
    Bilbao
    Panda Security S.L.
    Spain
    SpainSpanishCfo256246680001
    EDWARDS, Stephen
    1 Cam Close
    PE27 3FG St. Ives
    Cambridgeshire
    Administrateur
    1 Cam Close
    PE27 3FG St. Ives
    Cambridgeshire
    BritishManager74301870001
    GARCIA AGUSTIN, Juan Andres
    28009
    Madrid
    C/Lope De Rueda 45,
    Spain
    Administrateur
    28009
    Madrid
    C/Lope De Rueda 45,
    Spain
    SpainSpanishDirector139546790001
    GARCIA CHECA, Jose Fernando
    Hillswood Drive
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    England
    Administrateur
    Hillswood Drive
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    England
    SpainSpanishBusiness Director205500940001
    GIANNOTTA, Simon
    28 Carter Close
    SL4 3QX Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    28 Carter Close
    SL4 3QX Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritishSales Executive103689920002
    HALE, Ian Edward
    15 Beaumont Vale
    CB9 8QG Haverhill
    Suffolk
    Administrateur
    15 Beaumont Vale
    CB9 8QG Haverhill
    Suffolk
    BritishDirector76302170002
    HALLWORTH, Simon Jeremy
    Clifford House
    5 High Street
    BN6 9TT Hurstpierpoint
    West Sussex
    Administrateur
    Clifford House
    5 High Street
    BN6 9TT Hurstpierpoint
    West Sussex
    EnglandBritishSales Executive61732800002
    HOLMES, Peter James
    Meadow View
    5a Mill Common
    PE29 3AU Huntingdon
    Cambs
    Administrateur
    Meadow View
    5a Mill Common
    PE29 3AU Huntingdon
    Cambs
    EnglandBritishAccountant97375340001
    HOSKINS, Dominic
    1 Oldwood Chase
    Southwood
    GU14 0QS Farnborough
    Hampshire
    Administrateur
    1 Oldwood Chase
    Southwood
    GU14 0QS Farnborough
    Hampshire
    BritishSales Executive124512680001
    LAUTIN, Petter
    Opladen Way
    RG12 0PH Bracknell
    Lavenir
    Berkshire
    Administrateur
    Opladen Way
    RG12 0PH Bracknell
    Lavenir
    Berkshire
    United KingdomNorwegianManaging Director65681210007
    LEE, Antony Richard
    Bourne Business Park
    5 Dashwood Lang Road
    KT15 2HJ Weybridge
    500
    England
    Administrateur
    Bourne Business Park
    5 Dashwood Lang Road
    KT15 2HJ Weybridge
    500
    England
    EnglandBritishChartered Accountant109740640001
    MANRIQUE DE LARA FERNANDEZ, Ignacio
    C/La Maso 99
    28034 Madrid
    Madrid
    Spain
    Administrateur
    C/La Maso 99
    28034 Madrid
    Madrid
    Spain
    SpainSpanishDirector139651450001
    MAYORALAS ALISES, Santiago
    Hillswood Drive
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    England
    Administrateur
    Hillswood Drive
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    England
    SpainSpanishCfo220972690001
    NAVARRETE IACOBI, Diego Ian
    Opladen Way
    RG12 0PH Bracknell
    Lavenir
    Berkshire
    Administrateur
    Opladen Way
    RG12 0PH Bracknell
    Lavenir
    Berkshire
    SpainSpanishGeneral Manager199342400001
    PEREZ, Juan Santana
    28760 Tres Cantos
    Madrid
    C/Ronda De Poniente 17
    Spain
    Administrateur
    28760 Tres Cantos
    Madrid
    C/Ronda De Poniente 17
    Spain
    SpainSpanishDirector148636550001
    PORTEUS, Emmaly Jayne
    19 Fairfield Road
    RH15 8QB Burgess Hill
    West Sussex
    Administrateur
    19 Fairfield Road
    RH15 8QB Burgess Hill
    West Sussex
    BritishFinancial Director122692590001
    PRICE, Mark Thomas
    95 Teversham Drift
    CB1 3LL Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    95 Teversham Drift
    CB1 3LL Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishTechnician97479010001
    REAY, David Alan
    41 Pepperslade
    Duxford
    CB2 4XT Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    41 Pepperslade
    Duxford
    CB2 4XT Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishSales Director98636900001
    ROBERTS, Anthony
    94a London Road
    RH15 8NB Burgess Hill
    West Sussex
    Administrateur
    94a London Road
    RH15 8NB Burgess Hill
    West Sussex
    BritishTechnical Manager124511550001
    SANTAMARIA URIARTE, Juan
    Bourne Business Park
    5 Dashwood Lang Road
    KT15 2HJ Weybridge
    500
    England
    Administrateur
    Bourne Business Park
    5 Dashwood Lang Road
    KT15 2HJ Weybridge
    500
    England
    SpainSpanishGeneral Manager243078490001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PANDA SECURITY UK LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Gala Capital Partners Equity Scr S. A.
    Serrano
    Madrid
    57
    Spain
    06 avr. 2016
    Serrano
    Madrid
    57
    Spain
    Oui
    Forme juridiqueAnonymous Society
    Pays d'enregistrementSpain
    Autorité légaleSpain
    Lieu d'enregistrementSpain
    Numéro d'enregistrementNot Applicable
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    Mr Jose Sancho Garcia
    Santiago De Compostela
    48003
    Bilbao
    12
    Spain
    06 avr. 2016
    Santiago De Compostela
    48003
    Bilbao
    12
    Spain
    Oui
    Nationalité: Spanish
    Pays de résidence: Spain
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des actions de la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour PANDA SECURITY UK LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    26 avr. 2021La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    PANDA SECURITY UK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    All assets debenture
    Créé le 25 juin 2010
    Livré le 29 juin 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 29 juin 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 21 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 07 mai 2010
    Livré le 20 mai 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 mai 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 21 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 06 avr. 2009
    Livré le 16 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 nov. 2005
    Livré le 30 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Close Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 30 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 15 juil. 2005
    Livré le 26 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £17,986.31 due or to become due from the company to
    Brèves mentions
    £17,986.31 and interest accruing in a deposit account.
    Personnes ayant droit
    • Mgph Limited
    Transactions
    • 26 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 13 nov. 2001
    Livré le 15 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Venture Finance PLC
    Transactions
    • 15 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 28 mars 2000
    Livré le 11 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee arising under a factoring agreement
    Brèves mentions
    (I) by way of fixed charge any present or future debt the ownership of which fail to vest absolutely and effectively in the security holder for any reason together with the related rights (the factored debts) and (ii) all amounts of indebtedness due to the company on any account whatsoever other than the factored debts (the other debts).by way of floating charge all the undertaking and all the property rights and assets.
    Personnes ayant droit
    • Bibby Factors Limited
    Transactions
    • 11 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    PANDA SECURITY UK LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    02 avr. 2024Due to be dissolved on
    21 déc. 2021Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Lee De'Ath
    Town Wall House Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex
    practitioner
    Town Wall House Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex
    Richard Howard Toone
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    practitioner
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0