PANDA SECURITY UK LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | PANDA SECURITY UK LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03760287 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PANDA SECURITY UK LIMITED ?
Adresse du siège social | Begbies Traynor (Central) Llp Town Wall House Balkerne Hill CO3 3AD Colchester Essex |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PANDA SECURITY UK LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour PANDA SECURITY UK LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 14 pages | LIQ13 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 déc. 2022 | 15 pages | LIQ03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 500 Bourne Business Park 5 Dashwood Lang Road Weybridge KT15 2HJ England à Begbies Traynor (Central) Llp Town Wall House Balkerne Hill Colchester Essex CO3 3AD le 07 janv. 2022 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 6 pages | LIQ01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 56 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 4 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 27 avr. 2021 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Notification d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif | 2 pages | PSC08 | ||||||||||
Cessation de Gala Capital Partners Equity Scr S. A. en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 avr. 2021 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Jose Sancho Garcia en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 janv. 2018 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Antony Richard Lee en tant que directeur le 01 août 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Oscar Del Pozo Menor en tant que directeur le 31 juil. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Juan Santamaria Uriarte en tant que directeur le 31 juil. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Cy Stefan Hersch en tant qu'administrateur le 06 juil. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Kathryn Elizabeth Coffey en tant qu'administrateur le 06 juil. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 27 avr. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes audités abrégés arrêtés au 31 déc. 2019 | 8 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 3000 Hillswood Drive Chertsey KT16 0RS England à 500 Bourne Business Park 5 Dashwood Lang Road Weybridge KT15 2HJ le 13 mai 2019 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 27 avr. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes audités abrégés arrêtés au 31 déc. 2018 | 7 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Oscar Del Pozo Menor en tant qu'administrateur le 04 mars 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Santiago Mayoralas Alises en tant que directeur le 28 févr. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de PANDA SECURITY UK LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFFEY, Kathryn Elizabeth | Administrateur | Town Wall House Balkerne Hill CO3 3AD Colchester Begbies Traynor (Central) Llp Essex | United States | American | Vp, Corporate Controller | 271650810001 | ||||
HERSCH, Cy Stefan | Administrateur | Town Wall House Balkerne Hill CO3 3AD Colchester Begbies Traynor (Central) Llp Essex | United States | American | Senior Director, Corporate Counsel | 271679340001 | ||||
BATES, Samantha | Secrétaire | 19 Milner Road KT1 2AU Kingston Upon Thames Surrey | British | 68740950001 | ||||||
HOLMES, Peter James | Secrétaire | Meadow View 5a Mill Common PE29 3AU Huntingdon Cambs | British | Accountant | 97375340001 | |||||
LEE, Antony Richard | Secrétaire | 12 St Elizabeth Drive KT18 7LA Epsom Surrey | British | 109740640001 | ||||||
PORTEUS, Emmaly Jayne | Secrétaire | 19 Fairfield Road RH15 8QB Burgess Hill West Sussex | British | 122692590001 | ||||||
CATER BARNARD PLC | Secrétaire | Dean House Sovereign Court Ermine Business Park PE29 6WA Huntingdon Cambridgeshire | 74425930001 | |||||||
ENVESTA PLC | Secrétaire | 6 Lloyds Avenue EC2N 3AX London | 78013300001 | |||||||
FORM 10 SECRETARIES FD LTD | Secrétaire désigné | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester Lancashire | 900014000001 | |||||||
SOFTWARE DIALOG PLC | Secrétaire | Unit 5 Signet Court Swann Road CB5 8LA Cambridge Cambridgeshire | 90782490001 | |||||||
ANSON, Nicola | Administrateur | 3 Swan Grove Exning CB8 7HX Newmarket Suffolk | England | British | Financial Director | 49308560001 | ||||
BATES, Jeremy Nicholas | Administrateur | 19 Milner Road KT1 2AU Kingston Upon Thames Surrey | United Kingdom | British | I T Consultant | 51202980001 | ||||
CHAPMAN, Lyndon Douglas | Administrateur | 2 Greenmead Cottage Henfield Road BN6 9DB Albourne West Sussex | United Kingdom | British | Company Chairman | 95006010001 | ||||
CHAPMAN, Lyndon Douglas | Administrateur | 2 Greenmead Cottage Henfield Road BN6 9DB Albourne West Sussex | United Kingdom | British | Director | 95006010001 | ||||
CROSBY, Julie | Administrateur | 311 Newmarket Road CB5 8JE Cambridge | British | Marketing Manager | 97478920001 | |||||
DEL POZO MENOR, Oscar | Administrateur | Santiago De Compostela 12 1st Floor 48003 Bilbao Panda Security S.L. Spain | Spain | Spanish | Cfo | 256246680001 | ||||
EDWARDS, Stephen | Administrateur | 1 Cam Close PE27 3FG St. Ives Cambridgeshire | British | Manager | 74301870001 | |||||
GARCIA AGUSTIN, Juan Andres | Administrateur | 28009 Madrid C/Lope De Rueda 45, Spain | Spain | Spanish | Director | 139546790001 | ||||
GARCIA CHECA, Jose Fernando | Administrateur | Hillswood Drive KT16 0RS Chertsey 3000 England | Spain | Spanish | Business Director | 205500940001 | ||||
GIANNOTTA, Simon | Administrateur | 28 Carter Close SL4 3QX Windsor Berkshire | United Kingdom | British | Sales Executive | 103689920002 | ||||
HALE, Ian Edward | Administrateur | 15 Beaumont Vale CB9 8QG Haverhill Suffolk | British | Director | 76302170002 | |||||
HALLWORTH, Simon Jeremy | Administrateur | Clifford House 5 High Street BN6 9TT Hurstpierpoint West Sussex | England | British | Sales Executive | 61732800002 | ||||
HOLMES, Peter James | Administrateur | Meadow View 5a Mill Common PE29 3AU Huntingdon Cambs | England | British | Accountant | 97375340001 | ||||
HOSKINS, Dominic | Administrateur | 1 Oldwood Chase Southwood GU14 0QS Farnborough Hampshire | British | Sales Executive | 124512680001 | |||||
LAUTIN, Petter | Administrateur | Opladen Way RG12 0PH Bracknell Lavenir Berkshire | United Kingdom | Norwegian | Managing Director | 65681210007 | ||||
LEE, Antony Richard | Administrateur | Bourne Business Park 5 Dashwood Lang Road KT15 2HJ Weybridge 500 England | England | British | Chartered Accountant | 109740640001 | ||||
MANRIQUE DE LARA FERNANDEZ, Ignacio | Administrateur | C/La Maso 99 28034 Madrid Madrid Spain | Spain | Spanish | Director | 139651450001 | ||||
MAYORALAS ALISES, Santiago | Administrateur | Hillswood Drive KT16 0RS Chertsey 3000 England | Spain | Spanish | Cfo | 220972690001 | ||||
NAVARRETE IACOBI, Diego Ian | Administrateur | Opladen Way RG12 0PH Bracknell Lavenir Berkshire | Spain | Spanish | General Manager | 199342400001 | ||||
PEREZ, Juan Santana | Administrateur | 28760 Tres Cantos Madrid C/Ronda De Poniente 17 Spain | Spain | Spanish | Director | 148636550001 | ||||
PORTEUS, Emmaly Jayne | Administrateur | 19 Fairfield Road RH15 8QB Burgess Hill West Sussex | British | Financial Director | 122692590001 | |||||
PRICE, Mark Thomas | Administrateur | 95 Teversham Drift CB1 3LL Cambridge Cambridgeshire | British | Technician | 97479010001 | |||||
REAY, David Alan | Administrateur | 41 Pepperslade Duxford CB2 4XT Cambridge Cambridgeshire | British | Sales Director | 98636900001 | |||||
ROBERTS, Anthony | Administrateur | 94a London Road RH15 8NB Burgess Hill West Sussex | British | Technical Manager | 124511550001 | |||||
SANTAMARIA URIARTE, Juan | Administrateur | Bourne Business Park 5 Dashwood Lang Road KT15 2HJ Weybridge 500 England | Spain | Spanish | General Manager | 243078490001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PANDA SECURITY UK LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gala Capital Partners Equity Scr S. A. | 06 avr. 2016 | Serrano Madrid 57 Spain | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Mr Jose Sancho Garcia | 06 avr. 2016 | Santiago De Compostela 48003 Bilbao 12 Spain | Oui | ||||||||||
Nationalité: Spanish Pays de résidence: Spain | |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour PANDA SECURITY UK LIMITED ?
Notifié le | Cessé le | Déclaration |
---|---|---|
26 avr. 2021 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
PANDA SECURITY UK LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
All assets debenture | Créé le 25 juin 2010 Livré le 29 juin 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 07 mai 2010 Livré le 20 mai 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 06 avr. 2009 Livré le 16 avr. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 29 nov. 2005 Livré le 30 nov. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Rent deposit deed | Créé le 15 juil. 2005 Livré le 26 juil. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti £17,986.31 due or to become due from the company to | |
Brèves mentions £17,986.31 and interest accruing in a deposit account. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 13 nov. 2001 Livré le 15 nov. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge | Créé le 28 mars 2000 Livré le 11 avr. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee arising under a factoring agreement | |
Brèves mentions (I) by way of fixed charge any present or future debt the ownership of which fail to vest absolutely and effectively in the security holder for any reason together with the related rights (the factored debts) and (ii) all amounts of indebtedness due to the company on any account whatsoever other than the factored debts (the other debts).by way of floating charge all the undertaking and all the property rights and assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
PANDA SECURITY UK LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0