SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03762419 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED ?
| Adresse du siège social | Connaught House 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2011 |
Quels sont les derniers dépôts pour SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Angela Culhane en tant que directeur le 25 juin 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2011 | 17 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 17 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Jonathan David Calow en tant que secrétaire le 08 déc. 2011 | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Care Uk Services Ltd en tant que secrétaire le 08 déc. 2011 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 17 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Connaught House the Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9QB le 03 mai 2011 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Paul Justin Humphreys le 01 avr. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2010 | 17 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Paul John Watson en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Michael Robert Parish le 10 août 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 12 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 28 pages | MG01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2009 | 17 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Deborah Jane Marriott-Boam en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Geoffrey Benn en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 17 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Care Uk Services Ltd le 01 avr. 2010 | 2 pages | CH04 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Douglas Umbers en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Angela Hector Culhane en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALOW, Jonathan David | Secrétaire | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom | 165633600001 | |||||||||||
| HUMPHREYS, Paul Justin | Administrateur | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 33223550003 | |||||||||
| MARRIOTT-BOAM, Deborah Jane | Administrateur | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 151689670001 | |||||||||
| PARISH, Michael Robert | Administrateur | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom | England | British | 78828750003 | |||||||||
| WATSON, Paul John | Administrateur | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 82460360003 | |||||||||
| BURKE, Michael Anthony | Secrétaire | 1446 Stratford Road B28 9ES Birmingham West Midlands | British | 101343700001 | ||||||||||
| GEORGE, Valerie Grace | Secrétaire | 1446 Stratford Road Hall Green B28 9ES Birmingham | British | 66299990002 | ||||||||||
| HUMPHREYS, Paul Justin | Secrétaire | Hall Barn Creeting Hall Farm Creeting Saint Peter IP6 8QZ Ipswich Suffolk | British | 33223550003 | ||||||||||
| CARE UK SERVICES LTD | Secrétaire | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom |
| 125241530002 | ||||||||||
| JPCORS LIMITED | Secrétaire désigné | Suite 17 City Business Centre Lower Road SE16 2XB London | 900001430001 | |||||||||||
| BENN, Geoffrey Richard | Administrateur | 15 Mimosa Close CM1 6NW Chelmsford Essex | England | British | 73786580001 | |||||||||
| BOOKER, Roger Ian | Administrateur | Fairview 17a Queens Road WA15 9HF Hale Cheshire | United Kingdom | British | 14044530003 | |||||||||
| BURKE, Michael Anthony | Administrateur | 1446 Stratford Road B28 9ES Birmingham West Midlands | British | 101343700001 | ||||||||||
| BURKE, Michelle Deborah | Administrateur | 1446 Stratford Road Hall Green B28 9ES Birmingham West Midlands | British | 66299740002 | ||||||||||
| CULHANE, Angela | Administrateur | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom | England | British | 68602910001 | |||||||||
| GEORGE, Valerie Grace | Administrateur | 1446 Stratford Road Hall Green B28 9ES Birmingham | British | 66299990002 | ||||||||||
| HASTINGS, Roy | Administrateur | Wallis Road RG21 3DN Basingstoke 20 Hampshire | United Kingdom | British | 130098430001 | |||||||||
| QUINN, David Laurence, Mr. | Administrateur | 6 Whitecross Road HP17 8BA Haddenham Buckinghamshire | England | British | 123356660001 | |||||||||
| UMBERS, Douglas | Administrateur | SO53 | United Kingdom | British | 90541690001 | |||||||||
| VOCKINS, Anthony Frederick | Administrateur | 4 Main Street Croxton Kerrial NG32 1QF Grantham The Old Post Office Lincolnshire | England | British | 130512090002 | |||||||||
| JPCORD LIMITED | Administrateur désigné | Suite 17 City Business Centre Lower Road SE16 2XB London | 900001420001 |
SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 21 juil. 2010 Livré le 26 juil. 2010 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 16 mars 2007 Livré le 04 avr. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 22 sept. 2006 Livré le 29 sept. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 24 oct. 2003 Livré le 12 nov. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The property known as maple leaf lodge redhill road forhill. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 12 juil. 1999 Livré le 13 juil. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0