SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED

SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03762419
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED ?

    • Autres activités liées à la santé humaine (86900) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Angela Culhane en tant que directeur le 25 juin 2012

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2011

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 avr. 2012

    État du capital au 19 avr. 2012

    • Capital: GBP 1,350
    SH01

    Nomination de Jonathan David Calow en tant que secrétaire le 08 déc. 2011

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Care Uk Services Ltd en tant que secrétaire le 08 déc. 2011

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de Connaught House the Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9QB le 03 mai 2011

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Paul Justin Humphreys le 01 avr. 2011

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2010

    17 pagesAA

    Nomination de Paul John Watson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Michael Robert Parish le 10 août 2010

    2 pagesCH01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Résolutions

    Resolutions
    12 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    legacy

    28 pagesMG01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2009

    17 pagesAA

    Nomination de Deborah Jane Marriott-Boam en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Geoffrey Benn en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Annotations
    DateAnnotation
    31 oct. 2025Other Any information marked (#) was made unavailable on 31/10/2025 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    Modification des coordonnées du secrétaire Care Uk Services Ltd le 01 avr. 2010

    2 pagesCH04

    Cessation de la nomination de Douglas Umbers en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Angela Hector Culhane en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CALOW, Jonathan David
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Secrétaire
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    165633600001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish33223550003
    MARRIOTT-BOAM, Deborah Jane
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish151689670001
    PARISH, Michael Robert
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish78828750003
    WATSON, Paul John
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish82460360003
    BURKE, Michael Anthony
    1446 Stratford Road
    B28 9ES Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    1446 Stratford Road
    B28 9ES Birmingham
    West Midlands
    British101343700001
    GEORGE, Valerie Grace
    1446 Stratford Road
    Hall Green
    B28 9ES Birmingham
    Secrétaire
    1446 Stratford Road
    Hall Green
    B28 9ES Birmingham
    British66299990002
    HUMPHREYS, Paul Justin
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    Secrétaire
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    British33223550003
    CARE UK SERVICES LTD
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Secrétaire
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2482660
    125241530002
    JPCORS LIMITED
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    Secrétaire désigné
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    900001430001
    BENN, Geoffrey Richard
    15 Mimosa Close
    CM1 6NW Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    15 Mimosa Close
    CM1 6NW Chelmsford
    Essex
    EnglandBritish73786580001
    BOOKER, Roger Ian
    Fairview
    17a Queens Road
    WA15 9HF Hale
    Cheshire
    Administrateur
    Fairview
    17a Queens Road
    WA15 9HF Hale
    Cheshire
    United KingdomBritish14044530003
    BURKE, Michael Anthony
    1446 Stratford Road
    B28 9ES Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    1446 Stratford Road
    B28 9ES Birmingham
    West Midlands
    British101343700001
    BURKE, Michelle Deborah
    1446 Stratford Road
    Hall Green
    B28 9ES Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    1446 Stratford Road
    Hall Green
    B28 9ES Birmingham
    West Midlands
    British66299740002
    CULHANE, Angela
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish68602910001
    GEORGE, Valerie Grace
    1446 Stratford Road
    Hall Green
    B28 9ES Birmingham
    Administrateur
    1446 Stratford Road
    Hall Green
    B28 9ES Birmingham
    British66299990002
    HASTINGS, Roy
    Wallis Road
    RG21 3DN Basingstoke
    20
    Hampshire
    Administrateur
    Wallis Road
    RG21 3DN Basingstoke
    20
    Hampshire
    United KingdomBritish130098430001
    QUINN, David Laurence, Mr.
    6 Whitecross Road
    HP17 8BA Haddenham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    6 Whitecross Road
    HP17 8BA Haddenham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish123356660001
    UMBERS, Douglas
    SO53
    Administrateur
    SO53
    United KingdomBritish90541690001
    VOCKINS, Anthony Frederick
    4 Main Street
    Croxton Kerrial
    NG32 1QF Grantham
    The Old Post Office
    Lincolnshire
    Administrateur
    4 Main Street
    Croxton Kerrial
    NG32 1QF Grantham
    The Old Post Office
    Lincolnshire
    EnglandBritish130512090002
    JPCORD LIMITED
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    Administrateur désigné
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    900001420001

    SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 21 juil. 2010
    Livré le 26 juil. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank Nv, London Branch (As Security Agent)
    Transactions
    • 26 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 16 mars 2007
    Livré le 04 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 22 sept. 2006
    Livré le 29 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 29 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 24 oct. 2003
    Livré le 12 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property known as maple leaf lodge redhill road forhill. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 juil. 1999
    Livré le 13 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0