OLYMPIA GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOLYMPIA GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03764367
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OLYMPIA GROUP LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe OLYMPIA GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de OLYMPIA GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    EARLS COURT & OLYMPIA GROUP LIMITED01 oct. 199901 oct. 1999
    HEXAGON 237 LIMITED04 mai 199904 mai 1999

    Quels sont les derniers comptes de OLYMPIA GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour OLYMPIA GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    13 pagesLIQ13

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Olympia London Hammersmith Road Kensington London W14 8UX

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Olympia London Hammersmith Road Kensington London W14 8UX England à Olympia London Hammersmith Road Kensington London W14 8UX

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Olympia London Hammersmith Road Kensington London W14 8UX England à Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR le 24 oct. 2018

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 01 oct. 2018

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    7 pagesLIQ01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 24 sept. 2018

    • Capital: GBP 1.00
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Yvonne Lillian Denyer en tant que directeur le 10 sept. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Gavin Stuart Charles Neilan en tant que directeur le 24 mai 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Nigel Howard Nathan en tant que directeur le 24 mai 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Matthew Thorpe en tant que directeur le 24 mai 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 04 mai 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Olympia London Hammersmith Road Kensington London W14 8UX

    1 pagesAD04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gavin Stuart Charles Neilan le 30 août 2017

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Matthew Thorpe le 30 août 2017

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Lloyd Eng-Meng Lee le 30 août 2017

    2 pagesCH01

    Nomination de Ms Yvonne Lillian Denyer en tant que secrétaire le 11 sept. 2017

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Jagdish Johal en tant que secrétaire le 11 sept. 2017

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de 4th Floor, 26-28 Mount Row London W1K 3SG United Kingdom à Olympia London Hammersmith Road Kensington London W14 8UX le 30 août 2017

    1 pagesAD01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Olympia London Hammersmith Road Kensington London W14 8UX

    1 pagesAD03

    Qui sont les dirigeants de OLYMPIA GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DENYER, Yvonne Lillian
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Secrétaire
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    238953230001
    LEE, Lloyd Eng-Meng
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Administrateur
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United KingdomAmerican86610230004
    ROCCOGRANDE, Frank Charles
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Administrateur
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United KingdomAmerican220664170001
    CONWAY, Simon Alexander Malcolm
    York Lodge
    High Wood Hill Mill
    NW7 4HA London
    Greater London
    Secrétaire
    York Lodge
    High Wood Hill Mill
    NW7 4HA London
    Greater London
    British88608520001
    FOLGER, Susan
    40 Broadway
    London
    SW1H 0BU
    Secrétaire
    40 Broadway
    London
    SW1H 0BU
    British68599110002
    JOHAL, Jagdish
    Mount Row
    W1K 3SG London
    4th Floor, 24-26
    United Kingdom
    Secrétaire
    Mount Row
    W1K 3SG London
    4th Floor, 24-26
    United Kingdom
    229032480001
    MCCAVENY, Leigh
    Grosvenor Street
    W1K 4QZ London
    15
    Secrétaire
    Grosvenor Street
    W1K 4QZ London
    15
    207687630001
    MORRIS, Jack Anthony
    2 Linnell Drive
    NW11 7LJ London
    Secrétaire
    2 Linnell Drive
    NW11 7LJ London
    British2460900001
    NEAL, Peter Richard
    Earls Court Exhibition Centre
    Warwick Road
    SW5 9TA London
    Secrétaire
    Earls Court Exhibition Centre
    Warwick Road
    SW5 9TA London
    British95289870001
    PAVEY, Ruth Elizabeth
    Grosvenor Street
    W1K 4QZ London
    15
    Secrétaire
    Grosvenor Street
    W1K 4QZ London
    15
    British151473460001
    PILCHER, Timothy James
    46 Caldervale Road
    Clapham
    SW4 9LZ London
    Secrétaire
    46 Caldervale Road
    Clapham
    SW4 9LZ London
    British72758230001
    HEXAGON REGISTRARS LIMITED
    Ten Dominion Street
    EC2M 2EE London
    Secrétaire désigné
    Ten Dominion Street
    EC2M 2EE London
    900013760001
    ARCULUS, Thomas David Guy
    Flat 193 County Hall North Block
    1a Belvedere Road
    SE1 7GH London
    Administrateur
    Flat 193 County Hall North Block
    1a Belvedere Road
    SE1 7GH London
    British80344070001
    BARTON, Robin Michael
    45 Sandrock Hill Road
    Wrecclesham
    GU10 4RJ Farnham
    Surrey
    Administrateur
    45 Sandrock Hill Road
    Wrecclesham
    GU10 4RJ Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish110323990001
    BLACK, William Reginald
    Grosvenor Street
    W1K 4QZ London
    15
    Administrateur
    Grosvenor Street
    W1K 4QZ London
    15
    EnglandBritish41017610002
    CONWAY, Simon Alexander Malcolm
    York Lodge
    High Wood Hill Mill
    NW7 4HA London
    Greater London
    Administrateur
    York Lodge
    High Wood Hill Mill
    NW7 4HA London
    Greater London
    EnglandBritish88608520001
    DAS, Soumen
    Grosvenor Street
    W1K 4QZ London
    15
    Administrateur
    Grosvenor Street
    W1K 4QZ London
    15
    United KingdomBritish150962550001
    DENYER, Yvonne Lillian
    Hammersmith Road
    Kensington
    W14 8UX London
    Olympia London
    England
    Administrateur
    Hammersmith Road
    Kensington
    W14 8UX London
    Olympia London
    England
    United KingdomBritish102647680002
    DURANT, Ian Charles
    57 The Avenue
    Kew
    TW9 2AL Richmond
    Surrey
    Administrateur
    57 The Avenue
    Kew
    TW9 2AL Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish150020002
    EDINGTON, George Gordon
    7 St Simons Avenue
    Putney
    SW15 6DU London
    Administrateur
    7 St Simons Avenue
    Putney
    SW15 6DU London
    United KingdomBritish1386790001
    FISCHEL, David Andrew
    40 Broadway
    London
    SW1H 0BU
    Administrateur
    40 Broadway
    London
    SW1H 0BU
    United KingdomBritish8845220002
    GOOLD, Jonathan Pearson
    13 Lillian Road
    Barnes
    SW13 9JG London
    Administrateur
    13 Lillian Road
    Barnes
    SW13 9JG London
    British79723100001
    HAWKSWORTH, Ian David
    Grosvenor Street
    W1K 4QZ London
    15
    Administrateur
    Grosvenor Street
    W1K 4QZ London
    15
    United KingdomBritish115713550001
    JOBANPUTRA, Situl Suryakant
    Grosvenor Street
    W1K 4QZ London
    15
    United Kingdom
    Administrateur
    Grosvenor Street
    W1K 4QZ London
    15
    United Kingdom
    United KingdomBritish220745230001
    KIMBLE, Simon Reed, Mr.
    125 Blythe Road
    W14 0HL London
    Administrateur
    125 Blythe Road
    W14 0HL London
    British76923040002
    KING, Suzanne Jane
    114 Ramillies Road
    W4 1JA London
    Administrateur
    114 Ramillies Road
    W4 1JA London
    United KingdomBritish87195220001
    LEEFE, Simon Neville Arden
    Cuckfield Road
    Ansty
    RH17 5AJ Haywards Heath
    West Riddens
    West Sussex
    Administrateur
    Cuckfield Road
    Ansty
    RH17 5AJ Haywards Heath
    West Riddens
    West Sussex
    United KingdomBritish136410560001
    LYONS, Anthony
    Bracknell Gardens
    NW3 7EE London
    25
    Administrateur
    Bracknell Gardens
    NW3 7EE London
    25
    United KingdomBritish117463490002
    MORRIS, Andrew Bernard
    5 Ruskin Close
    NW11 7AU London
    Administrateur
    5 Ruskin Close
    NW11 7AU London
    United KingdomBritish2464800001
    MORRIS, Jack Anthony
    2 Linnell Drive
    NW11 7LJ London
    Administrateur
    2 Linnell Drive
    NW11 7LJ London
    EnglandBritish2460900001
    NATHAN, Nigel Howard
    Hammersmith Road
    Kensington
    W14 8UX London
    Olympia London
    England
    Administrateur
    Hammersmith Road
    Kensington
    W14 8UX London
    Olympia London
    England
    United KingdomBritish66508820005
    NEILAN, Gavin Stuart Charles
    Hammersmith Road
    Kensington
    W14 8UX London
    Olympia London
    England
    Administrateur
    Hammersmith Road
    Kensington
    W14 8UX London
    Olympia London
    England
    United KingdomBritish220664190001
    PILCHER, Timothy James
    46 Caldervale Road
    Clapham
    SW4 9LZ London
    Administrateur
    46 Caldervale Road
    Clapham
    SW4 9LZ London
    British72758230001
    SELLINS, Jonathan Robert
    W13
    Administrateur
    W13
    United KingdomBritish108633180001
    SELLINS, Jonathan Robert
    W13
    Administrateur
    W13
    United KingdomBritish108633180001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur OLYMPIA GROUP LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mount Row
    W1K 3SG London
    26-28
    England
    06 avr. 2016
    Mount Row
    W1K 3SG London
    26-28
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement05089859
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    OLYMPIA GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 20 avr. 2017
    Livré le 25 avr. 2017
    En cours
    Brève description
    The mortgaged property being olympia exhibition halls, hammersmith road, london W14 8UX with title number BGL31510.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lgim Commercial Lending Limited, One Coleman Street, London, EC2R 5AA (As Security Agent)
    Transactions
    • 25 avr. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 20 avr. 2017
    Livré le 25 avr. 2017
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lgim Commercial Lending Limited, One Coleman Street, London, EC2R 5AA (As Security Agent and Secured Party)
    Transactions
    • 25 avr. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 16 févr. 2017
    Livré le 17 févr. 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    The properties owned by the chargor as specified (and defined) in the supplemental charge registered by this form MR01 ("supplemental charge") and including, amongst others, leasehold land being part of olympia way, hammersmith, london and registered at the land registry with title number BGL23331. For more details please refer to the supplemental charge.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Credit Agricole Corporate and Investment Bank as Security Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 17 févr. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 25 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 19 déc. 2016
    Livré le 23 déc. 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    By way of first legal mortgage, all freehold and leasehold property owned by the chargor, including (amongst others) the freehold land being olympia exhibition halls, hammersmith road, london (W14 8UX) and registered at the land registry under title number BGL31510 and the freehold land on the north west side of olympia way, kensington olympia, london and registered at the land registry under title number BGL15270, and including all buildings, fixtures, fittings and fixed plant and machinery on those properties. For more information, please see the debenture.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Credit Agricole Corporate and Investment Bank (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transactions
    • 23 déc. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 25 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 19 déc. 2016
    Livré le 22 déc. 2016
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Credit Agricole Corporate and Investment Bank (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transactions
    • 22 déc. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 25 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Share charge
    Créé le 24 déc. 2009
    Livré le 12 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The investments being ordinary shares in the issued capital of empress place limited see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation Limited
    Transactions
    • 12 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 14 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge over account
    Créé le 14 avr. 2008
    Livré le 17 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge all right title and interest in and to the account and the deposit see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (Security Trustee)
    Transactions
    • 17 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 24 juil. 2007
    Livré le 06 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Capital and Counties Limited
    Transactions
    • 06 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 01 févr. 2006
    Livré le 20 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The property k/a 1. f/h olympia t/n BGL31510 2. l/h olympia way hammersmith road london t/no's BGL23329 BGL23330 BGL23331 3. l/h earls court exhibition buildings (earls COURT1) warwick road london t/n LN176409 for further details of property charged please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 20 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 11 févr. 2005
    Livré le 25 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H olympia exhibition hall hammersmith road london t/n BGL31510 l/h olympia way hammersmith road london t/n bgl 3329 BGL23330 BGL23331 l/h earls court exhibition (earls court 1) warwick road london t/n LN176409 for further details of the properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transactions
    • 25 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental legal charge which supplements the debenture dated 7 may 2004
    Créé le 11 févr. 2005
    Livré le 23 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H premises k/a olympia exhibition halls hammersmith road london t/no BGL31510 together with all buildings fixtures and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nomura International PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries) (Thesecurity Agent)
    Transactions
    • 23 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 mai 2004
    Livré le 11 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from such chargor to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nomura International PLC (As Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 11 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over account
    Créé le 28 juin 2000
    Livré le 30 juin 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the chargor to any of the secured parties under or pursuant to any of the financing documents (including for the avoidance of doubt, the charge).
    Brèves mentions
    All the company's right title benefit and interest in and to the account including, without limitation, the balances standing to the credit of the charged account from time to time and at any time charged account being numbrer 1009702 in the name of the company held with credit suisse first boston 5 cabot square london designated ecog-poex/br disposal proceeds account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston
    Transactions
    • 30 juin 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Keyman insurance assignment
    Créé le 22 déc. 1999
    Livré le 29 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties (as defined) (the "security trustee") under or pursuant to all or any of the financing documents (as defined)
    Brèves mentions
    The policies and the proceeds and the full benefit thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston
    Transactions
    • 29 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 30 sept. 1999
    Livré le 13 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company formerly known as hexagon 237 limited to the chargee under or pursuant to any of the financing documents
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Security Trustee)
    Transactions
    • 13 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    OLYMPIA GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    01 oct. 2018Commencement of winding up
    21 mai 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ian Harvey Dean
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    practitioner
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Stephen Roland Browne
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    practitioner
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0