SPORT MEDIA GROUP PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSPORT MEDIA GROUP PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 03769328
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SPORT MEDIA GROUP PLC ?

    • (2212) /

    Où se situe SPORT MEDIA GROUP PLC ?

    Adresse du siège social
    BDO LLP
    3 Hardman Street
    M3 3AT Manchester
    Greater Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SPORT MEDIA GROUP PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INTERACTIVE WORLD PUBLIC LIMITED COMPANY06 avr. 200606 avr. 2006
    FREE4INTERNET.NET LIMITED12 mai 199912 mai 1999

    Quels sont les derniers comptes de SPORT MEDIA GROUP PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SPORT MEDIA GROUP PLC ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour SPORT MEDIA GROUP PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de compte final avant dissolution

    1 pages4.43

    Dépôt d'insolvabilité

    INSOLVENCY:Progress report ends 22/03/2015
    12 pagesLIQ MISC

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:progress report end: 22/03/2014
    10 pagesLIQ MISC

    Nomination d'un administrateur

    2.12B

    Nomination d'un liquidateur

    1 pages4.31

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    4 pagesCOCOMP

    legacy

    3 pagesMG02

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 03 oct. 2011

    24 pages2.24B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B/2.15B

    13 pages2.16B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    2 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    66 pages2.17B

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Changement d'adresse du siège social de * 19 Great Ancoats Street Manchester M60 4BT* le 12 avr. 2011

    2 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Robert Johnson en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    30 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2009

    62 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 mai 2010 avec liste étendue des actionnaires

    19 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 juil. 2010

    État du capital au 05 juil. 2010

    • Capital: GBP 247,105.9575
    SH01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    2 pagesAD02

    Nomination de Mr Robert Neil Johnson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr William Martin Robinson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Neil Gordon Robertson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Qui sont les dirigeants de SPORT MEDIA GROUP PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ROBERTSON, Neil Gordon
    5 Willow Road
    Uppermill
    OL3 6JP Oldham
    Secrétaire
    5 Willow Road
    Uppermill
    OL3 6JP Oldham
    BritishAccountant55874680002
    BAILEY, David John
    Woodspeen Lodge
    Woodspeen
    RG20 8BS Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Woodspeen Lodge
    Woodspeen
    RG20 8BS Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director2914140001
    FICKLING, Andrew
    46a Greenleach Lane
    Worsley
    M28 2RG Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    46a Greenleach Lane
    Worsley
    M28 2RG Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector118192470001
    MADDOCK, John Malcolm
    37 The Avenue
    M33 4PJ Sale
    Cheshire
    Administrateur
    37 The Avenue
    M33 4PJ Sale
    Cheshire
    BritishDirector20168510001
    ROBERTSON, Neil Gordon
    Hardman Street
    M3 3AT Manchester
    3
    Greater Manchester
    Administrateur
    Hardman Street
    M3 3AT Manchester
    3
    Greater Manchester
    EnglandBritishAccountant55874680002
    ROBINSON, William Martin
    Hardman Street
    M3 3AT Manchester
    3
    Greater Manchester
    Administrateur
    Hardman Street
    M3 3AT Manchester
    3
    Greater Manchester
    Great BritainBritishCompany Director76608610001
    FLETCHER, Andrew Peter
    57 Tunnel Wood Road
    WD17 4GD Watford
    Secrétaire
    57 Tunnel Wood Road
    WD17 4GD Watford
    United KingdomChief Financial Officer55880920002
    MADDOCK, Keith John
    35 Norden Way
    Norden
    OL11 5TD Rochdale
    Lancashire
    Secrétaire
    35 Norden Way
    Norden
    OL11 5TD Rochdale
    Lancashire
    BritishDirector60277330001
    SULLIVAN, Clive
    Albyns Hall
    Albyns Lane, Stapleford Tawney
    RM4 1RS Romford
    Essex
    Secrétaire
    Albyns Hall
    Albyns Lane, Stapleford Tawney
    RM4 1RS Romford
    Essex
    BritishConsultant13521830002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BLYTHE TINKER, Nigel Edwin
    Fenn Farm Road
    Great Henny
    CO10 7NN Sudbury
    Henny Farm
    Suffolk
    Administrateur
    Fenn Farm Road
    Great Henny
    CO10 7NN Sudbury
    Henny Farm
    Suffolk
    BritishDirector112185800002
    CRACKNELL, Nicholas
    Hillside
    Duckington
    SY14 8LH Malpas
    Cheshire
    Administrateur
    Hillside
    Duckington
    SY14 8LH Malpas
    Cheshire
    BritishDirector67745460001
    FLETCHER, Andrew Peter
    57 Tunnel Wood Road
    WD17 4GD Watford
    Administrateur
    57 Tunnel Wood Road
    WD17 4GD Watford
    EnglandUnited KingdomAccountant55880920002
    HUME KENDALL, Simon Patrick
    The Oast House
    Lamberhurst Vineyard
    TN3 8ER Lamberhurst
    Kent
    Administrateur
    The Oast House
    Lamberhurst Vineyard
    TN3 8ER Lamberhurst
    Kent
    KentBritishDirector107579300001
    JOHNSON, Robert Neil
    Great Ancoats Street
    M60 4BT Manchester
    19
    Administrateur
    Great Ancoats Street
    M60 4BT Manchester
    19
    EnglandBritishDirector111394290001
    JOHNSON, Robert Neil
    Sheepcote Farmhouse
    Sheepcote Lane
    BR5 4ET Orpington
    Kent
    Administrateur
    Sheepcote Farmhouse
    Sheepcote Lane
    BR5 4ET Orpington
    Kent
    EnglandBritishManaging Director111394290001
    MADDOCK, Keith John
    35 Norden Way
    Norden
    OL11 5TD Rochdale
    Lancashire
    Administrateur
    35 Norden Way
    Norden
    OL11 5TD Rochdale
    Lancashire
    BritishDirector60277330001
    SULLIVAN, Clive
    Albyns Hall
    Albyns Lane, Stapleford Tawney
    RM4 1RS Romford
    Essex
    Administrateur
    Albyns Hall
    Albyns Lane, Stapleford Tawney
    RM4 1RS Romford
    Essex
    United KingdomBritishConsultant13521830002
    SULLIVAN, David
    Birch Hall Coppice Row
    Theydon Bois
    CM16 7DR Epping
    Essex
    Administrateur
    Birch Hall Coppice Row
    Theydon Bois
    CM16 7DR Epping
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director34611830001

    SPORT MEDIA GROUP PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 08 mai 2009
    Livré le 15 mai 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Gold Group International Limited
    Transactions
    • 15 mai 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 08 mai 2009
    Livré le 13 mai 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & equipment see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Roldvale Limited
    Transactions
    • 13 mai 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 04 avr. 2008
    Livré le 12 avr. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Gold Group International Limited
    Transactions
    • 12 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 avr. 2008
    Fixed and floating charge
    Créé le 21 déc. 2007
    Livré le 05 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 05 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 21 déc. 2007
    Livré le 29 déc. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 03 sept. 2007
    Livré le 14 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,000,000 due or to become due from the company to
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • David Sullivan, Ralph Gold and David Gold
    Transactions
    • 14 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 sept. 2007
    Livré le 13 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,000,000 due or to become due from the company formerly k/a intereactive world PLC to the chargee
    Personnes ayant droit
    • David Sullivan, Ralph Gold and David Gold
    Transactions
    • 13 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SPORT MEDIA GROUP PLC a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    04 avr. 2011Administration started
    23 mars 2012Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Dermot Justin Power
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    practitioner
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Patrick Alexander Lannagan
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    practitioner
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    2
    DateType
    17 juin 2015Conclusion of winding up
    21 mars 2012Petition date
    23 mars 2012Commencement of winding up
    25 sept. 2015Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    practitioner
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Patrick Alexander Lannagan
    3 Hardman Street
    M3 3AT Manchester
    practitioner
    3 Hardman Street
    M3 3AT Manchester
    Dermot Justin Power
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    practitioner
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0