STREAMFOODS LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTREAMFOODS LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03771000
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STREAMFOODS LTD ?

    • Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. (10890) / Industries manufacturières

    Où se situe STREAMFOODS LTD ?

    Adresse du siège social
    40 Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    Northamptonshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de STREAMFOODS LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour STREAMFOODS LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Nomination de Mr Deon Joubert en tant que secrétaire le 03 févr. 2023

    2 pagesAP03

    Nomination de Mr Deon Joubert en tant qu'administrateur le 03 févr. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Steven Daniel Goodes en tant que directeur le 03 févr. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Felix Lombard en tant que directeur le 03 févr. 2023

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 037710000013 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 mai 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    22 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 mai 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    État du capital au 21 avr. 2021

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Reduce share prem a/c 24/12/2020
    RES13

    Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2020 au 31 déc. 2020

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 14 mai 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Thushen Agambaram Govender en tant que directeur le 30 avr. 2020

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2019

    35 pagesAA

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2018

    34 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de STREAMFOODS LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GOODES, Steven Daniel
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    Secrétaire
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    236744200001
    JOUBERT, Deon
    Sanitarium Drive
    Berkeley Vale
    1
    New South Wales 2261
    Australia
    Secrétaire
    Sanitarium Drive
    Berkeley Vale
    1
    New South Wales 2261
    Australia
    305129160001
    JOUBERT, Deon
    Sanitarium Drive
    Berkeley Vale
    1
    New South Wales 2261
    Australia
    Administrateur
    Sanitarium Drive
    Berkeley Vale
    1
    New South Wales 2261
    Australia
    AustraliaAustralian305129060001
    THORN, Jonathon Wilhelm
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    Administrateur
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    EnglandBritish211294420001
    CRAIG, Andrea Harvey, Ms.
    Noak 4 Brow Of The Hill
    Leziate
    PE32 1EN Kings Lynn
    Norfolk
    Secrétaire
    Noak 4 Brow Of The Hill
    Leziate
    PE32 1EN Kings Lynn
    Norfolk
    British59469810001
    DING, Alison
    Westfield Rise Wormegay Road
    Blackborough End
    PE32 1SG Kings Lynn
    Norfolk
    Secrétaire
    Westfield Rise Wormegay Road
    Blackborough End
    PE32 1SG Kings Lynn
    Norfolk
    British58359950001
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British68848420004
    LANE, Mark John
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    Secrétaire
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    British151305720001
    THORN, Jonathon Wilhelm
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    Secrétaire
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    211303240001
    RM REGISTRARS LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Secrétaire désigné
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900000760001
    CHARLES, Gavin
    Westfield
    Gipsy Lane
    RG40 2HP Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    Westfield
    Gipsy Lane
    RG40 2HP Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritish120029860002
    DING, Ian Charles
    West Field Rise Wormegay Road
    Blackborough End
    PE32 1SG Kings Lynn
    Norfolk
    Administrateur
    West Field Rise Wormegay Road
    Blackborough End
    PE32 1SG Kings Lynn
    Norfolk
    EnglandBritish58359910001
    GLEN, Frederick Nairn
    The Well House
    RG7 2DJ Stratfield Saye
    Berkshire
    Administrateur
    The Well House
    RG7 2DJ Stratfield Saye
    Berkshire
    United KingdomBritish72400610001
    GOODES, Steven Daniel
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    Administrateur
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    EnglandBritish236743890001
    GOODING, Belinda
    16 Boxgrove Avenue
    GU1 1XG Guildford
    Surrey
    Administrateur
    16 Boxgrove Avenue
    GU1 1XG Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish109456400002
    GORDON, Alan George
    26 Wiverton Road
    SE26 5HY London
    Administrateur
    26 Wiverton Road
    SE26 5HY London
    British42882550001
    GOVENDER, Thushen Agambaram
    Building 1, Sliver Stream Business Park
    10 Muswell Road
    Bryanston
    Ground Floor
    South Africa
    Administrateur
    Building 1, Sliver Stream Business Park
    10 Muswell Road
    Bryanston
    Ground Floor
    South Africa
    South AfricaSouth African186889770001
    GUEST, Christopher Robert
    The Manor House
    Thorpe By Water
    LE15 9JQ Uppingham
    Leicestershire
    Administrateur
    The Manor House
    Thorpe By Water
    LE15 9JQ Uppingham
    Leicestershire
    British31438630001
    HILES, John Matthews
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    Administrateur
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    EnglandBritish173954820001
    LANE, Mark John
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    Administrateur
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    EnglandBritish132183700002
    LOMBARD, Felix
    Glacier Place
    1 Sportica Cresent
    Tygervalley 7530
    Pioneer Foods
    South Africa
    Administrateur
    Glacier Place
    1 Sportica Cresent
    Tygervalley 7530
    Pioneer Foods
    South Africa
    South AfricaSouth African238998300001
    MAGEE, Gerard Vincent
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    Administrateur
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    IrelandIrish151272980001
    MCGILL, John
    Tiefields
    New Drove
    PE14 4UA Northbrink
    Cambs
    Administrateur
    Tiefields
    New Drove
    PE14 4UA Northbrink
    Cambs
    British72400780001
    MYBURGH, Corni
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    Administrateur
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    South AfricaSouth African236784340001
    NEWBERRY, Paul David
    White Lodge
    Maywood Drive, Portsmouth Road
    GU15 1LH Camberley
    Surrey
    Administrateur
    White Lodge
    Maywood Drive, Portsmouth Road
    GU15 1LH Camberley
    Surrey
    EnglandBritish69243720001
    O'CONNOR, Philip Stephen
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Administrateur
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    EnglandIrish107745290001
    TOOMEY, John Francis
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Administrateur
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    EnglandIrish164624980001
    RM NOMINEES LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Administrateur désigné
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900009140001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur STREAMFOODS LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    England
    29 juil. 2016
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement04080435
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    STREAMFOODS LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 12 août 2016
    Livré le 18 août 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    1) registered trademark: aneeq, registration number 2543822, filing date 31/03/2010, classes 29 and 30. 2) registered trademark: aroi, registration number 2543826, filing date 31/03/2010, classes 29 and 30. any additional intellectual property - see deed for further details.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 18 août 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 25 janv. 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    A supplemental deed
    Créé le 13 janv. 2010
    Livré le 14 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 14 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 20 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite debenture
    Créé le 24 déc. 2009
    Livré le 08 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge over any right title or interest in any land and all shareas related rights and all distribution rights thereon; all investments and related rights all book debts benefits and security thereon; all non trading debts and all benefits rights and security thereunder; fixed charge over all amounts standing to the credit of each account and any other amount; all property rights all fees royalties and other rights thereon; the goodwill and uncalled capital and benefit of all authorisations held in relation to any security interest; all insurances and floating charge over all undertaking and assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 08 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 20 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security accession deed
    Créé le 14 janv. 2009
    Livré le 27 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Units a,b and c broadend industrial estate (also known as unit 5) t/no NK328879; fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Agent and Trustee for Itself and the Finance Parties)
    Transactions
    • 27 janv. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental deed
    Créé le 14 mars 2008
    Livré le 31 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Trustee for the Finance Parties) (the Security Trustee)
    Transactions
    • 31 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security accession deed to a debenture dated 7 september 2006 and
    Créé le 28 févr. 2007
    Livré le 08 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Trustee for the Finance Parties) (Securitytrustee)
    Transactions
    • 08 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 20 déc. 2005
    Livré le 29 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 23 sept. 2005
    Livré le 29 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £9,693.75 due or to become due from the company to
    Brèves mentions
    All of its right and entitlement to the funds held in the deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Beverley Patricia Emden
    Transactions
    • 29 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 14 juin 2005
    Livré le 27 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £8,812.50 due or to become due from the company to
    Brèves mentions
    By way of first fixed legal charge all its right and entitlement to the deposit account from time to time and all interest cerdited to the deposit account.
    Personnes ayant droit
    • Beverley Patricia Emden
    Transactions
    • 27 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 20 avr. 2005
    Livré le 05 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The property k/a units a b & c broadend road industrial estate walsoken wisbech cambs. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 27 août 2004
    Livré le 03 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the plant, machinery, chattels or other equipment being, make line 3 fruit paste bar, model extruding machine, make cartoner, serial no 03-193's, make checkweighter, serial no B2319. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 13 déc. 2000
    Livré le 15 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 oct. 2000
    Livré le 11 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0