PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03772667 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED ?
| Adresse du siège social | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gary Robert Barnes en tant que directeur le 21 nov. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 18 mai 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Charles Powell en tant que directeur le 03 mai 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy Julian Rice en tant que directeur le 24 sept. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 18 mai 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Gary Robert Barnes en tant qu'administrateur le 01 avr. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 26 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr David Joseph Clements en tant qu'administrateur le 12 oct. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Joseph Clements en tant que secrétaire le 15 juin 2017 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Philip Henry Walker en tant que secrétaire le 15 juin 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr Timothy Julian Rice en tant qu'administrateur le 05 juin 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon Alick Moore en tant qu'administrateur le 05 juin 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 18 mai 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Snook en tant que directeur le 29 mars 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 25 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 18 mai 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 25 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 18 mai 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 27 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Philip Henry Walker en tant que secrétaire le 03 nov. 2014 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Mr Philip Henry Walker en tant qu'administrateur le 03 nov. 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Mark Waller en tant que directeur le 03 nov. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEMENTS, David Joseph | Secrétaire | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | 233687120001 | |||||||
| CLEMENTS, David Joseph | Administrateur | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | England | British | 200768970001 | |||||
| MOORE, Simon Alick | Administrateur | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | England | British | 169812620001 | |||||
| WALKER, Philip Henry | Administrateur | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | England | British | 192548770001 | |||||
| WALKER, Philip Henry | Secrétaire | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | 192552730001 | |||||||
| WALLER, John Mark | Secrétaire | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | British | 8778550002 | ||||||
| WEST, James Crawshaw | Secrétaire | 103 Lower Road SL9 8JZ Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 29331030001 | ||||||
| OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED | Secrétaire | Level 1 Exchange House Primrose Street EC2A 2HS London | 2519400001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BARNES, Gary Robert | Administrateur | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | England | British | 244815210001 | |||||
| BARNETT, Calvin Stuart | Administrateur | 3 The Firs Stockbridge Road SO20 5BD Winchester Hampshire | England | British | 65673400001 | |||||
| DENHOLM, Ian Thomas | Administrateur | 4 Sunset Road Totton SO40 3JU Southampton Hampshire | British | 68340880002 | ||||||
| DENHOLM, Ian Thomas | Administrateur | The Old School Hemp Lane Wigginton HP23 6HF Tring Hertfordshire | British | 68340880001 | ||||||
| JEROME, David Leslie | Administrateur | 34 Collington Crescent PO6 4BH Portsmouth Hampshire | British | 61080770001 | ||||||
| JEROME, David Leslie | Administrateur | 34 Collington Crescent PO6 4BH Portsmouth Hampshire | British | 61080770001 | ||||||
| PENFOLD, Diane June | Administrateur | 43 Eagle Court Hermon Hill E11 1PD London | United Kingdom | British | 59962430002 | |||||
| POWELL, Christopher Charles | Administrateur | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | England | British | 264658290001 | |||||
| RICE, Timothy Julian | Administrateur | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | England | British | 219666070001 | |||||
| SNOOK, Christopher | Administrateur | Avalon 14 Whiteway View Stratton GL7 2HY Cirencester Gloucestershire | England | British | 81547090001 | |||||
| THOMPSON, Joseph John James | Administrateur | Underhill House Gretton GL54 5DA Cheltenham Gloucestershire | British | 43146240001 | ||||||
| WALLER, John Mark | Administrateur | Farriers House Naseby Road Thornby NN6 8SW Northampton Northamptonshire | England | British | 8778550002 | |||||
| WILSON, Clare Alice | Administrateur | 75 Ifield Road SW10 9AU London | British | 47611200001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennant International Group Plc | 06 avr. 2016 | Herrick Close Staverton Technology Park, Staverton GL51 6TL Cheltenham Pennant Court England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Charge of intellectual property | Créé le 26 mars 2003 Livré le 04 avr. 2003 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All rights,title and interest in and to the intellectual property rights excluding third party rights and all materials; the right to commence proceedings and/or receive and recover damages and all plant,machinery and equipment thereon; all book and other debts from time to time due to the company; first floating charge over the remaining undertaking,assets and business and all other rights,assets and property; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 13 févr. 2002 Livré le 19 févr. 2002 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H properties 2-10 cawte road 210-214 shirley road 1, 3, 5, 7 and 9 paynes road and land adjoining t/nos: HP154515 HP586655 HP518278 HP111751 HP428299 HP397993 HP238161 HP320808. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 21 déc. 1999 Livré le 23 déc. 1999 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 10 août 1999 Livré le 14 août 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 06 août 1999 Livré le 23 août 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 3 of the hive down agreement dated 6 august 1999 | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 06 août 1999 Livré le 14 août 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0