PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED

PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03772667
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED ?

    • Développement de logiciels professionnels et grand public (62012) / Information et communication

    Où se situe PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PENNANT INFORMATION SERVICES LIMITED21 janv. 200021 janv. 2000
    SOLVERA INFORMATION SERVICES (DOCUMENTATION) LIMITED28 juil. 199928 juil. 1999
    PRECIS (1761) LIMITED18 mai 199918 mai 1999

    Quels sont les derniers comptes de PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de Gary Robert Barnes en tant que directeur le 21 nov. 2019

    1 pagesTM01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 18 mai 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Christopher Charles Powell en tant que directeur le 03 mai 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Timothy Julian Rice en tant que directeur le 24 sept. 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 18 mai 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Gary Robert Barnes en tant qu'administrateur le 01 avr. 2018

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    26 pagesAA

    Nomination de Mr David Joseph Clements en tant qu'administrateur le 12 oct. 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr David Joseph Clements en tant que secrétaire le 15 juin 2017

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Philip Henry Walker en tant que secrétaire le 15 juin 2017

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Timothy Julian Rice en tant qu'administrateur le 05 juin 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Simon Alick Moore en tant qu'administrateur le 05 juin 2017

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 18 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Christopher Snook en tant que directeur le 29 mars 2017

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    25 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 mai 2016

    État du capital au 18 mai 2016

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    25 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 mai 2015

    État du capital au 18 mai 2015

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    27 pagesAA

    Nomination de Mr Philip Henry Walker en tant que secrétaire le 03 nov. 2014

    2 pagesAP03

    Nomination de Mr Philip Henry Walker en tant qu'administrateur le 03 nov. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de John Mark Waller en tant que directeur le 03 nov. 2014

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CLEMENTS, David Joseph
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    233687120001
    CLEMENTS, David Joseph
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish200768970001
    MOORE, Simon Alick
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish169812620001
    WALKER, Philip Henry
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish192548770001
    WALKER, Philip Henry
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    192552730001
    WALLER, John Mark
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    British8778550002
    WEST, James Crawshaw
    103 Lower Road
    SL9 8JZ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    103 Lower Road
    SL9 8JZ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British29331030001
    OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    Secrétaire
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    2519400001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARNES, Gary Robert
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish244815210001
    BARNETT, Calvin Stuart
    3 The Firs
    Stockbridge Road
    SO20 5BD Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    3 The Firs
    Stockbridge Road
    SO20 5BD Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish65673400001
    DENHOLM, Ian Thomas
    4 Sunset Road
    Totton
    SO40 3JU Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    4 Sunset Road
    Totton
    SO40 3JU Southampton
    Hampshire
    British68340880002
    DENHOLM, Ian Thomas
    The Old School Hemp Lane
    Wigginton
    HP23 6HF Tring
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Old School Hemp Lane
    Wigginton
    HP23 6HF Tring
    Hertfordshire
    British68340880001
    JEROME, David Leslie
    34 Collington Crescent
    PO6 4BH Portsmouth
    Hampshire
    Administrateur
    34 Collington Crescent
    PO6 4BH Portsmouth
    Hampshire
    British61080770001
    JEROME, David Leslie
    34 Collington Crescent
    PO6 4BH Portsmouth
    Hampshire
    Administrateur
    34 Collington Crescent
    PO6 4BH Portsmouth
    Hampshire
    British61080770001
    PENFOLD, Diane June
    43 Eagle Court
    Hermon Hill
    E11 1PD London
    Administrateur
    43 Eagle Court
    Hermon Hill
    E11 1PD London
    United KingdomBritish59962430002
    POWELL, Christopher Charles
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish264658290001
    RICE, Timothy Julian
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish219666070001
    SNOOK, Christopher
    Avalon 14 Whiteway View
    Stratton
    GL7 2HY Cirencester
    Gloucestershire
    Administrateur
    Avalon 14 Whiteway View
    Stratton
    GL7 2HY Cirencester
    Gloucestershire
    EnglandBritish81547090001
    THOMPSON, Joseph John James
    Underhill House
    Gretton
    GL54 5DA Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Underhill House
    Gretton
    GL54 5DA Cheltenham
    Gloucestershire
    British43146240001
    WALLER, John Mark
    Farriers House Naseby Road
    Thornby
    NN6 8SW Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Farriers House Naseby Road
    Thornby
    NN6 8SW Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish8778550002
    WILSON, Clare Alice
    75 Ifield Road
    SW10 9AU London
    Administrateur
    75 Ifield Road
    SW10 9AU London
    British47611200001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Herrick Close
    Staverton Technology Park, Staverton
    GL51 6TL Cheltenham
    Pennant Court
    England
    06 avr. 2016
    Herrick Close
    Staverton Technology Park, Staverton
    GL51 6TL Cheltenham
    Pennant Court
    England
    Non
    Forme juridiquePlc
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03187528
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge of intellectual property
    Créé le 26 mars 2003
    Livré le 04 avr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All rights,title and interest in and to the intellectual property rights excluding third party rights and all materials; the right to commence proceedings and/or receive and recover damages and all plant,machinery and equipment thereon; all book and other debts from time to time due to the company; first floating charge over the remaining undertaking,assets and business and all other rights,assets and property; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 13 févr. 2002
    Livré le 19 févr. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H properties 2-10 cawte road 210-214 shirley road 1, 3, 5, 7 and 9 paynes road and land adjoining t/nos: HP154515 HP586655 HP518278 HP111751 HP428299 HP397993 HP238161 HP320808.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 21 déc. 1999
    Livré le 23 déc. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 10 août 1999
    Livré le 14 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Gmac Commercial Credit Limited
    Transactions
    • 14 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 06 août 1999
    Livré le 23 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 3 of the hive down agreement dated 6 august 1999
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Solvera Information Services Limited
    Transactions
    • 23 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 06 août 1999
    Livré le 14 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Solvera PLC(In Administration)
    Transactions
    • 14 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0