ROTHERCROFT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéROTHERCROFT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03780903
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ROTHERCROFT LIMITED ?

    • Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques n.c.a. (74909) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe ROTHERCROFT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Recovery House Hainault Business Park
    15-17 Roebuck Road
    IG6 3TU Ilford
    Essex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ROTHERCROFT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TROTWOOD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED12 janv. 200112 janv. 2001
    REMNUT AND NAVONOD PROPERTIES LIMITED13 juil. 199913 juil. 1999
    FIELDFORD PROPERTIES LTD02 juin 199902 juin 1999

    Quels sont les derniers comptes de ROTHERCROFT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour ROTHERCROFT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    19 pagesLIQ14

    Changement d'adresse du siège social de Lgj House Knowles Farm Estate Wycke Hill Maldon Essex CM9 6SH England à Recovery House Hainault Business Park 15-17 Roebuck Road Ilford Essex IG6 3TU le 10 déc. 2019

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires

    10 pagesLIQ02

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 02 déc. 2019

    LRESEX

    Satisfaction de la charge 037809030012 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes de micro-entité établis au 31 août 2018

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Inscription de la charge 037809030012, créée le 28 sept. 2018

    11 pagesMR01

    Comptes de micro-entité établis au 31 août 2017

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    4 pagesMR04

    Changement d'adresse du siège social de The Stables, Baddow Park, West Hanningfield Road Great Baddow Chelmsford Essex CM2 7SY England à Lgj House Knowles Farm Estate Wycke Hill Maldon Essex CM9 6SH le 09 août 2017

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2016

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de ROTHERCROFT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TUNMER, Laura Beverley Jennifer
    Hainault Business Park
    15-17 Roebuck Road
    IG6 3TU Ilford
    Recovery House
    Essex
    Administrateur
    Hainault Business Park
    15-17 Roebuck Road
    IG6 3TU Ilford
    Recovery House
    Essex
    EnglandBritishCompany Director149035680001
    TUNMER, Robert John
    West House
    2 Clarence Gate Repton Park
    IG8 8GN Woodford Green
    Essex
    Secrétaire
    West House
    2 Clarence Gate Repton Park
    IG8 8GN Woodford Green
    Essex
    BritishDirector38480850004
    CHEVERHALL LIMITED
    Baddow Park
    West Hanningfield Road Great Baddow
    CM2 7SY Chelmsford
    The Coach House
    Essex
    United Kingdom
    Secrétaire
    Baddow Park
    West Hanningfield Road Great Baddow
    CM2 7SY Chelmsford
    The Coach House
    Essex
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement05143742
    140665100001
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Secrétaire désigné
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900014000001
    AMBROSE, Stephen
    7 Wentworth Close
    Hatfield Peverel
    CM3 2JS Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    7 Wentworth Close
    Hatfield Peverel
    CM3 2JS Chelmsford
    Essex
    BritishDirector51083880001
    DONOVAN, Peter Thomas
    15 Royston Avenue
    Noak Mead
    SS15 4EW Basildon
    Administrateur
    15 Royston Avenue
    Noak Mead
    SS15 4EW Basildon
    BritishContract Manager33690500002
    POWELL, Jane
    Canes Mill Court
    CM7 9AP Braintree
    5
    Essex
    Administrateur
    Canes Mill Court
    CM7 9AP Braintree
    5
    Essex
    EnglandBritishCompany Director134571520001
    SHARPE, Jason Adrian
    Beckingham Business Park, Beckingham Street
    Tolleshunt Major
    CM9 8LZ Maldon
    Swiss House
    Essex
    England
    Administrateur
    Beckingham Business Park, Beckingham Street
    Tolleshunt Major
    CM9 8LZ Maldon
    Swiss House
    Essex
    England
    EnglandBritishCompany Director139899860001
    TUNMER, Beverley Rose
    Baddow Park, West Hanningfield Road
    Great Baddow
    CM2 7SY Chelmsford
    The Coach House
    Essex
    England
    Administrateur
    Baddow Park, West Hanningfield Road
    Great Baddow
    CM2 7SY Chelmsford
    The Coach House
    Essex
    England
    EnglandBritishCompany Director187482890001
    TUNMER, Billy
    Beckingham Business Park, Beckingham Street
    Tolleshunt Major
    CM9 8LZ Maldon
    Swiss House
    Essex
    England
    Administrateur
    Beckingham Business Park, Beckingham Street
    Tolleshunt Major
    CM9 8LZ Maldon
    Swiss House
    Essex
    England
    EnglandBritishCompany Director158337390002
    TUNMER, Robert John
    2 Clarence Gate
    IG8 8GN Woodford Green
    West House
    Essex
    England
    Administrateur
    2 Clarence Gate
    IG8 8GN Woodford Green
    West House
    Essex
    England
    EnglandBritishCompany Director38480850004
    TUNMER, Robert John
    West House
    2 Clarence Gate Repton Park
    IG8 8GN Woodford Green
    Essex
    Administrateur
    West House
    2 Clarence Gate Repton Park
    IG8 8GN Woodford Green
    Essex
    EnglandBritishDirector38480850004
    TUNMER, Robert John
    Croftside Manor Road
    Lambourne End Abridge
    RM4 1NB Romford
    Essex
    Administrateur
    Croftside Manor Road
    Lambourne End Abridge
    RM4 1NB Romford
    Essex
    BritishDirector38480850001
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Administrateur désigné
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900013990001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ROTHERCROFT LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Miss Laura Beverley Jennifer Tunmer
    Hainault Business Park
    15-17 Roebuck Road
    IG6 3TU Ilford
    Recovery House
    Essex
    01 oct. 2016
    Hainault Business Park
    15-17 Roebuck Road
    IG6 3TU Ilford
    Recovery House
    Essex
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    ROTHERCROFT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 28 sept. 2018
    Livré le 02 oct. 2018
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All freehold and leasehold land and buildings of the chargor both at the date of the charge and future and all trade fixtures and fittings and all plant and machinery from time to time in or on such land or buildings. All intellectual property at the date of the charge owned or at any time hereafter to be owned by the chargor.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Sme Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 02 oct. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 20 nov. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 31 oct. 2003
    Livré le 06 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1 chipping lodge western road romford essex. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 28 avr. 2003
    Livré le 09 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    93 lockside marina chelmsford essex. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 28 mars 2003
    Livré le 29 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    133 burrow road hainault essex. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 28 nov. 2002
    Livré le 12 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    31 manford cross, hainault ilford essex t/n EGL237009. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 16 mai 2002
    Livré le 24 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    4 cedrus court primrose hill chelmsford storage cupboard and parking space. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 24 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 15 oct. 2001
    Livré le 05 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/Hold property known as 42 railway st,chelmsford,essex; ex 657888. and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 22 déc. 2000
    Livré le 06 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The leasehold property known as 69 trotwood chigwell essex title number EX287208. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 janv. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 20 oct. 2000
    Livré le 01 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The leasehold property known as 45 trotwood chigwell essex, title number ex 276143. and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 18 oct. 2000
    Livré le 24 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 30A shakespeare road romford essex t/no.EGL338679. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 24 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 15 sept. 2000
    Livré le 19 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    16 trotwood chigwell essex london borough of havering; ex 267639; the goodwill of business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 19 nov. 1999
    Livré le 23 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 30 shakespeare road romford essex t/n EGL338679. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 23 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 sept. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ROTHERCROFT LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    02 déc. 2019Commencement of winding up
    23 sept. 2020Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Alan John Clark
    Carter Clark Recovery House
    15-17 Roebuck Road, Hainault Business Park
    IG6 3TU Ilford
    Essex
    practitioner
    Carter Clark Recovery House
    15-17 Roebuck Road, Hainault Business Park
    IG6 3TU Ilford
    Essex

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0