AUTOMOTIVE UK NO.1

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAUTOMOTIVE UK NO.1
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité illimitée
    Numéro de société 03785354
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AUTOMOTIVE UK NO.1 ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe AUTOMOTIVE UK NO.1 ?

    Adresse du siège social
    Griffin House Uk1-101-135 Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Bedfordshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AUTOMOTIVE UK NO.1 ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GM AUTOMOTIVE UK25 juin 199925 juin 1999
    CATSHAPE LIMITED09 juin 199909 juin 1999

    Quels sont les derniers comptes de AUTOMOTIVE UK NO.1 ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour AUTOMOTIVE UK NO.1 ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Période comptable actuelle raccourcie du 30 juin 2019 au 31 déc. 2018

    1 pagesAA01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share prem a/c 30/11/2018
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Stefan Fesser en tant que directeur le 30 juin 2018

    1 pagesTM01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2017 au 30 juin 2018

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 09 juin 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de David Borland en tant que directeur le 28 févr. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Stephen Norman en tant qu'administrateur le 01 févr. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Rory Vincent Harvey en tant que directeur le 10 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Modification des détails de General Motors Company en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 juil. 2017

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de Griffin House Uk1-101-135 Osborne Road Luton Bedfordshire LU1 3YT à Griffin House Uk1-101-135 Osborne Road Luton Bedfordshire LU1 3YT le 21 août 2017

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Christopher Thexton en tant que directeur le 31 juil. 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 09 juin 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 août 2016

    État du capital au 17 août 2016

    • Capital: GBP 1,512,585,758
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    16 pagesAA

    Cessation de la nomination de Alfred Kamanja Kibe en tant que directeur le 18 déc. 2015

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher Thexton le 09 sept. 2015

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr James Charles Highnam en tant qu'administrateur le 01 déc. 2015

    2 pagesAP01

    Deuxième dépôt de AP01 précédemment soumis à Companies House

    5 pagesRP04
    Annotations
    DateAnnotation
    06 nov. 2015Clarification Second filing AP01 for Alfred Kibe.

    Nomination de Mr Rory Harvey en tant qu'administrateur le 23 sept. 2015

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de AUTOMOTIVE UK NO.1 ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NAGI, Rabiya Sultana
    29 Winton Avenue
    N11 2AS London
    Secrétaire
    29 Winton Avenue
    N11 2AS London
    British29667260003
    HIGHNAM, James Charles
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    Bedfordshire
    England
    Administrateur
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    Bedfordshire
    England
    FranceBritish203514510001
    HOPE, Peter Thomas
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    Bedfordshire
    England
    Administrateur
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish191426120001
    NORMAN, Stephen
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    Bedfordshire
    England
    Administrateur
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    Bedfordshire
    England
    FranceFrench243325520001
    WRIGHT, Michael
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk 1-101-135
    Bedfordshire
    England
    Administrateur
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk 1-101-135
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish169818050001
    BENJAMIN, Keith John
    35 Queens Road
    AL5 1QW Harpenden
    Hertfordshire
    Secrétaire
    35 Queens Road
    AL5 1QW Harpenden
    Hertfordshire
    British34539180002
    HALL, Mark Dennis
    Flat 5 156 Sutherland Avenue
    W9 1HP London
    Secrétaire
    Flat 5 156 Sutherland Avenue
    W9 1HP London
    British64866740002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ALDRED, Duncan Neil
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Bedfordshire
    Administrateur
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Bedfordshire
    EnglandBritish148250160001
    BENJAMIN, Keith John
    77 Northumberland Road
    CV32 6HQ Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    77 Northumberland Road
    CV32 6HQ Leamington Spa
    Warwickshire
    United KingdomBritish34539180005
    BLACKWELL, Richard John
    26 The Close
    AL5 3NB Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    26 The Close
    AL5 3NB Harpenden
    Hertfordshire
    British73111380001
    BORLAND, David
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Bedfordshire
    England
    Administrateur
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish181024620001
    BRANSTON, Giles Winthorpe
    Brookfield
    Highgate West Hill
    N6 6AT London
    35
    Administrateur
    Brookfield
    Highgate West Hill
    N6 6AT London
    35
    United KingdomBritish136881450001
    BURKUTEAN, Harry Gunther
    20c Douglas Road
    AL5 2EW Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    20c Douglas Road
    AL5 2EW Harpenden
    Hertfordshire
    German74805050001
    CRAY, Martyn
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    Bedfordshire
    England
    Administrateur
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    Bedfordshire
    England
    United KingdomBritish94376250001
    DOYLE, Elizabeth Katherine
    Hopwood House
    Therfield
    SG8 9PT Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    Hopwood House
    Therfield
    SG8 9PT Royston
    Hertfordshire
    British105256290001
    FESSER, Stefan
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    Bedfordshire
    Administrateur
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    Bedfordshire
    EnglandGerman185749240001
    FRAGOSO, Miguel
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    Bedfordshire
    England
    Administrateur
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish138074880002
    FRANCAVILLA, Antonio
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Bedfordshire
    Administrateur
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Bedfordshire
    UkAmerican Canadian150485030001
    FULCHER, John Robert
    101-135 Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House
    Bedfordshire
    England
    Administrateur
    101-135 Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish76025290001
    GALVIN, Lesley
    49 Bradbourne Vale Road
    TN13 3QG Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    49 Bradbourne Vale Road
    TN13 3QG Sevenoaks
    Kent
    British84807040001
    GALVIN, Lesley
    49 Bradbourne Vale Road
    TN13 3QG Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    49 Bradbourne Vale Road
    TN13 3QG Sevenoaks
    Kent
    British84807040001
    GILSON, Andrew Robert
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Bedfordshire
    Administrateur
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Bedfordshire
    EnglandBritish153325350001
    HALL, Mark Dennis
    Flat 5 156 Sutherland Avenue
    W9 1HP London
    Administrateur
    Flat 5 156 Sutherland Avenue
    W9 1HP London
    EnglandBritish64866740002
    HARVEY, Rory Vincent
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    Bedfordshire
    England
    Administrateur
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    Bedfordshire
    England
    GermanyBritish202453920001
    JUNG, Werner Heinrich
    28 St Stephens Avenue
    AL3 4AD St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    28 St Stephens Avenue
    AL3 4AD St Albans
    Hertfordshire
    German59090000003
    KIBE, Alfred Kamanja
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    Bedfordshire
    England
    Administrateur
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    Bedfordshire
    England
    EnglandAmerican201392050001
    MCCRUM, David
    50 Rylett Road
    W12 9ST London
    Administrateur
    50 Rylett Road
    W12 9ST London
    British24283060003
    MILLWARD, Philip
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Bedfordshire
    Administrateur
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Bedfordshire
    EnglandBritish84519620002
    MOLYNEUX, Richard John
    Bowers Way
    AL5 4EP Harpenden
    7
    Hertfordshire
    Administrateur
    Bowers Way
    AL5 4EP Harpenden
    7
    Hertfordshire
    United KingdomBritish310811830001
    PARFITT, Christopher William
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Bedfordshire
    Administrateur
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Bedfordshire
    EnglandBritish77006150003
    REILLY, David Nicholas
    Crowholt George Street
    Woburn
    MK17 9PX Milton Keynes
    Administrateur
    Crowholt George Street
    Woburn
    MK17 9PX Milton Keynes
    British51668350005
    STEELE, Andrew, Dr
    2 Cambridge Road
    Fowlmere
    SG8 7QN Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 Cambridge Road
    Fowlmere
    SG8 7QN Royston
    Hertfordshire
    British83746840001
    THEXTON, Christopher
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    General Motors Uk Limited
    Bedfordshire
    England
    Administrateur
    Griffin House Uk1-101-135
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    General Motors Uk Limited
    Bedfordshire
    England
    EnglandSouth African199560520002
    TOZER, Timothy David
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    Bedfordshire
    England
    Administrateur
    Osborne Road
    LU1 3YT Luton
    Griffin House Uk1-101-135
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish186137210002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur AUTOMOTIVE UK NO.1 ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Peugeot S.A.
    Rue Henri Sainte-Claire Déville
    92500
    Rueil-Malmaison
    7
    France
    06 avr. 2016
    Rue Henri Sainte-Claire Déville
    92500
    Rueil-Malmaison
    7
    France
    Non
    Forme juridiquePublic
    Pays d'enregistrementFrance
    Autorité légaleFrench Law
    Lieu d'enregistrementParis Trade And Companies Register
    Numéro d'enregistrement552 100 554 R.C.S.
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    AUTOMOTIVE UK NO.1 a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Share charge
    Créé le 07 juil. 2009
    Livré le 15 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge all present and future shares and dividends see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale
    Transactions
    • 15 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0