AUTOMOTIVE UK NO.1
Vue d'ensemble
| Nom de la société | AUTOMOTIVE UK NO.1 |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité illimitée |
| Numéro de société | 03785354 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe AUTOMOTIVE UK NO.1 ?
| Adresse du siège social | Griffin House Uk1-101-135 Osborne Road LU1 3YT Luton Bedfordshire England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de AUTOMOTIVE UK NO.1 ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour AUTOMOTIVE UK NO.1 ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 4 pages | DS01 | ||||||||||||||
Période comptable actuelle raccourcie du 30 juin 2019 au 31 déc. 2018 | 1 pages | AA01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Stefan Fesser en tant que directeur le 30 juin 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2017 au 30 juin 2018 | 1 pages | AA01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 juin 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de David Borland en tant que directeur le 28 févr. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Stephen Norman en tant qu'administrateur le 01 févr. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Rory Vincent Harvey en tant que directeur le 10 janv. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 4 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Avis de changement de nom" | 2 pages | CONNOT | ||||||||||||||
Modification des détails de General Motors Company en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 juil. 2017 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Griffin House Uk1-101-135 Osborne Road Luton Bedfordshire LU1 3YT à Griffin House Uk1-101-135 Osborne Road Luton Bedfordshire LU1 3YT le 21 août 2017 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Thexton en tant que directeur le 31 juil. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 juin 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 17 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 09 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 16 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Alfred Kamanja Kibe en tant que directeur le 18 déc. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher Thexton le 09 sept. 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr James Charles Highnam en tant qu'administrateur le 01 déc. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Deuxième dépôt de AP01 précédemment soumis à Companies House | 5 pages | RP04 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomination de Mr Rory Harvey en tant qu'administrateur le 23 sept. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de AUTOMOTIVE UK NO.1 ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGI, Rabiya Sultana | Secrétaire | 29 Winton Avenue N11 2AS London | British | 29667260003 | ||||||
| HIGHNAM, James Charles | Administrateur | Osborne Road LU1 3YT Luton Griffin House Uk1-101-135 Bedfordshire England | France | British | 203514510001 | |||||
| HOPE, Peter Thomas | Administrateur | Osborne Road LU1 3YT Luton Griffin House Uk1-101-135 Bedfordshire England | England | British | 191426120001 | |||||
| NORMAN, Stephen | Administrateur | Osborne Road LU1 3YT Luton Griffin House Uk1-101-135 Bedfordshire England | France | French | 243325520001 | |||||
| WRIGHT, Michael | Administrateur | Osborne Road LU1 3YT Luton Griffin House Uk 1-101-135 Bedfordshire England | England | British | 169818050001 | |||||
| BENJAMIN, Keith John | Secrétaire | 35 Queens Road AL5 1QW Harpenden Hertfordshire | British | 34539180002 | ||||||
| HALL, Mark Dennis | Secrétaire | Flat 5 156 Sutherland Avenue W9 1HP London | British | 64866740002 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ALDRED, Duncan Neil | Administrateur | Griffin House Uk1-101-135 Osborne Road LU1 3YT Luton Bedfordshire | England | British | 148250160001 | |||||
| BENJAMIN, Keith John | Administrateur | 77 Northumberland Road CV32 6HQ Leamington Spa Warwickshire | United Kingdom | British | 34539180005 | |||||
| BLACKWELL, Richard John | Administrateur | 26 The Close AL5 3NB Harpenden Hertfordshire | British | 73111380001 | ||||||
| BORLAND, David | Administrateur | Griffin House Uk1-101-135 Osborne Road LU1 3YT Luton Bedfordshire England | England | British | 181024620001 | |||||
| BRANSTON, Giles Winthorpe | Administrateur | Brookfield Highgate West Hill N6 6AT London 35 | United Kingdom | British | 136881450001 | |||||
| BURKUTEAN, Harry Gunther | Administrateur | 20c Douglas Road AL5 2EW Harpenden Hertfordshire | German | 74805050001 | ||||||
| CRAY, Martyn | Administrateur | Osborne Road LU1 3YT Luton Griffin House Uk1-101-135 Bedfordshire England | United Kingdom | British | 94376250001 | |||||
| DOYLE, Elizabeth Katherine | Administrateur | Hopwood House Therfield SG8 9PT Royston Hertfordshire | British | 105256290001 | ||||||
| FESSER, Stefan | Administrateur | Osborne Road LU1 3YT Luton Griffin House Uk1-101-135 Bedfordshire | England | German | 185749240001 | |||||
| FRAGOSO, Miguel | Administrateur | Osborne Road LU1 3YT Luton Griffin House Uk1-101-135 Bedfordshire England | England | British | 138074880002 | |||||
| FRANCAVILLA, Antonio | Administrateur | Griffin House Uk1-101-135 Osborne Road LU1 3YT Luton Bedfordshire | Uk | American Canadian | 150485030001 | |||||
| FULCHER, John Robert | Administrateur | 101-135 Osborne Road LU1 3YT Luton Griffin House Bedfordshire England | England | British | 76025290001 | |||||
| GALVIN, Lesley | Administrateur | 49 Bradbourne Vale Road TN13 3QG Sevenoaks Kent | British | 84807040001 | ||||||
| GALVIN, Lesley | Administrateur | 49 Bradbourne Vale Road TN13 3QG Sevenoaks Kent | British | 84807040001 | ||||||
| GILSON, Andrew Robert | Administrateur | Griffin House Uk1-101-135 Osborne Road LU1 3YT Luton Bedfordshire | England | British | 153325350001 | |||||
| HALL, Mark Dennis | Administrateur | Flat 5 156 Sutherland Avenue W9 1HP London | England | British | 64866740002 | |||||
| HARVEY, Rory Vincent | Administrateur | Osborne Road LU1 3YT Luton Griffin House Uk1-101-135 Bedfordshire England | Germany | British | 202453920001 | |||||
| JUNG, Werner Heinrich | Administrateur | 28 St Stephens Avenue AL3 4AD St Albans Hertfordshire | German | 59090000003 | ||||||
| KIBE, Alfred Kamanja | Administrateur | Osborne Road LU1 3YT Luton Griffin House Uk1-101-135 Bedfordshire England | England | American | 201392050001 | |||||
| MCCRUM, David | Administrateur | 50 Rylett Road W12 9ST London | British | 24283060003 | ||||||
| MILLWARD, Philip | Administrateur | Griffin House Uk1-101-135 Osborne Road LU1 3YT Luton Bedfordshire | England | British | 84519620002 | |||||
| MOLYNEUX, Richard John | Administrateur | Bowers Way AL5 4EP Harpenden 7 Hertfordshire | United Kingdom | British | 310811830001 | |||||
| PARFITT, Christopher William | Administrateur | Griffin House Uk1-101-135 Osborne Road LU1 3YT Luton Bedfordshire | England | British | 77006150003 | |||||
| REILLY, David Nicholas | Administrateur | Crowholt George Street Woburn MK17 9PX Milton Keynes | British | 51668350005 | ||||||
| STEELE, Andrew, Dr | Administrateur | 2 Cambridge Road Fowlmere SG8 7QN Royston Hertfordshire | British | 83746840001 | ||||||
| THEXTON, Christopher | Administrateur | Griffin House Uk1-101-135 Osborne Road LU1 3YT Luton General Motors Uk Limited Bedfordshire England | England | South African | 199560520002 | |||||
| TOZER, Timothy David | Administrateur | Osborne Road LU1 3YT Luton Griffin House Uk1-101-135 Bedfordshire England | England | British | 186137210002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur AUTOMOTIVE UK NO.1 ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot S.A. | 06 avr. 2016 | Rue Henri Sainte-Claire Déville 92500 Rueil-Malmaison 7 France | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
AUTOMOTIVE UK NO.1 a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Share charge | Créé le 07 juil. 2009 Livré le 15 juil. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any obligor to the finance parties on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed charge all present and future shares and dividends see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0