TELIRIS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTELIRIS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03796511
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TELIRIS LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe TELIRIS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Laser House
    132 - 140 Goswell Road
    EC1V 7DY London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TELIRIS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GLOBAL INTERCASTING LIMITED05 juil. 199905 juil. 1999
    POINTCLAUSE LIMITED25 juin 199925 juin 1999

    Quels sont les derniers comptes de TELIRIS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour TELIRIS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 24 juil. 2017

    • Capital: GBP 0.02
    5 pagesSH19

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancellation of share premium account 24/07/2017
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 25 juin 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Notification de Dimension Data Holdings Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    1 pagesPSC02

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2015

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 juin 2016

    État du capital au 28 juin 2016

    • Capital: GBP 102,000
    SH01

    Nomination de Mr Yang Li en tant qu'administrateur le 10 févr. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr William Yong en tant qu'administrateur le 10 févr. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Barney Andrew Taylor en tant qu'administrateur le 10 févr. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ian Paul Heard en tant que directeur le 10 févr. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Scott Cornell Cruikshank en tant que directeur le 10 févr. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jonathan Andrew Brock en tant que directeur le 10 févr. 2016

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2014

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 juin 2015

    État du capital au 29 juin 2015

    • Capital: GBP 102,000
    SH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2013

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 août 2014

    État du capital au 19 août 2014

    • Capital: GBP 102,000
    SH01

    Nomination de Jonathan Andrew Brock en tant qu'administrateur le 06 mai 2014

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de 1 Swan Lane London EC4R 3TN England à Laser House 132 - 140 Goswell Road London EC1V 7DY le 18 août 2014

    1 pagesAD01

    Nomination de Scott Cornell Cruikshank en tant qu'administrateur le 06 mai 2014

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de TELIRIS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LI, Yang
    132 - 140 Goswell Road
    EC1V 7DY London
    Laser House
    Administrateur
    132 - 140 Goswell Road
    EC1V 7DY London
    Laser House
    EnglandBritish205206330001
    TAYLOR, Barney Andrew
    132 - 140 Goswell Road
    EC1V 7DY London
    Laser House
    Administrateur
    132 - 140 Goswell Road
    EC1V 7DY London
    Laser House
    EnglandBritish199377820001
    YONG, William
    132 - 140 Goswell Road
    EC1V 7DY London
    Laser House
    Administrateur
    132 - 140 Goswell Road
    EC1V 7DY London
    Laser House
    SingaporeSingaporean205168510001
    GLICKMAN, Richard Alan
    William Street
    Suite 1825
    10038 New York
    100
    New York
    Usa
    Secrétaire
    William Street
    Suite 1825
    10038 New York
    100
    New York
    Usa
    162072400001
    THOMSON, James Stewart
    3 Mead Way
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    Secrétaire
    3 Mead Way
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    British55415050001
    TRACHTENBERG, Marc
    Broadway
    NY 10006 New York
    55
    Usa
    Secrétaire
    Broadway
    NY 10006 New York
    55
    Usa
    Other124986270001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BROCK, Jonathan Andrew
    Clarke Street
    2030 Vaulcuse
    21a
    Nsw
    Australia
    Administrateur
    Clarke Street
    2030 Vaulcuse
    21a
    Nsw
    Australia
    AustraliaAustralian189089980001
    CRUIKSHANK, Scott Cornell
    Lake Boone Terrace
    Suite 200
    NC 27607 Raleigh
    4101
    Usa
    Administrateur
    Lake Boone Terrace
    Suite 200
    NC 27607 Raleigh
    4101
    Usa
    United StatesAmerican190228040001
    GREY, Rupert Christopher
    Hampshire Cottage
    South Harting
    GU31 5LP Petersfield
    Hampshire
    Administrateur
    Hampshire Cottage
    South Harting
    GU31 5LP Petersfield
    Hampshire
    EnglandBritish30429000001
    HEARD, Ian Paul
    Effra Road
    SW19 8PP London
    52
    United Kingdom
    Administrateur
    Effra Road
    SW19 8PP London
    52
    United Kingdom
    United KingdomBritish190214290001
    HOBBS, John Neil
    William Street
    Suite 1825
    10038 New York
    100
    New York
    Usa
    Administrateur
    William Street
    Suite 1825
    10038 New York
    100
    New York
    Usa
    United StatesAmerican162074130001
    INGLIS, John
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7DD London
    3
    United Kingdom
    Administrateur
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7DD London
    3
    United Kingdom
    ScotlandBritish162072190001
    LEWIS, Martyn John Dudley
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7DD London
    3
    United Kingdom
    Administrateur
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7DD London
    3
    United Kingdom
    EnglandBritish7277990003
    TENCH, Jeff
    William Street
    Suite 1825
    New York
    100
    New York 10038
    Usa
    Administrateur
    William Street
    Suite 1825
    New York
    100
    New York 10038
    Usa
    Usa ColoradoAmerican179011240003
    THOMSON, James Anthony, Dr
    30 Paradise Walk
    SW3 4JL London
    Administrateur
    30 Paradise Walk
    SW3 4JL London
    British63388730001
    THOMSON, James Stewart
    3 Mead Way
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    Administrateur
    3 Mead Way
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    British55415050001
    TRACHTENBERG, Marc
    Broadway
    NY 10006 New York
    55
    Usa
    Administrateur
    Broadway
    NY 10006 New York
    55
    Usa
    Other124986270001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TELIRIS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Dimension Data Holdings Plc
    Waterfront Business Park
    Fleet Road
    GU51 3QT Fleet
    Dimension Data House
    England
    06 avr. 2016
    Waterfront Business Park
    Fleet Road
    GU51 3QT Fleet
    Dimension Data House
    England
    Non
    Forme juridiquePublic Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementRegistrar Of Companies, England & Wales
    Numéro d'enregistrement3704278
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    TELIRIS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent deposit deed
    Créé le 14 janv. 2010
    Livré le 26 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The rent security deposit deed.
    Personnes ayant droit
    • Market Building Limited and the London Underwriting Centre Limited
    Transactions
    • 26 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 15 avr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage debenture
    Créé le 10 sept. 2009
    Livré le 30 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Silicon Valley Bank
    Transactions
    • 30 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 févr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Loan and security agreement
    Créé le 18 avr. 2008
    Livré le 01 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any credit party to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The collateral meaning all of the right title and interest in and to all goods, accounts, equipment, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Silicon Valley Bank
    Transactions
    • 01 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 févr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage debenture
    Créé le 18 avr. 2008
    Livré le 01 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Silicon Valley Bank
    Transactions
    • 01 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 févr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0