TYMEL WEST SCOTLAND

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTYMEL WEST SCOTLAND
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité illimitée
    Numéro de société 03804532
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TYMEL WEST SCOTLAND ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières
    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe TYMEL WEST SCOTLAND ?

    Adresse du siège social
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TYMEL WEST SCOTLAND ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HIGHCROSS WEST SCOTLAND LIMITED 13 déc. 199913 déc. 1999
    DMWSL 277 LIMITED09 juil. 199909 juil. 1999

    Quels sont les derniers comptes de TYMEL WEST SCOTLAND ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au21 juil. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour TYMEL WEST SCOTLAND ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour TYMEL WEST SCOTLAND ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    16 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 17 mars 2015

    16 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de * C/O Clyne & Co. Plymouth Chambers Bartlett Street Caerphilly Mid Glamorgan CF83 1JS Wales* le 28 mars 2014

    1 pagesAD01

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    6 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation

    LRESEX

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 21 juil. 2013

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 juin 2013

    État du capital au 05 juin 2013

    • Capital: GBP 1.05
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 21 juil. 2012

    4 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 3 Mountain Road Caerphilly Mid Glamorgan CF83 1HG* le 19 avr. 2013

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de * Victoria House Southampton Row London WC1B 4DA* le 10 juil. 2012

    2 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale établis au 21 juil. 2011

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    13 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    13 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2009 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2008 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 21 juil. 2010

    15 pagesAA

    Comptes annuels établis au 21 juil. 2009

    15 pagesAA

    Comptes annuels établis au 21 juil. 2008

    16 pagesAA

    Comptes annuels établis au 21 juil. 2007

    17 pagesAA

    Demande de rétablissement administratif

    3 pagesRT01

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Qui sont les dirigeants de TYMEL WEST SCOTLAND ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ALLARD, Imelda
    3 The Spires
    BT18 9DY Holywood
    County Down
    N Ireland
    Secrétaire
    3 The Spires
    BT18 9DY Holywood
    County Down
    N Ireland
    British82441870001
    ALLARD, Tyrone James
    The Spires
    BT18 9DY Holywood
    3
    County Down
    Northern Ireland
    Administrateur
    The Spires
    BT18 9DY Holywood
    3
    County Down
    Northern Ireland
    Northern IrelandIrishDirector2343150005
    MASSEY, Jill Elizabeth Ann
    15 Hatch Close
    Chapel Row
    RG7 6NZ Bucklebury
    Berkshire
    Secrétaire
    15 Hatch Close
    Chapel Row
    RG7 6NZ Bucklebury
    Berkshire
    British34436710001
    MEGAN, Michael Francis
    15 Blackthorn Drive
    RG18 4BP Thatcham
    Berkshire
    Secrétaire
    15 Blackthorn Drive
    RG18 4BP Thatcham
    Berkshire
    Irish46067860002
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire désigné
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    GUBB, Peter Griffiths
    Donnington Hurst
    Wantage Road Donnington
    RG14 3BE Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Donnington Hurst
    Wantage Road Donnington
    RG14 3BE Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish Chartered Surveyor6163460002
    HUNTER, Iain Gordon
    Headshaw
    TD7 4NT Ashkirk
    Selkirkshire
    Administrateur
    Headshaw
    TD7 4NT Ashkirk
    Selkirkshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor34752600001
    MEGAN, Michael Francis
    15 Blackthorn Drive
    RG18 4BP Thatcham
    Berkshire
    Administrateur
    15 Blackthorn Drive
    RG18 4BP Thatcham
    Berkshire
    IrishAccountant46067860002
    WOODS, Keith Desmond
    8 Walters Close
    Cold Ash
    RG18 9PU Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    8 Walters Close
    Cold Ash
    RG18 9PU Newbury
    Berkshire
    UkBritishArchitect87234820001
    WRIGHT, Helen Marjorie Elizabeth
    Merrilees Cottage
    Main Street
    RG20 7EW Chaddleworth
    Berkshire
    Administrateur
    Merrilees Cottage
    Main Street
    RG20 7EW Chaddleworth
    Berkshire
    BritishSurveyor56779440004
    25 NOMINEES LIMITED
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    Administrateur
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    42409900001

    TYMEL WEST SCOTLAND a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Assignation of rent due under occupational leases
    Créé le 03 juil. 2002
    Livré le 18 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due from highcross west scotland limited to the chargee
    Brèves mentions
    All sums due and that may become due to the borrower whether by way of rent or otherwise by the tenants detailed. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    Transactions
    • 18 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 mai 2002
    Livré le 18 juin 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    Transactions
    • 18 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 7 june 2002 and
    Créé le 31 mai 2002
    Livré le 13 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due from the company (formerly known as highcross west scotland limited) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Subjects known as crowngate centre,114-127 brook st,glasgow being the subjects at 117-127 brook st,glasgow and subjects on south west side of rimsdale st,glasgow; GLA113510 and GLA119195.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    Transactions
    • 13 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignation of rent
    Créé le 31 mai 2002
    Livré le 13 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due from the company (formerly known as highcross west scotland limited) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All sums due by way of rent in respect of their interest in the occupation leases as detailed in the schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    Transactions
    • 13 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 déc. 1999
    Livré le 07 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 29 december 1999 and
    Créé le 20 déc. 1999
    Livré le 15 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in the terms of a facility agreement dated 17TH and 20TH december 1999 relating to a facility to make available £1,622,400 to the company
    Brèves mentions
    Land at brook street glasgow t/n GLA113510 and land on the west south west side of rimsdale street glasgow t/n GLA119195.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    TYMEL WEST SCOTLAND a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    08 août 2015Due to be dissolved on
    18 mars 2014Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    William Antony Batty
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    practitioner
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0