TYMEL WEST SCOTLAND
Vue d'ensemble
Nom de la société | TYMEL WEST SCOTLAND |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société privée à responsabilité illimitée |
Numéro de société | 03804532 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TYMEL WEST SCOTLAND ?
Adresse du siège social | 3 Field Court Grays Inn WC1R 5EF London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TYMEL WEST SCOTLAND ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 21 juil. 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour TYMEL WEST SCOTLAND ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour TYMEL WEST SCOTLAND ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers | 16 pages | 4.72 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 17 mars 2015 | 16 pages | 4.68 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * C/O Clyne & Co. Plymouth Chambers Bartlett Street Caerphilly Mid Glamorgan CF83 1JS Wales* le 28 mars 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché | 6 pages | 4.20 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 21 juil. 2013 | 9 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 21 juil. 2012 | 4 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * 3 Mountain Road Caerphilly Mid Glamorgan CF83 1HG* le 19 avr. 2013 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Victoria House Southampton Row London WC1B 4DA* le 10 juil. 2012 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2012 avec liste complète des actionnaires | 14 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 21 juil. 2011 | 11 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2011 avec liste complète des actionnaires | 13 pages | AR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2010 avec liste complète des actionnaires | 13 pages | AR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2009 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2008 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 21 juil. 2010 | 15 pages | AA | ||||||||||
Comptes annuels établis au 21 juil. 2009 | 15 pages | AA | ||||||||||
Comptes annuels établis au 21 juil. 2008 | 16 pages | AA | ||||||||||
Comptes annuels établis au 21 juil. 2007 | 17 pages | AA | ||||||||||
Demande de rétablissement administratif | 3 pages | RT01 | ||||||||||
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 |
Qui sont les dirigeants de TYMEL WEST SCOTLAND ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLARD, Imelda | Secrétaire | 3 The Spires BT18 9DY Holywood County Down N Ireland | British | 82441870001 | ||||||
ALLARD, Tyrone James | Administrateur | The Spires BT18 9DY Holywood 3 County Down Northern Ireland | Northern Ireland | Irish | Director | 2343150005 | ||||
MASSEY, Jill Elizabeth Ann | Secrétaire | 15 Hatch Close Chapel Row RG7 6NZ Bucklebury Berkshire | British | 34436710001 | ||||||
MEGAN, Michael Francis | Secrétaire | 15 Blackthorn Drive RG18 4BP Thatcham Berkshire | Irish | 46067860002 | ||||||
DM COMPANY SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | 16 Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh Midlothian | 900000320001 | |||||||
GUBB, Peter Griffiths | Administrateur | Donnington Hurst Wantage Road Donnington RG14 3BE Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 6163460002 | ||||
HUNTER, Iain Gordon | Administrateur | Headshaw TD7 4NT Ashkirk Selkirkshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 34752600001 | ||||
MEGAN, Michael Francis | Administrateur | 15 Blackthorn Drive RG18 4BP Thatcham Berkshire | Irish | Accountant | 46067860002 | |||||
WOODS, Keith Desmond | Administrateur | 8 Walters Close Cold Ash RG18 9PU Newbury Berkshire | Uk | British | Architect | 87234820001 | ||||
WRIGHT, Helen Marjorie Elizabeth | Administrateur | Merrilees Cottage Main Street RG20 7EW Chaddleworth Berkshire | British | Surveyor | 56779440004 | |||||
25 NOMINEES LIMITED | Administrateur | Royal London House 22-25 Finsbury Square EC2A 1DX London | 42409900001 |
TYMEL WEST SCOTLAND a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Assignation of rent due under occupational leases | Créé le 03 juil. 2002 Livré le 18 juil. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due from highcross west scotland limited to the chargee | |
Brèves mentions All sums due and that may become due to the borrower whether by way of rent or otherwise by the tenants detailed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 31 mai 2002 Livré le 18 juin 2002 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security which was presented for registration in scotland on 7 june 2002 and | Créé le 31 mai 2002 Livré le 13 juin 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due from the company (formerly known as highcross west scotland limited) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Subjects known as crowngate centre,114-127 brook st,glasgow being the subjects at 117-127 brook st,glasgow and subjects on south west side of rimsdale st,glasgow; GLA113510 and GLA119195. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Assignation of rent | Créé le 31 mai 2002 Livré le 13 juin 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due from the company (formerly known as highcross west scotland limited) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All sums due by way of rent in respect of their interest in the occupation leases as detailed in the schedule. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 21 déc. 1999 Livré le 07 janv. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A standard security which was presented for registration in scotland on 29 december 1999 and | Créé le 20 déc. 1999 Livré le 15 janv. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee in the terms of a facility agreement dated 17TH and 20TH december 1999 relating to a facility to make available £1,622,400 to the company | |
Brèves mentions Land at brook street glasgow t/n GLA113510 and land on the west south west side of rimsdale street glasgow t/n GLA119195. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
TYMEL WEST SCOTLAND a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Creditors voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0