FOOD PARTNERS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFOOD PARTNERS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03804549
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FOOD PARTNERS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe FOOD PARTNERS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2 The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FOOD PARTNERS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DMWSL 270 LIMITED09 juil. 199909 juil. 1999

    Quels sont les derniers comptes de FOOD PARTNERS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour FOOD PARTNERS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Martin Johnson en tant que directeur le 03 juin 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Diarmuid Brendan Conifrey en tant que directeur le 24 juin 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Diarmuid Brendan Conifrey en tant qu'administrateur le 08 avr. 2020

    2 pagesAP01

    Ordonnance du tribunal

    S1096 Court Order to Rectify
    6 pagesOC

    Déclaration de confirmation établie le 30 août 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2018

    22 pagesAA

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    4 pagesMR04

    legacy

    pagesANNOTATION

    Déclaration de confirmation établie le 30 août 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 30 sept. 2017

    23 pagesAA

    legacy

    2 pagesAGREEMENT2

    legacy

    47 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Période comptable précédente prolongée du 31 mars 2017 au 30 sept. 2017

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 30 août 2017 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2016

    31 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 août 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Mark Ian Tentori en tant que directeur le 27 avr. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Gavin Cox en tant que secrétaire le 08 mars 2016

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Gavin Eliot Cox en tant que directeur le 07 mars 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Martin Johnson en tant qu'administrateur le 25 févr. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Mark Ian Tentori en tant qu'administrateur le 06 oct. 2015

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de FOOD PARTNERS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COX, Gavin
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Secrétaire
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    165756650001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    Secrétaire
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    British150500050001
    ROBERTSON, Neil Charles
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    Secrétaire
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    BritishChartered Accountant48323870001
    THORNE, Michael
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British71735980002
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire désigné
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Secrétaire désigné
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    CHREE, Ian Charles Gordon
    6 The Grange
    Perceton
    KA11 2EU Irvine
    Ayrshire
    Administrateur
    6 The Grange
    Perceton
    KA11 2EU Irvine
    Ayrshire
    ScotlandBritishCompany Director65127980003
    CONIFREY, Diarmuid Brendan
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    Administrateur
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandIrishChief Finance Officer268799160001
    COX, Gavin Eliot
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Administrateur
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    United KingdomBritishDirector153840250001
    EARL, Elizabeth Jane
    Waverley
    Burners Heath
    GU24 0DJ Pirbright Woking
    Surrey
    Administrateur
    Waverley
    Burners Heath
    GU24 0DJ Pirbright Woking
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director202375770001
    HAZELDEAN, William James
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    Administrateur
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    ScotlandBritishCompany Director83660790002
    HULBERT, David John
    St Michaels Way
    Steeple Claydon
    MK18 2QD Buckingham
    53
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    St Michaels Way
    Steeple Claydon
    MK18 2QD Buckingham
    53
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishOperational And Technical Dire136463020001
    JOHNSON, Martin
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    Administrateur
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandBritishDirector140167360001
    KILSHAW, David Charles
    Drumallan
    283 North Deeside Road, Cults
    AB15 9PA Aberdeen
    Administrateur
    Drumallan
    283 North Deeside Road, Cults
    AB15 9PA Aberdeen
    United KingdomBritishIndustrial Manager18455470002
    KINGSLEY BATES, Paul
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Administrateur
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director132962170001
    MCLELLAND, Stewart
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishDirector157009150001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Administrateur
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector51784930002
    POCOCK, Patrick William
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    Administrateur
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    BritishCompany Director96978470001
    ROBERTSON, Neil Charles
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    Administrateur
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    United KingdomBritishChartered Accountant48323870001
    ROBINSON, Stuart John
    Westfield House
    Harburn
    EH55 8RB West Calder
    West Lothian
    Administrateur
    Westfield House
    Harburn
    EH55 8RB West Calder
    West Lothian
    BritishCompany Director63448390001
    TENTORI, Mark Ian
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    Administrateur
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandBritishChief Finance Officer119564310001
    THOMAS, Christopher
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Administrateur
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    United KingdomBritishDirector63844650001
    THORNE, Michael
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director71735980002
    THORPE, Alan
    7 Oak Wynd
    Cambuslang
    G72 7GS Glasgow
    Administrateur
    7 Oak Wynd
    Cambuslang
    G72 7GS Glasgow
    BritishDistribution Manager81775420001
    TRUELOVE, Amelia Anne
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    Administrateur
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    BritishDirector37845970003
    WOOD, Steven John
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Administrateur
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    United KingdomBritishDirector232132390001
    25 NOMINEES LIMITED
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    Administrateur
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    42409900001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FOOD PARTNERS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Adelie Foods Group Limited
    The Square, Southall Lane
    UB2 5NH Southall
    2
    England
    06 avr. 2016
    The Square, Southall Lane
    UB2 5NH Southall
    2
    England
    Non
    Forme juridiqueAdelie Foods Group Limited
    Pays d'enregistrementEngalnd & Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementRegistrar Of Companies
    Numéro d'enregistrement07964277
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    FOOD PARTNERS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 05 mars 2015
    Livré le 11 mars 2015
    En cours
    Brève description
    None.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 11 mars 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 31 mai 2013
    Livré le 07 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    A fixed charge over all land (I.E. any interest in heritable, freehold or leasehold land) vested in or charged to food partners limited, owned now or in the future. This includes all fixtures and fittings attached to the land and all rents receivable from any lease granted out of the land.. A fixed charge, subject to third party consents, over all intellectual property of food partners limited, owned now or in the future.. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 07 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 10 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 31 mai 2013
    Livré le 05 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Punjab National Bank (International) Limited
    Transactions
    • 05 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 06 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 11 avr. 2012
    Livré le 14 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor or any future obligor and each grantor of security to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 07 juin 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 11 avr. 2012
    Livré le 14 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Pnc Business Credit, a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD
    Transactions
    • 14 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 07 juin 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 20 oct. 2011
    Livré le 01 nov. 2011
    En cours
    Montant garanti
    £56,000 due or to become due
    Brèves mentions
    The deposit amount see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Trw Pensions Trust Limited
    Transactions
    • 01 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Rent deposit deed
    Créé le 20 oct. 2011
    Livré le 01 nov. 2011
    En cours
    Montant garanti
    £18,066.80 due or to become due
    Brèves mentions
    The deposit amount see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Trw Pensions Trust Limited
    Transactions
    • 01 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Rent deposit deed
    Créé le 23 févr. 2009
    Livré le 04 mars 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All monies standing to the credit of the deposit account see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Brixton (Unit 6 Horton Road Poyle) Limited
    Transactions
    • 04 mars 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed
    Créé le 24 avr. 2008
    Livré le 10 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £43,505.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    £43,505.00 or the amount of the credit in the account from time to time.
    Personnes ayant droit
    • Microsoft Limited
    Transactions
    • 10 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 mars 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 21 avr. 2008
    Livré le 02 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Duke Street Capital General Partner Limited (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transactions
    • 02 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Rent deposit deed
    Créé le 01 mars 2007
    Livré le 10 mars 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Premium of £56,000 plus vat deposited by the company with the chargee and all other sums from time to time.
    Personnes ayant droit
    • Trw Pensions Trust Limited
    Transactions
    • 10 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture accession deed
    Créé le 04 avr. 2006
    Livré le 13 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each member of the group to the security agent and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transactions
    • 13 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 8 may 2006 and
    Créé le 02 avr. 2006
    Livré le 27 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the security agent and/or the other security parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Rowallan business park, southcraig avenue, kilmarnock t/no. AYR3588.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Security Parties)
    Transactions
    • 27 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Share pledge
    Créé le 02 avr. 2006
    Livré le 20 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any additional shares and related rights, additional shares means any shares in the company including any such shares comprised in related rights meaning all dividends, interest. The comapany and the existing shares being food partners kilmarnock limited reg no:SC140577, ordinary shares of £1. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland 'Security Agent'
    Transactions
    • 20 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 26TH september 2005 and
    Créé le 31 mai 2005
    Livré le 07 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The property k/a rowallan business park, kilmarnock.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 07 août 2003
    Livré le 13 août 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The sum of £62,500 or such greater sum as is equal to one half of the current annual rental as defined in the lease.
    Personnes ayant droit
    • Cockspur Property (General Partner) Limited and Cockspur Property (Nominee No.1) Limited
    Transactions
    • 13 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Composite corporate guarantee
    Créé le 31 oct. 2001
    Livré le 17 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    To exercise a right of set-off or retention in respect of all money at any time standing to the credit of the guarantor's accounts whatsoever. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 oct. 2001
    Livré le 14 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 oct. 2000
    Livré le 19 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0