CITYSCOPE DEVELOPMENTS LIMITED

CITYSCOPE DEVELOPMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCITYSCOPE DEVELOPMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03805091
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CITYSCOPE DEVELOPMENTS LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe CITYSCOPE DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Acre House 11-15 William Road
    London
    NW1 3ER
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CITYSCOPE DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ACRE 310 LIMITED12 juil. 199912 juil. 1999

    Quels sont les derniers comptes de CITYSCOPE DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour CITYSCOPE DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Thomas Liam O'donohoe en tant que directeur le 21 sept. 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Mark William Fitzgerald en tant que directeur le 21 sept. 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de Cherry Rose Investments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 sept. 2022

    1 pagesPSC07

    Notification de Steven Mark Aldridge en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 sept. 2022

    2 pagesPSC01

    Cessation de Thomas Liam O'donohoe en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 sept. 2022

    1 pagesPSC07

    Déclaration de confirmation établie le 08 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 juil. 2021

    8 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Steven Mark Aldridge le 19 juil. 2021

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 08 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 juil. 2020

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 juil. 2019

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 juil. 2018

    7 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Steven Mark Aldridge le 18 mars 2019

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Steven Mark Aldridge le 18 mars 2019

    2 pagesCH01

    Modification des détails de Thomas Liam O'donohoe en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 nov. 2018

    2 pagesPSC04

    Déclaration de confirmation établie le 08 juin 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 juil. 2017

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 juin 2017 avec mises à jour

    9 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 juil. 2016

    10 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CITYSCOPE DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ALDRIDGE, Steven Mark
    Acre House 11-15 William Road
    London
    NW1 3ER
    Administrateur
    Acre House 11-15 William Road
    London
    NW1 3ER
    EnglandBritishProperty Developer67139430012
    GRAF, Robin Anthony Scott
    16 Elwill Way
    BR3 3AD Beckenham
    Kent
    Secrétaire
    16 Elwill Way
    BR3 3AD Beckenham
    Kent
    BritishSolicitor3942820001
    WRIGHT, Sunchia Liza
    73e Warrington Crescent
    W9 1EH London
    Secrétaire
    73e Warrington Crescent
    W9 1EH London
    British67139500001
    LAWSON (LONDON) LIMITED
    Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    Secrétaire désigné
    Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    900018120001
    CLAYDON, Katherine Maria
    20 Lambourne Gardens
    Chingford
    E4 7SG London
    Administrateur
    20 Lambourne Gardens
    Chingford
    E4 7SG London
    EnglandBritishCompany Secretarial Assistant58204010001
    COOPER, Michael Edward
    23 Priory Road
    N8 8LH London
    Administrateur
    23 Priory Road
    N8 8LH London
    BritishAdministrator64658610001
    FITZGERALD, Mark William
    11/15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    United Kingdom
    Administrateur
    11/15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    United Kingdom
    EnglandBritishPrivate Investor154379460003
    O'DONOHOE, Thomas Liam
    11/15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    United Kingdom
    Administrateur
    11/15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    United Kingdom
    United KingdomIrishCompany Director158163190002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CITYSCOPE DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Steven Mark Aldridge
    Acre House 11-15 William Road
    London
    NW1 3ER
    22 sept. 2022
    Acre House 11-15 William Road
    London
    NW1 3ER
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    Thomas Liam O'Donohoe
    11/15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    11/15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    United Kingdom
    Oui
    Nationalité: Irish
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    11/15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    11/15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    United Kingdom
    Oui
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement07509939
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    11/15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    11/15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement07995579
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.

    CITYSCOPE DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Interest loan agreement
    Créé le 31 mai 2012
    Livré le 23 janv. 2013
    En cours
    Montant garanti
    £1,400,000 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge property k/a 44 jubilee place london t/no NGL623096 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Easter Rose Limited
    Transactions
    • 23 janv. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    Interest loan agreement
    Créé le 31 mai 2012
    Livré le 23 janv. 2013
    En cours
    Montant garanti
    £1,400,000 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge property k/a 44 jubilee place london t/no NGL623096 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Cherry Rose Investments Limited
    Transactions
    • 23 janv. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    Interest free loan agreement
    Créé le 31 mai 2012
    Livré le 23 janv. 2013
    En cours
    Montant garanti
    £878,665 due or to become due from the company to the charge on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge property k/a 44 jubilee place london t/no NGL623096 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Easter Rose Limited
    Transactions
    • 23 janv. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    Interest free loan agreement
    Créé le 31 mai 2012
    Livré le 23 janv. 2013
    En cours
    Montant garanti
    £878,665 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge 44 jubilee place london t/no NGL623096 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Cherry Rose Investments Limited
    Transactions
    • 23 janv. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal charge
    Créé le 26 janv. 2006
    Livré le 01 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    32, hesper mews, london t/no LN109874. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 16 nov. 2005
    Livré le 24 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    29 malvern court onslow square london t/no BGL44805. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 24 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 12 oct. 2005
    Livré le 19 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of charge
    Créé le 23 juil. 2004
    Livré le 31 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Flat 2, 7/8 sydney place kensington london fixed charge over all rental income and the proceeds of sale of any lease of the property. Floating charge over the undertaking all property assets and rights of the company.
    Personnes ayant droit
    • Capital Home Loans Limited
    Transactions
    • 31 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 janv. 2003
    Livré le 20 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Leasehold property known as flat d 48 redcliffe gardens london SW10 9HB.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 janv. 2003
    Livré le 15 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £260,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    L/H property k/a 48D redcliffe gardens london t/n BGL35642.
    Personnes ayant droit
    • Redcliffe Estates Limited
    Transactions
    • 15 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 02 janv. 2003
    Livré le 08 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 oct. 2002
    Livré le 12 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Leasehold property known as basement flat 7 ormonde gate chelsea london SW3 4EU. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 avr. 2002
    Livré le 01 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Flat 2,7 sydney place,london SW7 3NL. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 déc. 2001
    Livré le 02 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a flat e, 40 lexham gardens, kensington, london W8 5JE.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 04 mai 2000
    Livré le 08 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a 14 h randolph crescent london t/no: NGL464430. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 10 janv. 2000
    Livré le 25 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 28 castellain mansions castellain road london t/n-NGL707987. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0