SOUTHERN CROSS CARE HOMES HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SOUTHERN CROSS CARE HOMES HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03805939 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SOUTHERN CROSS CARE HOMES HOLDINGS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SOUTHERN CROSS CARE HOMES HOLDINGS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour SOUTHERN CROSS CARE HOMES HOLDINGS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack en tant que secrétaire le 09 oct. 2012 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Avis d'achèvement de l'accord volontaire | 6 pages | 1.4 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy James Bolot en tant que directeur le 17 août 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Avis au registre des sociétés de l'accord volontaire prenant effet | 4 pages | 1.1 | ||||||||||
Cessation de la nomination de William James Buchan en tant que directeur le 15 nov. 2011 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Andrew Smith en tant que directeur le 01 nov. 2011 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Stephen Jonathan Taylor en tant qu'administrateur le 26 oct. 2011 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Timothy James Bolot en tant qu'administrateur le 26 oct. 2011 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2010 | 20 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de William Mcleish en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Midmer en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 27 sept. 2009 | 18 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Andrew Smith le 07 janv. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Andrew Smith en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Smith en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Andrew Smith en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kamma Foulkes en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SOUTHERN CROSS CARE HOMES HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYLOR, Stephen Jonathan | Administrateur | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 163496070001 | |||||
| JOYCE, Meriel Lucy Ann | Secrétaire | 21 Easter Steil EH10 5XE Edinburgh | British | 16385330010 | ||||||
| KAUL, Sheila | Secrétaire | 35 Princes Court HA9 7JJ Wembley Middlesex | British | 70194600001 | ||||||
| MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Secrétaire | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | 158305800001 | |||||||
| MCLEISH, William David | Secrétaire | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | British | 168970640001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BOLOT, Timothy James | Administrateur | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 107837080002 | |||||
| BUCHAN, William James | Administrateur | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 79917240001 | |||||
| COLVIN, William | Administrateur | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890003 | |||||
| COLVIN, William | Administrateur | 1 Patterdale Coldharbour Road KT14 6JN West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890001 | |||||
| FOULKES, Kamma | Administrateur | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| GROOMBRIDGE, Kevin John | Administrateur | 51 Old Croft Road ST17 0NL Stafford | England | British | 105722880001 | |||||
| JOYCE, Anthony | Administrateur | Gibliston Farmhouse Colinsburgh KY9 1JS Leven Fife | Scotland | British | 95693160002 | |||||
| JOYCE, Martin Patrick | Administrateur | La Rue A St Peter Port GY1 1QG Guernsey | United Kingdom | British | 27130160009 | |||||
| JOYCE, Meriel Lucy Ann | Administrateur | 21 Easter Steil EH10 5XE Edinburgh | British | 16385330010 | ||||||
| LOCK, Jason David | Administrateur | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | 144822040001 | |||||
| MALHAM, Janette | Administrateur | The Limekilns 9a Elm Grove TS26 8LZ Hartlepool | England | British | 91088900003 | |||||
| MCKEEVER, Pauline Ann | Administrateur | 40 Pine Place G5 0BX Glasgow | Britain | British | 91521130001 | |||||
| MIDMER, Richard Neil | Administrateur | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 110640170001 | |||||
| MILLOY, Alastair Harvey | Administrateur | Flat 1/1 Camphill House Queens Park G41 2DX Glasgow Lanarkshire | British | 69398880001 | ||||||
| MURPHY, John | Administrateur | 21 Montgreenan View KA13 7NL Kilwinning Ayrshire | British | 26177180002 | ||||||
| MURPHY, John | Administrateur | 4 Lochend Road KA10 6JJ Troon | United Kingdom | British | 26177180004 | |||||
| RUTTER, Christopher | Administrateur | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| SCOTT, Philip Henry | Administrateur | The Old Vicarage Newgate DL12 8NW Barnard Castle County Durham | England | British | 174231320001 | |||||
| SIZER, Graham Kevin | Administrateur | Old Salutation Barn Low Street Little Fencote DL7 9LR Northallerton | England | British | 77274540003 | |||||
| SMITH, David Andrew, Mr. | Administrateur | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 147997950001 | |||||
| SMITH, David Andrew, Mr. | Administrateur | Durham Road Low Fell NE9 5AL Gateshead 377 England England | United Kingdom | British | 147997950001 | |||||
| STEIN, Anthony Karl | Administrateur | 9 Birmingham Road Coughton B49 5HR Alcester | United Kingdom | British | 109518530001 | |||||
| TAYLOR, John James | Administrateur | Ben Sayers Park North Berwick EH39 5PT Edinburgh 19 East Lothian | Scotland | British | 138774840001 | |||||
| WILSON, Mark Stephen | Administrateur | 9 Wheatear Lane Ingleby Barwick TS17 0TB Stockton On Tees | British | 90893350001 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
SOUTHERN CROSS CARE HOMES HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 29 févr. 2008 Livré le 14 mars 2008 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 06 juin 2007 Livré le 19 juin 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 07 juil. 2006 Livré le 20 juil. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 08 avr. 2005 Livré le 15 avr. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 02 août 2002 Livré le 13 août 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of fixed charge the real property other than scottish real property, all goodwill, insurance, debts, investments and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Share pledge | Créé le 31 janv. 2001 Livré le 10 févr. 2001 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from highfield operations limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The shares in the capital of highfield operations limited and any shares in the capital of highfield operations LTD from time to time and all rights to dividends and other distributions payable and all other rights thereon,bonus,etc. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Share pledge | Créé le 19 janv. 2001 Livré le 26 janv. 2001 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from highfield operations (no.2) limited under the terms of the lease or under the terms of any other document whether actual or contingent | |
Brèves mentions The shares listed in the schedule to the share pledge and all rights to dividends and other distributions paid or payable on all or any of these shares and all other rights accruing or offered at any time by way of redemption, bonus, pre-emption or otherwise. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
SOUTHERN CROSS CARE HOMES HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Corporate voluntary arrangement (CVA) |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0