VOYAGE RECRUITMENT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéVOYAGE RECRUITMENT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03807482
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de VOYAGE RECRUITMENT LIMITED ?

    • Activités des agences de travail temporaire (78200) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe VOYAGE RECRUITMENT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Voyage Care Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de VOYAGE RECRUITMENT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    OPPORTUNITIES UK LIMITED24 août 199924 août 1999
    INGLEBY (1226) LIMITED14 juil. 199914 juil. 1999

    Quels sont les derniers comptes de VOYAGE RECRUITMENT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour VOYAGE RECRUITMENT LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour VOYAGE RECRUITMENT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Nomination de Mr Philip Andre Sealey en tant qu'administrateur le 09 janv. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kevin Wei Roberts en tant que directeur le 09 janv. 2015

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2014

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 juil. 2014

    État du capital au 17 juil. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2013

    14 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * Garrick House 2 Queen Street Lichfield Staffordshire WS13 6QD* le 26 sept. 2013

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Kevin Wei Roberts en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de James Mckendrick en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 juil. 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 19 juil. 2013

    SH01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    28 pagesMG01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Nomination de Mr Andrew Winning en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Nigel Moreton en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Douglas Quinn en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr James Bruce Mckendrick en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Douglas John Quinn le 14 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Nigel Keef Moreton le 14 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de VOYAGE RECRUITMENT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SEALEY, Philip Andre
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    Secrétaire
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    British45325360001
    SEALEY, Philip Andre
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    Administrateur
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    EnglandBritish45325360001
    WINNING, Andrew
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    Administrateur
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    EnglandBritish73772160002
    EARNSHAW, James Barry
    Holly Cottage High Street
    Eagle
    LN6 9DG Lincoln
    Lincolnshire
    Secrétaire
    Holly Cottage High Street
    Eagle
    LN6 9DG Lincoln
    Lincolnshire
    British53820720001
    MORETON, Nigel Keef
    Swan Farm
    Mill Lane
    WS9 9HN Lower Stonnall
    Staffordshire
    Secrétaire
    Swan Farm
    Mill Lane
    WS9 9HN Lower Stonnall
    Staffordshire
    British57063050002
    SEALEY, Philip Andre
    4 Beoley Hall
    Icknield St Beoley
    B98 9AL Redditch
    Worcestershire
    Secrétaire
    4 Beoley Hall
    Icknield St Beoley
    B98 9AL Redditch
    Worcestershire
    British45325360001
    INGLEBY NOMINEES LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    Secrétaire désigné
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007860001
    BERRY, Philip Thomas
    3 Roman Grange
    B74 3GA Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    3 Roman Grange
    B74 3GA Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish47529490002
    BROCK, Julian Richard Christopher
    Haredell
    Martinsend Lane
    HP16 9HR Great Missenden
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Haredell
    Martinsend Lane
    HP16 9HR Great Missenden
    Buckinghamshire
    British74294460003
    HARRIS, Nigel Robert
    Cedar Cottage
    Croft Lane, Crondall
    GU10 5QG Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Cedar Cottage
    Croft Lane, Crondall
    GU10 5QG Farnham
    Surrey
    British16250270002
    MCKENDRICK, James Bruce
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Garrick House
    Staffordshire
    Administrateur
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Garrick House
    Staffordshire
    EnglandBritish154043480001
    MILESTONE, Neill Frederick, Mr.
    Lysways Hall
    Lysways Lane
    WS15 4QB Longdon Green
    Staffordshire
    Administrateur
    Lysways Hall
    Lysways Lane
    WS15 4QB Longdon Green
    Staffordshire
    EnglandBritish13850080002
    MORETON, Nigel Keef
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Garrick House
    Staffordshire
    Administrateur
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Garrick House
    Staffordshire
    United KingdomBritish57063050002
    QUINN, Douglas John
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Garrick House
    Staffordshire
    Administrateur
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Garrick House
    Staffordshire
    United KingdomBritish80757840002
    ROBERTS, Kevin Wei
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    Administrateur
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    EnglandBritish72030660002
    SMITH, Andrew Colwyn
    5 Foden Close
    Shenstone
    WS14 0LE Litchfield
    Staffordshire
    Administrateur
    5 Foden Close
    Shenstone
    WS14 0LE Litchfield
    Staffordshire
    British78023740001
    INGLEBY HOLDINGS LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    Administrateur désigné
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007850001

    VOYAGE RECRUITMENT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 25 janv. 2013
    Livré le 04 févr. 2013
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any member of the group to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 04 févr. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    Fixed and floating security document
    Créé le 04 avr. 2006
    Livré le 20 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dresdner Bank Ag London Branch as Securuty Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 20 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating security document
    Créé le 02 juil. 2004
    Livré le 09 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party and any investor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Property including: the woodlnds, church lane, acklam, t/no CE8507, belchford, hesledon road, blackhall, t/no DU110208, 336 cowpen road, blyth, t/no ND117576 and for further properties charged please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dresdner Bank Ag London Branch as Security Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 09 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 06 sept. 2001
    Livré le 14 sept. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities due or to become due from the company and/or each other charging company (except for sums owed by such company in it's capacity as a guarantor for the chargor) to the chargee under or pursuant to the senior finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 sept. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 11 oct. 1999
    Livré le 18 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 sept. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0