CARRIER RENTAL SYSTEMS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | CARRIER RENTAL SYSTEMS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Détails du statut de la société | Proposition active de radiation |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03807755 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CARRIER RENTAL SYSTEMS LIMITED ?
Adresse du siège social | Unit H, Littleton House Littleton Road TW15 1UU Ashford Middlesex United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CARRIER RENTAL SYSTEMS LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CARRIER RENTAL SYSTEMS LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 13 juil. 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 27 juil. 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 13 juil. 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour CARRIER RENTAL SYSTEMS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2023 | 17 pages | AA | ||||||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Anthony Robinson le 01 nov. 2024 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Neil Andrew Vincent Gregor Macgregor le 01 nov. 2024 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Porsham Close Belliver Industrial Estate Plymouth Devon PL6 7DB England à Unit H, Littleton House Littleton Road Ashford Middlesex TW15 1UU le 08 nov. 2024 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Neil Andrew Vincent Gregor Macgregor le 24 oct. 2024 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 juil. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 18 pages | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 juil. 2023 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
État du capital au 15 mars 2023
| 5 pages | SH19 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Statuts | 8 pages | MA | ||||||||||||||||||
Subdivision des actions au 23 févr. 2023 | 6 pages | SH02 | ||||||||||||||||||
Détails de la variation des droits attachés aux actions | 2 pages | SH10 | ||||||||||||||||||
Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions | 2 pages | SH08 | ||||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 21 pages | AA | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Simon Boniface en tant que secrétaire le 09 déc. 2022 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||||||
Nomination de Mr John Anthony Robinson en tant qu'administrateur le 09 déc. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||
Nomination de Mr Neil Andrew Vincent Gregor Macgregor en tant qu'administrateur le 09 déc. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Alexandra Elizabeth Gooch en tant que directeur le 09 déc. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Justin Paddock en tant que directeur le 09 déc. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de CARRIER RENTAL SYSTEMS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREGOR MACGREGOR, Neil Andrew Vincent | Administrateur | Littleton Road TW15 1UU Ashford Unit H, Littleton House Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 286329300004 | ||||
ROBINSON, John Anthony | Administrateur | Littleton Road TW15 1UU Ashford Unit H, Littleton House Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 205997980001 | ||||
ATTRILL, Christopher Richard | Secrétaire | 9 The Chines Delamere Park CW8 2XA Cuddington Cheshire | British | Finance Director | 93024670001 | |||||
BONIFACE, Simon | Secrétaire | Guildford Road Fetcham KT22 9UT Leatherhead United Technologies House England | 250226760001 | |||||||
BROADBENT, Garry Keith | Secrétaire | 24 Heron Way FY3 8FB Blackpool Lancashire | British | Director | 45362230002 | |||||
D'CRUZ, Agnes Mary | Secrétaire | Guildford Road Fetcham KT22 9UT Leatherhead United Technologies House Surrey England | Malaysian | Lawyer | 110058870001 | |||||
FOSTER, David Eric | Secrétaire | 3 Leadhall Drive HG2 9NL Harrogate North Yorkshire | British | Chartered Accountant | 54143460001 | |||||
HARBRIDGE, Simon Richard | Secrétaire | Marlbrook Lane Sale Green WR9 7LW Droitwich Charlbury House Worcestershire | British | Director | 105161460002 | |||||
LEDGER, Ray | Secrétaire | 4 Brunswick House 5-6 Mansfield Court HG1 2QT Harrogate North Yorkshire | British | Director | 98530780001 | |||||
SLOSS, Robert | Secrétaire | Unit B Colima Avenue Sunderland Enterprise Park West SR5 3XE Sunderland | 201315100001 | |||||||
WILCOCK, Laura | Secrétaire | Unit B Colima Avenue Sunderland Enterprise Park West SR5 3XE Sunderland | 201314890001 | |||||||
INGLEBY NOMINEES LIMITED | Secrétaire désigné | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham | 900007860001 | |||||||
ATTRILL, Christopher Richard | Administrateur | 9 The Chines Delamere Park CW8 2XA Cuddington Cheshire | England | British | Director | 93024670001 | ||||
BLABY, Steven | Administrateur | Church Road GL15 5EL Lydney Watkins Hire Ltd England | England | British | Accountant | 250616320001 | ||||
BROADBENT, Garry Keith | Administrateur | Mullberry House Meadowview, Great Plumpton PR4 3NF Preston | United Kingdom | British | Director | 45362230003 | ||||
CLUBB, Ian Mcmaster | Administrateur | Pond House EN5 4PS Hadley Green Hertfordshire | British | Accountant | 3485960001 | |||||
DAVY, Michael Robert | Administrateur | Gresham Gardens Golders Green NW11 8PD London 34 | England | British | Investment Banker | 132050710001 | ||||
DENNING, Roland John | Administrateur | Swallowfield Grange The Street RG7 1RE Swallowfield Berkshire | England | British | Company Director | 95991510001 | ||||
FOSTER, David Eric | Administrateur | 3 Leadhall Drive HG2 9NL Harrogate North Yorkshire | British | Chartered Accountant | 54143460001 | |||||
GOOCH, Alexandra Elizabeth | Administrateur | Belliver Industrial Estate PL6 7DB Plymouth Porsham Close Devon England | England | British | Finance Director | 286825110001 | ||||
GORNALL, David | Administrateur | Gometra Little Stainton Bishopton TS21 1HN Stockton On Tees | United Kingdom | British | Sales And Marketing Director | 76417460004 | ||||
GREEN, Derek | Administrateur | Rosedale House Brandreth Delph, Parbold WN8 7AQ Wigan Lancashire | United Kingdom | British | Company Director | 166954440001 | ||||
HARBRIDGE, Simon Richard | Administrateur | Marlbrook Lane Sale Green WR9 7LW Droitwich Charlbury House Worcestershire | England | British | Company Director | 105161460002 | ||||
HOOK, Eric Ward | Administrateur | Woodside House Longville In The Dale TF13 6DR Much Wenlock Shropshire | England | British | Company Director | 39185740002 | ||||
HUGHES, Jonathan Raoul | Administrateur | 4 Sudbrooke Road SW12 8TG London | British | Investment Banker | 61123800001 | |||||
HUNGWE, Archibald Ziwanemoyo | Administrateur | Guildford Road KT22 9UT Leatherhead United Technologies House Surrey England | England | British | General Manager | 240353160001 | ||||
JONES, Richard Hilton | Administrateur | Guildford Road Fetcham KT22 9UT Leatherhead United Technologies House Surrey England | England | British | General Manager/ Company Direc | 101090610001 | ||||
KELLEHER, Brian Edward | Administrateur | 7 Spring Meadow Lane 06035 Granby Connecticut Usa | American | Attorney | 117635100001 | |||||
LEDGER, Ray | Administrateur | 4 Brunswick House 5-6 West Park HG1 2QT Harrogate North Yorkshire | British | Director | 93270980001 | |||||
MAKHARINE, Muriel | Administrateur | 121 Northington Drive Avon Ct 06601 United States | Usa | French | Director | 132639020001 | ||||
MCDONALD, Steven Thomas | Administrateur | Roborough PL6 7DB Plymouth Porsham Close England | England | British | Finance Director | 133653510001 | ||||
MCMULLEN, Simon Ross Harden | Administrateur | Stockley Close UB7 9BL West Drayton 365 England | England | British | Financial Director | 132089160001 | ||||
MCMULLEN, Simon Ross Harden | Administrateur | Priory Road Chalfont St Peter SL9 8SB Gerrards Cross 7 Buckinghamshire | England | British | Finance Director | 132089160001 | ||||
PADDOCK, Andrew Justin | Administrateur | Guildford Road Fetcham KT22 9UT Leatherhead United Technologies House England | England | British | Director | 246915550001 | ||||
PAYNE, Alan Douglas | Administrateur | 112 Northfield Road Kings Norton B30 1JG Birmingham West Midlands | British | Accountant | 74345940001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CARRIER RENTAL SYSTEMS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matlock Holdings Ltd | 07 mai 2019 | Littleton Road TW15 1TZ Ashford 1st Floor Ash House Middlesex England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
United Technologies Holdings Limited | 15 juil. 2016 | Littleton Road TW15 1TZ Ashford 1st Floor Ash House England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour CARRIER RENTAL SYSTEMS LIMITED ?
Notifié le | Cessé le | Déclaration |
---|---|---|
15 juil. 2016 | 15 juil. 2016 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0