THE LONDON JEWISH CULTURAL CENTRE

THE LONDON JEWISH CULTURAL CENTRE

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE LONDON JEWISH CULTURAL CENTRE
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social
    Numéro de société 03811133
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE LONDON JEWISH CULTURAL CENTRE ?

    • Éducation secondaire générale (85310) / Enseignement
    • Enseignement secondaire technique et professionnel (85320) / Enseignement
    • Autres activités de travail social sans hébergement n.c.a. (88990) / Activités de santé humaine et d'action sociale
    • Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a. (93290) / Activités artistiques, de loisirs et de divertissement

    Où se situe THE LONDON JEWISH CULTURAL CENTRE ?

    Adresse du siège social
    930 High Road
    N12 9RT London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THE LONDON JEWISH CULTURAL CENTRE ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THE LONDON JEWISH CULTURAL CENTRE LIMITED11 oct. 199911 oct. 1999
    ALDIN LIMITED21 juil. 199921 juil. 1999

    Quels sont les derniers comptes de THE LONDON JEWISH CULTURAL CENTRE ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour THE LONDON JEWISH CULTURAL CENTRE ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Neil George Pistol en tant que directeur le 08 avr. 2019

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2018

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 juil. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2017 au 30 juin 2018

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 21 juil. 2017 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2016

    19 pagesAA

    Période comptable actuelle raccourcie du 28 févr. 2017 au 31 déc. 2016

    1 pagesAA01

    Comptes annuels établis au 29 févr. 2016

    23 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 juil. 2016 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Eldred Hyman Kraines en tant que secrétaire le 03 mars 2016

    1 pagesTM02

    Nomination de Alan Harvey Fell en tant que secrétaire le 03 mars 2016

    2 pagesAP03

    Comptes consolidés établis au 28 févr. 2015

    25 pagesAA

    Cessation de la nomination de David John Lewis en tant que directeur le 28 août 2015

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Trudy Ann Marie Gold en tant que directeur le 09 sept. 2015

    2 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Ivy House 94-96 North End Road London NW11 7SX à 930 High Road London N12 9RT le 05 août 2015

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 juil. 2015 sans liste des membres

    6 pagesAR01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 août 2014 au 28 févr. 2015

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Michael Aron Heller en tant que directeur le 14 janv. 2015

    1 pagesTM01

    Inscription de la charge 038111330007, créée le 27 nov. 2014

    26 pagesMR01

    Cessation de la nomination de Joanna Frances Millan en tant que directeur le 02 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de THE LONDON JEWISH CULTURAL CENTRE ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FELL, Alan Harvey
    IG8 0DG Woodford Green
    28 Linden Crescent
    Essex
    United Kingdom
    Secrétaire
    IG8 0DG Woodford Green
    28 Linden Crescent
    Essex
    United Kingdom
    205752270001
    BLACK, Harry Sinclair
    N12 9RT London
    930 High Road
    United Kingdom
    Administrateur
    N12 9RT London
    930 High Road
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor11979600002
    BRILL, Alan Michael
    N12 9RT London
    930 High Road
    United Kingdom
    Administrateur
    N12 9RT London
    930 High Road
    United Kingdom
    United KingdomBritishRetired45388860001
    COHEN, Des
    N12 9RT London
    930 High Road
    United Kingdom
    Administrateur
    N12 9RT London
    930 High Road
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant34037680001
    MARX, Michael Henry
    N12 9RT London
    930 High Road
    United Kingdom
    Administrateur
    N12 9RT London
    930 High Road
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector35019090001
    HOROWITZ, David
    57 Hartland Drive
    HA8 8RJ Edgware
    Middlesex
    Secrétaire
    57 Hartland Drive
    HA8 8RJ Edgware
    Middlesex
    BritishAccountant93625650001
    KRAINES, Eldred Hyman
    N12 9RT London
    930 High Road
    United Kingdom
    Secrétaire
    N12 9RT London
    930 High Road
    United Kingdom
    BritishConsultant75673190001
    MOCATTA, Diana
    Byron Cottage
    17 North Road
    N6 4BD London
    Secrétaire
    Byron Cottage
    17 North Road
    N6 4BD London
    BritishDirector Of Administration71458830001
    SHORKEND, Albert
    The Old House Kings College London
    Kidderpore Avenue
    NW3 7SZ London
    Secrétaire
    The Old House Kings College London
    Kidderpore Avenue
    NW3 7SZ London
    British66952310002
    UNTERHALTER, Lionel
    41 Wentworth Road
    Golders Green
    NW11 0RT London
    Secrétaire
    41 Wentworth Road
    Golders Green
    NW11 0RT London
    British96272340001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secrétaire désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    BURGER, Paul Jeffrey
    33 Hollycroft Avenue
    NW3 7QJ London
    Administrateur
    33 Hollycroft Avenue
    NW3 7QJ London
    EnglandBritishDirector57783350002
    COHEN, Joy Audrey
    72 Viceroy Court
    Prince Albert Road
    NW8 7PS London
    Administrateur
    72 Viceroy Court
    Prince Albert Road
    NW8 7PS London
    BritishCo Director62614340001
    EREIRA, Russell Lawrence
    92 Clifton Hill
    St Johns Wood
    NW8 0JT London
    Administrateur
    92 Clifton Hill
    St Johns Wood
    NW8 0JT London
    BritishDirector34571750001
    FISHER, Wendy
    Ivy House
    94-96 North End Road
    NW11 7SX London
    Administrateur
    Ivy House
    94-96 North End Road
    NW11 7SX London
    United KingdomBritishClinical Psychologist126409230001
    FOGEL, Steven Andrew
    Dechert Llp
    160 Queen Victoria Street
    EC4B 4QQ London
    Administrateur
    Dechert Llp
    160 Queen Victoria Street
    EC4B 4QQ London
    BritishSolicitor41381590002
    GEE, Michael Joseph
    27 Berkeley House
    Hay Hill
    W1J 8NS London
    Administrateur
    27 Berkeley House
    Hay Hill
    W1J 8NS London
    United KingdomBritishCompany Director35542620002
    GOLD, Trudy Ann Marie
    N12 9RT London
    930 High Road
    United Kingdom
    Administrateur
    N12 9RT London
    930 High Road
    United Kingdom
    United KingdomBritishHistorian85001550001
    HELLER, Michael Aron, Sir
    Ivy House
    94-96 North End Road
    NW11 7SX London
    Administrateur
    Ivy House
    94-96 North End Road
    NW11 7SX London
    United KingdomBritishCompany Director44677700001
    KHALILI, Marion Sophie
    Balfour House
    1 Balfour Place
    W1Y 5RH London
    Administrateur
    Balfour House
    1 Balfour Place
    W1Y 5RH London
    United KingdomBritishDirector56877660001
    KON, Stephen David
    S J Berwin & Co
    10 Queen Street Place
    EC4R 1BE London
    Administrateur
    S J Berwin & Co
    10 Queen Street Place
    EC4R 1BE London
    EnglandBritishSolicitor40585680004
    LEVENE, Wendy Ann, Lady
    55 Cumberland
    Terrace Regents Park
    NW1 4HJ London
    Administrateur
    55 Cumberland
    Terrace Regents Park
    NW1 4HJ London
    United KingdomBritishMuseum Adviser28369800001
    LEWIS, David John
    N12 9RT London
    930 High Road
    United Kingdom
    Administrateur
    N12 9RT London
    930 High Road
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor1536210009
    MARKS, Adrianne Barbara Ellis, The Hon
    39 Farm Avenue
    NW2 2BJ London
    Administrateur
    39 Farm Avenue
    NW2 2BJ London
    BritishCompany Director41381400001
    MARKS, Clive Maurice
    1st Floor Lynton House
    7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Administrateur
    1st Floor Lynton House
    7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    BritishChartered Accountant107821580001
    MILLAN, Joanna Frances
    Ivy House
    94-96 North End Road
    NW11 7SX London
    Administrateur
    Ivy House
    94-96 North End Road
    NW11 7SX London
    United KingdomBritishRetired20073220001
    MITCHELL, Ashley Harvey
    28 Heath Drive
    NW3 7SB London
    Administrateur
    28 Heath Drive
    NW3 7SB London
    United KingdomBritishEntrepreneur1776820002
    MORGANTHAU, Allan Henry Simon
    26 Redington Road
    NW3 7RB London
    Administrateur
    26 Redington Road
    NW3 7RB London
    BritishCompany Director79975190001
    MUSGRAVE, Peter Alan
    4 Arnos Grove
    N14 7AS London
    Administrateur
    4 Arnos Grove
    N14 7AS London
    United KingdomBritishChartered Accountant101151130001
    MYERS, Sandra Hannah
    8 Birchwood Drive
    NW3 7NB London
    Administrateur
    8 Birchwood Drive
    NW3 7NB London
    EnglandBritishHousewife72881730001
    OLSWANG, Simon Myers
    1 Fordington Road
    Highgate
    N6 4TD London
    Administrateur
    1 Fordington Road
    Highgate
    N6 4TD London
    EnglandBritishSolicitor18139940001
    PISTOL, Neil George
    N12 9RT London
    930 High Road
    United Kingdom
    Administrateur
    N12 9RT London
    930 High Road
    United Kingdom
    United KingdomBritishMechanical Engineer168837190001
    ROSEFIELD, John Stuart Ian
    Ivy House
    94-96 North End Road
    NW11 7SX London
    Administrateur
    Ivy House
    94-96 North End Road
    NW11 7SX London
    United KingdomBritishFinance Director8320370001
    SALTER, Stanley Anthony
    Flat 2
    3 Stalbridge Street
    NW1 6TG London
    Administrateur
    Flat 2
    3 Stalbridge Street
    NW1 6TG London
    EnglandBritishAccountant79681150001
    TABATZNIK, Anthony Selwyn
    Ivy House
    94-96 North End Road
    NW11 7SX London
    Administrateur
    Ivy House
    94-96 North End Road
    NW11 7SX London
    United KingdomBritishCompany Director11841230002

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour THE LONDON JEWISH CULTURAL CENTRE ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    21 juil. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    THE LONDON JEWISH CULTURAL CENTRE a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 27 nov. 2014
    Livré le 01 déc. 2014
    En cours
    Brève description
    Ivy house, north end road, hendon, london l/h t/no AGL105841.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • James Paul Harding
    • Caroline Deletra
    • Melanie Sarah Jane Clore
    • Dame Vivien Louise Duffield
    Transactions
    • 01 déc. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • Plus de quatre personnes ayant droit Oui
    Legal charge
    Créé le 24 août 2012
    Livré le 07 sept. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    T/No AGL105841. Administrative area - barnet.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 sept. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 22 août 2012
    Livré le 29 août 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 21 févr. 2008
    Livré le 01 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 01 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 21 févr. 2008
    Livré le 01 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H land k/a ivy house 94-96 north end london t/no agl 105841 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 01 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 16 déc. 2004
    Livré le 24 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    L/H property k/a ivy house, north end road, hendon, barnet, london t/no. AGL105841 and all fixtures fittings and additions on or attached to the property together with all buildings and structures thereon.
    Personnes ayant droit
    • Anthony Selwyn Tabatznik
    Transactions
    • 24 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 16 déc. 2004
    Livré le 23 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    L/H property ivy house north end road hendon barnet london t/n AGL105841 and all fixtures fittings and additions.
    Personnes ayant droit
    • Abbey National PLC
    Transactions
    • 23 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0