THE LONDON JEWISH CULTURAL CENTRE
Vue d'ensemble
Nom de la société | THE LONDON JEWISH CULTURAL CENTRE |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social |
Numéro de société | 03811133 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe THE LONDON JEWISH CULTURAL CENTRE ?
Adresse du siège social | 930 High Road N12 9RT London United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de THE LONDON JEWISH CULTURAL CENTRE ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour THE LONDON JEWISH CULTURAL CENTRE ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 2 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Neil George Pistol en tant que directeur le 08 avr. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2018 | 16 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 juil. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2017 au 30 juin 2018 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 juil. 2017 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2016 | 19 pages | AA | ||||||||||
Période comptable actuelle raccourcie du 28 févr. 2017 au 31 déc. 2016 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 29 févr. 2016 | 23 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 juil. 2016 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Eldred Hyman Kraines en tant que secrétaire le 03 mars 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Alan Harvey Fell en tant que secrétaire le 03 mars 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Comptes consolidés établis au 28 févr. 2015 | 25 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de David John Lewis en tant que directeur le 28 août 2015 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Trudy Ann Marie Gold en tant que directeur le 09 sept. 2015 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Ivy House 94-96 North End Road London NW11 7SX à 930 High Road London N12 9RT le 05 août 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 21 juil. 2015 sans liste des membres | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 31 août 2014 au 28 févr. 2015 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Aron Heller en tant que directeur le 14 janv. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Inscription de la charge 038111330007, créée le 27 nov. 2014 | 26 pages | MR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Joanna Frances Millan en tant que directeur le 02 oct. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de THE LONDON JEWISH CULTURAL CENTRE ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELL, Alan Harvey | Secrétaire | IG8 0DG Woodford Green 28 Linden Crescent Essex United Kingdom | 205752270001 | |||||||
BLACK, Harry Sinclair | Administrateur | N12 9RT London 930 High Road United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 11979600002 | ||||
BRILL, Alan Michael | Administrateur | N12 9RT London 930 High Road United Kingdom | United Kingdom | British | Retired | 45388860001 | ||||
COHEN, Des | Administrateur | N12 9RT London 930 High Road United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 34037680001 | ||||
MARX, Michael Henry | Administrateur | N12 9RT London 930 High Road United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 35019090001 | ||||
HOROWITZ, David | Secrétaire | 57 Hartland Drive HA8 8RJ Edgware Middlesex | British | Accountant | 93625650001 | |||||
KRAINES, Eldred Hyman | Secrétaire | N12 9RT London 930 High Road United Kingdom | British | Consultant | 75673190001 | |||||
MOCATTA, Diana | Secrétaire | Byron Cottage 17 North Road N6 4BD London | British | Director Of Administration | 71458830001 | |||||
SHORKEND, Albert | Secrétaire | The Old House Kings College London Kidderpore Avenue NW3 7SZ London | British | 66952310002 | ||||||
UNTERHALTER, Lionel | Secrétaire | 41 Wentworth Road Golders Green NW11 0RT London | British | 96272340001 | ||||||
COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||
BURGER, Paul Jeffrey | Administrateur | 33 Hollycroft Avenue NW3 7QJ London | England | British | Director | 57783350002 | ||||
COHEN, Joy Audrey | Administrateur | 72 Viceroy Court Prince Albert Road NW8 7PS London | British | Co Director | 62614340001 | |||||
EREIRA, Russell Lawrence | Administrateur | 92 Clifton Hill St Johns Wood NW8 0JT London | British | Director | 34571750001 | |||||
FISHER, Wendy | Administrateur | Ivy House 94-96 North End Road NW11 7SX London | United Kingdom | British | Clinical Psychologist | 126409230001 | ||||
FOGEL, Steven Andrew | Administrateur | Dechert Llp 160 Queen Victoria Street EC4B 4QQ London | British | Solicitor | 41381590002 | |||||
GEE, Michael Joseph | Administrateur | 27 Berkeley House Hay Hill W1J 8NS London | United Kingdom | British | Company Director | 35542620002 | ||||
GOLD, Trudy Ann Marie | Administrateur | N12 9RT London 930 High Road United Kingdom | United Kingdom | British | Historian | 85001550001 | ||||
HELLER, Michael Aron, Sir | Administrateur | Ivy House 94-96 North End Road NW11 7SX London | United Kingdom | British | Company Director | 44677700001 | ||||
KHALILI, Marion Sophie | Administrateur | Balfour House 1 Balfour Place W1Y 5RH London | United Kingdom | British | Director | 56877660001 | ||||
KON, Stephen David | Administrateur | S J Berwin & Co 10 Queen Street Place EC4R 1BE London | England | British | Solicitor | 40585680004 | ||||
LEVENE, Wendy Ann, Lady | Administrateur | 55 Cumberland Terrace Regents Park NW1 4HJ London | United Kingdom | British | Museum Adviser | 28369800001 | ||||
LEWIS, David John | Administrateur | N12 9RT London 930 High Road United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 1536210009 | ||||
MARKS, Adrianne Barbara Ellis, The Hon | Administrateur | 39 Farm Avenue NW2 2BJ London | British | Company Director | 41381400001 | |||||
MARKS, Clive Maurice | Administrateur | 1st Floor Lynton House 7-12 Tavistock Square WC1H 9LT London | British | Chartered Accountant | 107821580001 | |||||
MILLAN, Joanna Frances | Administrateur | Ivy House 94-96 North End Road NW11 7SX London | United Kingdom | British | Retired | 20073220001 | ||||
MITCHELL, Ashley Harvey | Administrateur | 28 Heath Drive NW3 7SB London | United Kingdom | British | Entrepreneur | 1776820002 | ||||
MORGANTHAU, Allan Henry Simon | Administrateur | 26 Redington Road NW3 7RB London | British | Company Director | 79975190001 | |||||
MUSGRAVE, Peter Alan | Administrateur | 4 Arnos Grove N14 7AS London | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 101151130001 | ||||
MYERS, Sandra Hannah | Administrateur | 8 Birchwood Drive NW3 7NB London | England | British | Housewife | 72881730001 | ||||
OLSWANG, Simon Myers | Administrateur | 1 Fordington Road Highgate N6 4TD London | England | British | Solicitor | 18139940001 | ||||
PISTOL, Neil George | Administrateur | N12 9RT London 930 High Road United Kingdom | United Kingdom | British | Mechanical Engineer | 168837190001 | ||||
ROSEFIELD, John Stuart Ian | Administrateur | Ivy House 94-96 North End Road NW11 7SX London | United Kingdom | British | Finance Director | 8320370001 | ||||
SALTER, Stanley Anthony | Administrateur | Flat 2 3 Stalbridge Street NW1 6TG London | England | British | Accountant | 79681150001 | ||||
TABATZNIK, Anthony Selwyn | Administrateur | Ivy House 94-96 North End Road NW11 7SX London | United Kingdom | British | Company Director | 11841230002 |
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour THE LONDON JEWISH CULTURAL CENTRE ?
Notifié le | Cessé le | Déclaration |
---|---|---|
21 juil. 2016 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
THE LONDON JEWISH CULTURAL CENTRE a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 27 nov. 2014 Livré le 01 déc. 2014 | En cours | ||
Brève description Ivy house, north end road, hendon, london l/h t/no AGL105841. Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
Legal charge | Créé le 24 août 2012 Livré le 07 sept. 2012 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions T/No AGL105841. Administrative area - barnet. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 22 août 2012 Livré le 29 août 2012 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 21 févr. 2008 Livré le 01 mars 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 21 févr. 2008 Livré le 01 mars 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions L/H land k/a ivy house 94-96 north end london t/no agl 105841 see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 16 déc. 2004 Livré le 24 déc. 2004 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions L/H property k/a ivy house, north end road, hendon, barnet, london t/no. AGL105841 and all fixtures fittings and additions on or attached to the property together with all buildings and structures thereon. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 16 déc. 2004 Livré le 23 déc. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions L/H property ivy house north end road hendon barnet london t/n AGL105841 and all fixtures fittings and additions. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0