CASH CENTRES CORPORATION LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CASH CENTRES CORPORATION LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03812121 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CASH CENTRES CORPORATION LIMITED ?
| Adresse du siège social | 15th Floor, 6 Bevis Marks EC3A 7BA London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CASH CENTRES CORPORATION LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2021 |
Quels sont les derniers dépôts pour CASH CENTRES CORPORATION LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2022 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
État du capital au 08 avr. 2022
| 7 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Sheraz Afzal en tant que directeur le 06 avr. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Ms Marie-Anne Bousaba en tant qu'administrateur le 29 mars 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2021 | 7 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2020 | 7 pages | AA | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Unit 1 Castle Marina Road Nottingham NG7 1TN England à 15th Floor, 6 Bevis Marks London EC3A 7BA le 12 nov. 2020 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2019 | 7 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Alpesh Kumar Patel en tant que directeur le 07 oct. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Sheraz Afzal en tant qu'administrateur le 07 oct. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Browne Jacobson Llp Cardinal House Abbeyfield Road Nottingham NG7 2SZ England à Unit 1 Castle Marina Road Nottingham NG7 1TN | 1 pages | AD02 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Alpesh Kumar Patel en tant qu'administrateur le 22 mars 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Kevin Richard Kaye en tant que directeur le 22 mars 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2018 | 7 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Tony Deakin en tant que directeur le 01 déc. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de CASH CENTRES CORPORATION LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUSABA, Marie-Anne | Administrateur | 6 Bevis Marks EC3A 7BA London 15th Floor, England | United Kingdom | Australian | 293005440001 | |||||
| BIONDI, Lorna | Secrétaire | Abbeyfield Road NG7 2SZ Nottingham Cardinal House England | 196288610001 | |||||||
| MCKENZIE, Robbie | Secrétaire | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | 195401990001 | |||||||
| PRIOR, Mark Lee | Secrétaire | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | 178098760001 | |||||||
| SOKOLOWSKI, Peter John | Secrétaire | 208 Rively Avenue Collingdale Pennsylvannia 19023 Usa | American | 68054300001 | ||||||
| TANG, Renold Lee On | Secrétaire | Treetops The Close Sway SO41 6ED Lymington Hampshire | British | 2071760001 | ||||||
| WALTON, Caroline Debra | Secrétaire | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | British | 58608750003 | ||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
| AFZAL, Sheraz | Administrateur | 6 Bevis Marks EC3A 7BA London 15th Floor, England | United Kingdom | British | 251073350001 | |||||
| COHEN, Scott Aaron | Administrateur | Abbeyfield Road NG7 2SZ Nottingham Cardinal House England | United States | American | 209567180001 | |||||
| COREPAL, Sanjiv Kumar | Administrateur | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | United Kingdom | British | 205239750001 | |||||
| DEAKIN, Tony | Administrateur | Castle Marina Road NG7 1TN Nottingham Unit 1 England | England | British | 210862440001 | |||||
| DORFMAN, Richard Seth | Administrateur | 9 Pleasant Court Medford FOREIGN Newjersey 08055 Usa | American | 67599880001 | ||||||
| ERICKSON, Eric George | Administrateur | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | Usa | Usa | 224104020001 | |||||
| FILECCIA, Piero | Administrateur | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | England | British | 116096800001 | |||||
| FORD, Edward Frederick Arthur | Administrateur | Flat 44 Waterloo Warehouse Waterloo Road L3 0BG Liverpool Merseyside | Gibralta | British | 65311240001 | |||||
| GAYHARDT, Donald Francis | Administrateur | 511 Lynmere Road Brynmawr FOREIGN Pennsylvannia 19010 Usa | United States | American | 67600210001 | |||||
| HETHERINGTON, Cameron John | Administrateur | 3 Barculdie Crescent QLD 4508 Deception Bay Queensland Australia | Australian | 123428110001 | ||||||
| HIBBERD, Roy Wayne | Administrateur | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | Usa | United States | 158609380001 | |||||
| KAYE, Kevin Richard | Administrateur | Castle Marina Road NG7 1TN Nottingham Unit 1 England | England | British | 257480610001 | |||||
| MILDENSTEIN, Paul | Administrateur | The Barn Redhouse Farm Redhouse Farm Lane CV35 7NZ Beausale 2 Warwickshire | England | British | 158561370001 | |||||
| NUSSBAUM, Bennett Lawrence | Administrateur | 1436 Lancaster Avenue 19312 Berwyn Dfg World Pa Usa | Usa | American | 192429350001 | |||||
| PATEL, Alpesh Kumar | Administrateur | Castle Marina Road NG7 1TN Nottingham Unit 1 England | England | British | 193008350001 | |||||
| PICCINI, Silvio Dante | Administrateur | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | England | American | 129300540002 | |||||
| PRIOR, Mark Lee | Administrateur | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | Usa | American | 177845480001 | |||||
| TANG, Renold Lee On | Administrateur | Treetops The Close Sway SO41 6ED Lymington Hampshire | British | 2071760001 | ||||||
| UNDERWOOD, Randy | Administrateur | Lancaster Avenue Suite 300 19312 Berwyn 1436 Usa | Usa | United States | 134174560001 | |||||
| WEISS, Jeffrey Allan | Administrateur | Lancaster Avenue Suite 300 19312 Berwyn 1436 Usa | Usa | United States | 151303310006 | |||||
| WATERLOW NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CASH CENTRES CORPORATION LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurajoki Europe Limited | 30 juin 2017 | Abbeyfield Court Abbeyfield Road NG7 2SZ Nottingham Cardinal House United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Dollar Financial U.K. Limited | 06 avr. 2016 | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 Bevis Marks England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
CASH CENTRES CORPORATION LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Créé le 07 mars 2008 Livré le 13 mars 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 07 mars 2008 Livré le 13 mars 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 30 oct. 2006 Livré le 11 nov. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the non-us charging companies to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Pledge and security agreement | Créé le 15 déc. 1999 Livré le 18 déc. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti The obligations due or to become due from the company to the chargee under the guaranty and guarantor security agreements | |
Brèves mentions Interest over all shares in the company all voting and non-voting rights of the shares and all cash and non-cash dividends and all other property chattels contracts intangibles goods of the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0