CASH CENTRES CORPORATION LIMITED

CASH CENTRES CORPORATION LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCASH CENTRES CORPORATION LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03812121
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CASH CENTRES CORPORATION LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe CASH CENTRES CORPORATION LIMITED ?

    Adresse du siège social
    15th Floor, 6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CASH CENTRES CORPORATION LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour CASH CENTRES CORPORATION LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2022 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    État du capital au 08 avr. 2022

    • Capital: GBP 5.77290
    7 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduce share prem a/c 07/04/2022
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Sheraz Afzal en tant que directeur le 06 avr. 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de Ms Marie-Anne Bousaba en tant qu'administrateur le 29 mars 2022

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2021

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2020

    7 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Unit 1 Castle Marina Road Nottingham NG7 1TN England à 15th Floor, 6 Bevis Marks London EC3A 7BA le 12 nov. 2020

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2019

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Alpesh Kumar Patel en tant que directeur le 07 oct. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Sheraz Afzal en tant qu'administrateur le 07 oct. 2019

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Browne Jacobson Llp Cardinal House Abbeyfield Road Nottingham NG7 2SZ England à Unit 1 Castle Marina Road Nottingham NG7 1TN

    1 pagesAD02

    Nomination de Mr Alpesh Kumar Patel en tant qu'administrateur le 22 mars 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kevin Richard Kaye en tant que directeur le 22 mars 2019

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2018

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Tony Deakin en tant que directeur le 01 déc. 2018

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de CASH CENTRES CORPORATION LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BOUSABA, Marie-Anne
    6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    15th Floor,
    England
    Administrateur
    6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    15th Floor,
    England
    United KingdomAustralian293005440001
    BIONDI, Lorna
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Cardinal House
    England
    Secrétaire
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Cardinal House
    England
    196288610001
    MCKENZIE, Robbie
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    Secrétaire
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    195401990001
    PRIOR, Mark Lee
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    Secrétaire
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    178098760001
    SOKOLOWSKI, Peter John
    208 Rively Avenue
    Collingdale
    Pennsylvannia 19023
    Usa
    Secrétaire
    208 Rively Avenue
    Collingdale
    Pennsylvannia 19023
    Usa
    American68054300001
    TANG, Renold Lee On
    Treetops The Close
    Sway
    SO41 6ED Lymington
    Hampshire
    Secrétaire
    Treetops The Close
    Sway
    SO41 6ED Lymington
    Hampshire
    British2071760001
    WALTON, Caroline Debra
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    Secrétaire
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    British58608750003
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secrétaire désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    AFZAL, Sheraz
    6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    15th Floor,
    England
    Administrateur
    6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    15th Floor,
    England
    United KingdomBritish251073350001
    COHEN, Scott Aaron
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Cardinal House
    England
    Administrateur
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Cardinal House
    England
    United StatesAmerican209567180001
    COREPAL, Sanjiv Kumar
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    Administrateur
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    United KingdomBritish205239750001
    DEAKIN, Tony
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    Administrateur
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    EnglandBritish210862440001
    DORFMAN, Richard Seth
    9 Pleasant Court
    Medford
    FOREIGN Newjersey 08055
    Usa
    Administrateur
    9 Pleasant Court
    Medford
    FOREIGN Newjersey 08055
    Usa
    American67599880001
    ERICKSON, Eric George
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    Administrateur
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    UsaUsa224104020001
    FILECCIA, Piero
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    Administrateur
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    EnglandBritish116096800001
    FORD, Edward Frederick Arthur
    Flat 44 Waterloo Warehouse
    Waterloo Road
    L3 0BG Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    Flat 44 Waterloo Warehouse
    Waterloo Road
    L3 0BG Liverpool
    Merseyside
    GibraltaBritish65311240001
    GAYHARDT, Donald Francis
    511 Lynmere Road
    Brynmawr
    FOREIGN Pennsylvannia 19010
    Usa
    Administrateur
    511 Lynmere Road
    Brynmawr
    FOREIGN Pennsylvannia 19010
    Usa
    United StatesAmerican67600210001
    HETHERINGTON, Cameron John
    3 Barculdie Crescent
    QLD 4508 Deception Bay
    Queensland
    Australia
    Administrateur
    3 Barculdie Crescent
    QLD 4508 Deception Bay
    Queensland
    Australia
    Australian123428110001
    HIBBERD, Roy Wayne
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    Administrateur
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    UsaUnited States158609380001
    KAYE, Kevin Richard
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    Administrateur
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    EnglandBritish257480610001
    MILDENSTEIN, Paul
    The Barn Redhouse Farm
    Redhouse Farm Lane
    CV35 7NZ Beausale
    2
    Warwickshire
    Administrateur
    The Barn Redhouse Farm
    Redhouse Farm Lane
    CV35 7NZ Beausale
    2
    Warwickshire
    EnglandBritish158561370001
    NUSSBAUM, Bennett Lawrence
    1436 Lancaster Avenue
    19312 Berwyn
    Dfg World
    Pa
    Usa
    Administrateur
    1436 Lancaster Avenue
    19312 Berwyn
    Dfg World
    Pa
    Usa
    UsaAmerican192429350001
    PATEL, Alpesh Kumar
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    Administrateur
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    EnglandBritish193008350001
    PICCINI, Silvio Dante
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    Administrateur
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    EnglandAmerican129300540002
    PRIOR, Mark Lee
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    Administrateur
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    UsaAmerican177845480001
    TANG, Renold Lee On
    Treetops The Close
    Sway
    SO41 6ED Lymington
    Hampshire
    Administrateur
    Treetops The Close
    Sway
    SO41 6ED Lymington
    Hampshire
    British2071760001
    UNDERWOOD, Randy
    Lancaster Avenue
    Suite 300
    19312 Berwyn
    1436
    Usa
    Administrateur
    Lancaster Avenue
    Suite 300
    19312 Berwyn
    1436
    Usa
    UsaUnited States134174560001
    WEISS, Jeffrey Allan
    Lancaster Avenue
    Suite 300
    19312 Berwyn
    1436
    Usa
    Administrateur
    Lancaster Avenue
    Suite 300
    19312 Berwyn
    1436
    Usa
    UsaUnited States151303310006
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Administrateur désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CASH CENTRES CORPORATION LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Aurajoki Europe Limited
    Abbeyfield Court
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Cardinal House
    United Kingdom
    30 juin 2017
    Abbeyfield Court
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Cardinal House
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementRegistrar Of Companies England & Wales
    Numéro d'enregistrement07838968
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Dollar Financial U.K. Limited
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6 Bevis Marks
    England
    06 avr. 2016
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6 Bevis Marks
    England
    Oui
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleEnglish Law
    Lieu d'enregistrementRegister Of Uk Companies, Companies House
    Numéro d'enregistrement03701758
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    CASH CENTRES CORPORATION LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 07 mars 2008
    Livré le 13 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 07 mars 2008
    Livré le 13 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 30 oct. 2006
    Livré le 11 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the non-us charging companies to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Bank, National Association as Security Trustee
    Transactions
    • 11 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Pledge and security agreement
    Créé le 15 déc. 1999
    Livré le 18 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The obligations due or to become due from the company to the chargee under the guaranty and guarantor security agreements
    Brèves mentions
    Interest over all shares in the company all voting and non-voting rights of the shares and all cash and non-cash dividends and all other property chattels contracts intangibles goods of the company.
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Bank National Association (As Administrative Agent for Itself and the Lenders)
    Transactions
    • 18 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0