ALMA PRODUCTION UK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéALMA PRODUCTION UK LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03818844
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ALMA PRODUCTION UK LIMITED ?

    • Activités de production de films cinématographiques (59111) / Information et communication

    Où se situe ALMA PRODUCTION UK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    12 The Rookery
    OX5 1AW Kidlington
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ALMA PRODUCTION UK LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TOOMRANGE LIMITED03 août 199903 août 1999

    Quels sont les derniers comptes de ALMA PRODUCTION UK LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour ALMA PRODUCTION UK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01
    X8EVD022

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 2

    2 pagesMR05
    X8EVCRDE

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 3

    2 pagesMR05
    X8EVCS7M

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 4

    2 pagesMR05
    X8EVCUAH

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 4

    2 pagesMR05
    X8EVCUGI

    Changement d'adresse du siège social de 26 Appleton Road Cumnor Oxford OX2 9QH England à 12 the Rookery Kidlington OX5 1AW le 09 sept. 2019

    1 pagesAD01
    X8DLVX9F

    Déclaration de confirmation établie le 03 août 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X8DLVWNC

    Comptes de micro-entité établis au 31 janv. 2018

    3 pagesAA
    X7FG2LBS

    Déclaration de confirmation établie le 03 août 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X7C76IEZ

    Comptes de micro-entité établis au 31 janv. 2017

    4 pagesAA
    X6HBBVWB

    Changement d'adresse du siège social de 19 Hill Top Road Oxford OX4 1PB à 26 Appleton Road Cumnor Oxford OX2 9QH le 21 sept. 2017

    1 pagesAD01
    X6FEOFE2

    Notification de David John Christopher Marlow en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC01
    X6D009M2

    Déclaration de confirmation établie le 03 août 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X6D00MTK

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 janv. 2016

    6 pagesAA
    X5GDS8ED

    Déclaration de confirmation établie le 03 août 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01
    X5D9M58J

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 janv. 2015

    5 pagesAA
    A4IT2DTN

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 sept. 2015

    État du capital au 21 sept. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01
    X4GDJ1V4

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 janv. 2014

    8 pagesAA
    A3I3RVTU

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 août 2014

    État du capital au 29 août 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01
    X3FA31OB

    Cessation de la nomination de Dlc Company Services Limited en tant que secrétaire le 01 août 2014

    1 pagesTM02
    X3FA31N7

    Cessation de la nomination de Dlc Company Services Limited en tant que secrétaire le 01 août 2014

    1 pagesTM02
    X3FA2ZS1

    Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2013

    13 pagesAA
    A2J2PGHT

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 août 2013

    État du capital au 27 août 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01
    X2FN1MFK

    Qui sont les dirigeants de ALMA PRODUCTION UK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MARLOW, David John Christopher
    Hill Top Road
    OX4 1PB Oxford
    19
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hill Top Road
    OX4 1PB Oxford
    19
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandUnited KingdomProducer22267750002
    DLC COMPANY SERVICES LIMITED
    Old Burlington Street
    W1S 3NL London
    30
    United Kingdom
    Secrétaire
    Old Burlington Street
    W1S 3NL London
    30
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement012383683
    10023840003
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secrétaire désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BIMLER, Margit, Md
    Weinschenkstr 4a
    Munich
    FOREIGN Bavaria
    80999
    Germany
    Administrateur
    Weinschenkstr 4a
    Munich
    FOREIGN Bavaria
    80999
    Germany
    GermanFilm Sales69996650001
    GEEVES-BOOTH, David Noel
    2 Mount Zion
    Castle Lane
    SS7 2AR Benfleet
    Essex
    Administrateur
    2 Mount Zion
    Castle Lane
    SS7 2AR Benfleet
    Essex
    BritishWriter/Actor54882250002
    MORGAN, Leon Rhys
    1 Old Burlington Street
    W1X 1LA London
    Administrateur
    1 Old Burlington Street
    W1X 1LA London
    BritishSolicitor17832630001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Administrateur désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ALMA PRODUCTION UK LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr David John Christopher Marlow
    Hill Top Road
    OX4 1PB Oxford
    19
    England
    06 avr. 2016
    Hill Top Road
    OX4 1PB Oxford
    19
    England
    Non
    Nationalité: United Kingdom
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour ALMA PRODUCTION UK LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    03 août 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    ALMA PRODUCTION UK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Pledge agreement
    Créé le 21 déc. 2000
    Livré le 11 janv. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the pledgor to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of guarantees entered into by the pledgee or,as the case may be,under any of the pledge agreement and the deposit agreement
    Brèves mentions
    The sum of gbp 7,225,373.19 deposit in account number 56.54.64.779 in respect of the lease agreement relating to "bride of the wind" and all present and future right,title and interest in and to future payments deposited in credited to or standing to the credit of the account and any and all earnings and interest thereon and any proceeds thereof.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank N.V.
    Transactions
    • 11 janv. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2019L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    • 27 sept. 2019L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    Deed of charge and assignment
    Créé le 16 oct. 2000
    Livré le 20 oct. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under and pursuant to a). A loan and security agreement dated 7TH august 2000 between the company and firelight entertainment gmbh as borrowers and the bank and b). The charge
    Brèves mentions
    All the company's right title benefit and interest in and to the film tentatively entitled "bride of the wind" and all related rights and assets of the company pursuant to the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag
    Transactions
    • 20 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2019L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    Charge
    Créé le 27 juin 2000
    Livré le 22 sept. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement of even date
    Brèves mentions
    The film, the rights, the distribution agreements and all alma productions UK limited right, title benefit and interest. All sums payable and the proceeds of any insurance policies. All sums standing to the credit of the company in any bank account.
    Personnes ayant droit
    • Grosvenor Park Media Limited
    Transactions
    • 22 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2019L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    Charge
    Créé le 06 juin 2000
    Livré le 15 juin 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The amount owing from time to time under a financing agreement (as defined) being an initial sum of us$3,143,794 and any further sum contributed by the chargee under the aforementioned financing agreement
    Brèves mentions
    The film being the motion picture provisionally entitled "bride of the wind" and all rights etc in connection therewith.
    Personnes ayant droit
    • Total Film Group, Inc
    Transactions
    • 15 juin 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0