MANLON PROPERTY SERVICES LTD

MANLON PROPERTY SERVICES LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMANLON PROPERTY SERVICES LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03819597
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MANLON PROPERTY SERVICES LTD ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction
    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières
    • Administration de biens immobiliers pour compte de tiers (68320) / Activités immobilières

    Où se situe MANLON PROPERTY SERVICES LTD ?

    Adresse du siège social
    657 Liverpool Road
    Irlam
    M44 5XD Manchester
    Lancashire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de MANLON PROPERTY SERVICES LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour MANLON PROPERTY SERVICES LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes de micro-entité établis au 30 sept. 2018

    5 pagesAA

    Période comptable précédente prolongée du 31 août 2018 au 30 sept. 2018

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 23 oct. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 04 août 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 août 2017

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 août 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 août 2016

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 août 2016 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2015

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 oct. 2015

    État du capital au 01 oct. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2014

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 oct. 2014

    État du capital au 21 oct. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2013

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 août 2013

    État du capital au 06 août 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2012

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2011

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Michael Lewandowski en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2010

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2009

    7 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 28 févr. 2010 au 31 août 2009

    1 pagesAA01

    Qui sont les dirigeants de MANLON PROPERTY SERVICES LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILLIAMS, Ernest
    14 Braemar Drive
    Sale
    M33 4NJ Manchester
    Secrétaire
    14 Braemar Drive
    Sale
    M33 4NJ Manchester
    British83474900001
    WILLIAMS, Ernest
    14 Braemar Drive
    Sale
    M33 4NJ Manchester
    Administrateur
    14 Braemar Drive
    Sale
    M33 4NJ Manchester
    United KingdomBritish83474900001
    HODGKINSON, Paul Roger Dudley
    178b Kingston Lane
    Teddington
    TW11 9HD London
    Secrétaire
    178b Kingston Lane
    Teddington
    TW11 9HD London
    British93988900001
    QADUS, Shahena
    86 Park Road
    Stretford
    M32 8FD Manchester
    Secrétaire
    86 Park Road
    Stretford
    M32 8FD Manchester
    British73869660002
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Secrétaire désigné
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900014000001
    ABID, Shirko
    10 Fir Avenue
    Bramhall
    SK7 2NR Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    10 Fir Avenue
    Bramhall
    SK7 2NR Stockport
    Cheshire
    IraqIraqi34442520005
    LEWANDOWSKI, Michael
    11 South Drive
    Chorlton Ville
    M21 8DX Manchester
    Administrateur
    11 South Drive
    Chorlton Ville
    M21 8DX Manchester
    British73869740002
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Administrateur désigné
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900013990001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MANLON PROPERTY SERVICES LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Ernest Williams
    Sale
    M33 4NJ Manchester
    14 Braemar Drive
    Greater Manchester
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Sale
    M33 4NJ Manchester
    14 Braemar Drive
    Greater Manchester
    United Kingdom
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    MANLON PROPERTY SERVICES LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 09 janv. 2007
    Livré le 11 janv. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 07 août 2006
    Livré le 10 août 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    98 neston st,openshaw manchester M11 1HZ. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 08 mars 2006
    Livré le 14 mars 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    7 westminster avenue whalley range manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 01 sept. 2004
    Livré le 11 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property k/a 12 hollybush street abbey hey manchester. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 11 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 01 sept. 2004
    Livré le 11 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 50 whiteley street clayton manchester. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 11 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 29 déc. 2003
    Livré le 03 janv. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 6 wistaria road, manchester. T/n GM944285. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 03 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 03 sept. 2002
    Livré le 18 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    348 barlow moor road chorlton cum hardy manchester M21. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 18 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 mai 2002
    Livré le 24 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 24 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0