CRS BIO LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | CRS BIO LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03820032 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CRS BIO LIMITED ?
Adresse du siège social | The Platinum Building St Johns Innovation Park Cowley Road CB4 0DS Cambridge |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CRS BIO LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 avr. 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour CRS BIO LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers | 10 pages | LIQ14 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Déclaration des affaires | 7 pages | LIQ02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 10 the Triangle Ng2 Business Park Nottingham Nottinghamshire NG2 1AE United Kingdom à The Platinum Building St Johns Innovation Park Cowley Road Cambridge CB4 0DS le 04 juin 2017 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement | 5 pages | NDISC | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
La procédure de radiation d'office a été suspendue | 1 pages | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Cessation de la nomination de Bio Ad Limited en tant que directeur le 24 mars 2017 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Bio Group Limited en tant que directeur le 24 mars 2017 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Steven Sharratt en tant qu'administrateur le 24 mars 2017 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Steven Sharratt en tant que directeur le 20 janv. 2017 | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Bio Group Limited en tant qu'administrateur le 20 janv. 2017 | 3 pages | AP02 | ||||||||||
Nomination de Bio Ad Limited en tant qu'administrateur le 20 janv. 2017 | 3 pages | AP02 | ||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de , Unit 14 Ip City Centre, 1 Bath Street, Ipswich, Suffolk, IP2 8SD à 10 the Triangle Ng2 Business Park Nottingham Nottinghamshire NG2 1AE le 02 févr. 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2015 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2014 | 7 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de , C/O Miller Wash Associates Llp, 70-72 the Havens Unit 6 Basepoint House 70-72 the Havens, Ransomes Europark, Ipswich, IP3 9SJ à 10 the Triangle Ng2 Business Park Nottingham Nottinghamshire NG2 1AE le 23 oct. 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 juin 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2013 | 7 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CRS BIO LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHARRATT, Steven | Administrateur | St Johns Innovation Park Cowley Road CB4 0DS Cambridge The Platinum Building | England | British | None | 41673070005 | ||||||||
CHALLIS, Robert John | Secrétaire | 1 Cherry Orchard Oakington CB4 5AY Cambridge Cambridgeshire | British | Business Manager | 2953050001 | |||||||||
GERAGHTY, Paul Kevin Ian | Secrétaire | Monkwood Cottage Whitakers Way IG10 1SQ Loughton Essex | British | Accountant | 86029660001 | |||||||||
MULLETT, John Anderson James | Secrétaire | 31 Long Lane Willingham CB4 5LB Cambridge Cambridgeshire | British | Director | 59916040002 | |||||||||
MULLETT, John Anderson James | Secrétaire | 31 Long Lane Willingham CB4 5LB Cambridge Cambridgeshire | British | Director | 59916040002 | |||||||||
READYMADE SECRETARIES LTD | Secrétaire désigné | Ground Floor 334 Whitchurch Road CF4 3NG Cardiff | 900013920001 | |||||||||||
BELL, Steven John | Administrateur | Willingham House Flexon Business Park CB6 3RY Stretham Road Wilburton Cambridgeshire | United Kingdom | British | Chief Operating Officer | 148954950001 | ||||||||
BISHOP, Hugh William | Administrateur | Barnside 50 High Street MK44 1PF Sharnbrook Bedfordshire | England | British | Managing Director | 94622690001 | ||||||||
CHALLIS, Robert John | Administrateur | 1 Cherry Orchard Oakington CB4 5AY Cambridge Cambridgeshire | British | Business Manager | 2953050001 | |||||||||
DAVENPORT, Mark Edward | Administrateur | Alboro House Twentypence Road Cottenham CB4 8PS Cambridge | United Kingdom | British | Business Manager | 16640010002 | ||||||||
DOWNES, David John | Administrateur | Holden Brook New Barn Lane RH5 5PF Ockley Surrey | United Kingdom | British | Director | 37289200002 | ||||||||
FIELD, Christopher Charles | Administrateur | 4 Broad Road Cottages The Green Little Thurlow CB9 7JJ Haverhill Suffolk | England | British | Recycling Manager | 99183300003 | ||||||||
FLORINGER, Brian James | Administrateur | Northfield Road Forncett St. Peter NR16 1JY Norwich Horseshoe Barn England | United Kingdom | British | Accountant | 125389740001 | ||||||||
GERAGHTY, Paul Kevin Ian | Administrateur | Monkwood Cottage Whitakers Way IG10 1SQ Loughton Essex | United Kingdom | British | Accountant | 86029660001 | ||||||||
GOLDEN, Gerard Anthony | Administrateur | 2 Jubilee Gardens Bearsden G61 2RT Glasgow Lanarkshire | England | British | Managing Director | 71221940004 | ||||||||
MULLETT, John Anderson James | Administrateur | 31 Long Lane Willingham CB4 5LB Cambridge Cambridgeshire | United Kingdom | British | Manager | 59916040002 | ||||||||
SHARRATT, Steven | Administrateur | Cratfield Road Fressingfield IP21 5SH Eye Gissings Farm Suffolk | England | British | Business Consultans | 41673070005 | ||||||||
BIO AD LIMITED | Administrateur | The Triangle Ng2 Business Oark NG2 1AE Nottingham 10 |
| 225085100001 | ||||||||||
BIO GROUP LIMITED | Administrateur | The Triangle Ng2 Business Park NG2 1AE Nottingham 10 |
| 225122200001 | ||||||||||
READYMADE NOMINEES LTD | Administrateur désigné | Ground Floor 334 Whitchurch Road CF4 3NG Cardiff | 900013910001 |
CRS BIO LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Charge of deposit | Créé le 08 avr. 2010 Livré le 13 avr. 2010 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The deposit initially of £227,000 credited to account designation number 22922532 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge of deposit | Créé le 08 avr. 2010 Livré le 13 avr. 2010 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The deposit initially of £50,000 credited to account designation number 22922559 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Chattel mortgage | Créé le 28 déc. 2005 Livré le 29 déc. 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Crossfield-waste auto feed system - s/no: crs 2005/101. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 02 juil. 2004 Livré le 20 juil. 2004 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 16 août 2002 Livré le 20 août 2002 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
CRS BIO LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Creditors voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0