CRS BIO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCRS BIO LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03820032
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CRS BIO LIMITED ?

    • Récupération de matériaux triés (38320) / Approvisionnement en eau, assainissement, gestion des déchets et activités de dépollution

    Où se situe CRS BIO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Platinum Building St Johns Innovation Park
    Cowley Road
    CB4 0DS Cambridge
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CRS BIO LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CAMBRIDGE RECYCLING SERVICES LTD05 août 199905 août 1999

    Quels sont les derniers comptes de CRS BIO LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour CRS BIO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    10 pagesLIQ14

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration des affaires

    7 pagesLIQ02

    Changement d'adresse du siège social de 10 the Triangle Ng2 Business Park Nottingham Nottinghamshire NG2 1AE United Kingdom à The Platinum Building St Johns Innovation Park Cowley Road Cambridge CB4 0DS le 04 juin 2017

    2 pagesAD01

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    5 pagesNDISC

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 10 mai 2017

    LRESEX

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Cessation de la nomination de Bio Ad Limited en tant que directeur le 24 mars 2017

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Bio Group Limited en tant que directeur le 24 mars 2017

    2 pagesTM01

    Nomination de Mr Steven Sharratt en tant qu'administrateur le 24 mars 2017

    3 pagesAP01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Steven Sharratt en tant que directeur le 20 janv. 2017

    2 pagesTM01

    Nomination de Bio Group Limited en tant qu'administrateur le 20 janv. 2017

    3 pagesAP02

    Nomination de Bio Ad Limited en tant qu'administrateur le 20 janv. 2017

    3 pagesAP02

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 oct. 2016

    État du capital au 12 oct. 2016

    • Capital: GBP 1,775,000
    SH01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Changement d'adresse du siège social de , Unit 14 Ip City Centre, 1 Bath Street, Ipswich, Suffolk, IP2 8SD à 10 the Triangle Ng2 Business Park Nottingham Nottinghamshire NG2 1AE le 02 févr. 2016

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2015

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 août 2015

    État du capital au 10 août 2015

    • Capital: GBP 1,775,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2014

    7 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de , C/O Miller Wash Associates Llp, 70-72 the Havens Unit 6 Basepoint House 70-72 the Havens, Ransomes Europark, Ipswich, IP3 9SJ à 10 the Triangle Ng2 Business Park Nottingham Nottinghamshire NG2 1AE le 23 oct. 2014

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 oct. 2014

    État du capital au 05 oct. 2014

    • Capital: GBP 1,775,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 avr. 2013

    7 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CRS BIO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SHARRATT, Steven
    St Johns Innovation Park
    Cowley Road
    CB4 0DS Cambridge
    The Platinum Building
    Administrateur
    St Johns Innovation Park
    Cowley Road
    CB4 0DS Cambridge
    The Platinum Building
    EnglandBritishNone41673070005
    CHALLIS, Robert John
    1 Cherry Orchard
    Oakington
    CB4 5AY Cambridge
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    1 Cherry Orchard
    Oakington
    CB4 5AY Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishBusiness Manager2953050001
    GERAGHTY, Paul Kevin Ian
    Monkwood Cottage
    Whitakers Way
    IG10 1SQ Loughton
    Essex
    Secrétaire
    Monkwood Cottage
    Whitakers Way
    IG10 1SQ Loughton
    Essex
    BritishAccountant86029660001
    MULLETT, John Anderson James
    31 Long Lane
    Willingham
    CB4 5LB Cambridge
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    31 Long Lane
    Willingham
    CB4 5LB Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishDirector59916040002
    MULLETT, John Anderson James
    31 Long Lane
    Willingham
    CB4 5LB Cambridge
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    31 Long Lane
    Willingham
    CB4 5LB Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishDirector59916040002
    READYMADE SECRETARIES LTD
    Ground Floor 334 Whitchurch Road
    CF4 3NG Cardiff
    Secrétaire désigné
    Ground Floor 334 Whitchurch Road
    CF4 3NG Cardiff
    900013920001
    BELL, Steven John
    Willingham House
    Flexon Business Park
    CB6 3RY Stretham Road Wilburton
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Willingham House
    Flexon Business Park
    CB6 3RY Stretham Road Wilburton
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishChief Operating Officer148954950001
    BISHOP, Hugh William
    Barnside 50 High Street
    MK44 1PF Sharnbrook
    Bedfordshire
    Administrateur
    Barnside 50 High Street
    MK44 1PF Sharnbrook
    Bedfordshire
    EnglandBritishManaging Director94622690001
    CHALLIS, Robert John
    1 Cherry Orchard
    Oakington
    CB4 5AY Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    1 Cherry Orchard
    Oakington
    CB4 5AY Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishBusiness Manager2953050001
    DAVENPORT, Mark Edward
    Alboro House
    Twentypence Road Cottenham
    CB4 8PS Cambridge
    Administrateur
    Alboro House
    Twentypence Road Cottenham
    CB4 8PS Cambridge
    United KingdomBritishBusiness Manager16640010002
    DOWNES, David John
    Holden Brook
    New Barn Lane
    RH5 5PF Ockley
    Surrey
    Administrateur
    Holden Brook
    New Barn Lane
    RH5 5PF Ockley
    Surrey
    United KingdomBritishDirector37289200002
    FIELD, Christopher Charles
    4 Broad Road Cottages
    The Green Little Thurlow
    CB9 7JJ Haverhill
    Suffolk
    Administrateur
    4 Broad Road Cottages
    The Green Little Thurlow
    CB9 7JJ Haverhill
    Suffolk
    EnglandBritishRecycling Manager99183300003
    FLORINGER, Brian James
    Northfield Road
    Forncett St. Peter
    NR16 1JY Norwich
    Horseshoe Barn
    England
    Administrateur
    Northfield Road
    Forncett St. Peter
    NR16 1JY Norwich
    Horseshoe Barn
    England
    United KingdomBritishAccountant125389740001
    GERAGHTY, Paul Kevin Ian
    Monkwood Cottage
    Whitakers Way
    IG10 1SQ Loughton
    Essex
    Administrateur
    Monkwood Cottage
    Whitakers Way
    IG10 1SQ Loughton
    Essex
    United KingdomBritishAccountant86029660001
    GOLDEN, Gerard Anthony
    2 Jubilee Gardens
    Bearsden
    G61 2RT Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    2 Jubilee Gardens
    Bearsden
    G61 2RT Glasgow
    Lanarkshire
    EnglandBritishManaging Director71221940004
    MULLETT, John Anderson James
    31 Long Lane
    Willingham
    CB4 5LB Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    31 Long Lane
    Willingham
    CB4 5LB Cambridge
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishManager59916040002
    SHARRATT, Steven
    Cratfield Road
    Fressingfield
    IP21 5SH Eye
    Gissings Farm
    Suffolk
    Administrateur
    Cratfield Road
    Fressingfield
    IP21 5SH Eye
    Gissings Farm
    Suffolk
    EnglandBritishBusiness Consultans41673070005
    BIO AD LIMITED
    The Triangle
    Ng2 Business Oark
    NG2 1AE Nottingham
    10
    Administrateur
    The Triangle
    Ng2 Business Oark
    NG2 1AE Nottingham
    10
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement05282685
    225085100001
    BIO GROUP LIMITED
    The Triangle
    Ng2 Business Park
    NG2 1AE Nottingham
    10
    Administrateur
    The Triangle
    Ng2 Business Park
    NG2 1AE Nottingham
    10
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement06019372
    225122200001
    READYMADE NOMINEES LTD
    Ground Floor 334 Whitchurch Road
    CF4 3NG Cardiff
    Administrateur désigné
    Ground Floor 334 Whitchurch Road
    CF4 3NG Cardiff
    900013910001

    CRS BIO LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge of deposit
    Créé le 08 avr. 2010
    Livré le 13 avr. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The deposit initially of £227,000 credited to account designation number 22922532 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Charge of deposit
    Créé le 08 avr. 2010
    Livré le 13 avr. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The deposit initially of £50,000 credited to account designation number 22922559 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Chattel mortgage
    Créé le 28 déc. 2005
    Livré le 29 déc. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Crossfield-waste auto feed system - s/no: crs 2005/101.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 29 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 02 juil. 2004
    Livré le 20 juil. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 20 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 16 août 2002
    Livré le 20 août 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 août 2002Enregistrement d'une charge (395)

    CRS BIO LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 mai 2017Commencement of winding up
    27 févr. 2018Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Mark Upton
    The Platinum Building St Johns Innovation Park
    Cowley Road
    CB4 0DS Cambridge
    practitioner
    The Platinum Building St Johns Innovation Park
    Cowley Road
    CB4 0DS Cambridge
    David Paul Scrivener
    The Platinum Building St Johns Innovation Park
    Cowley Road
    CB4 0DS Cambridge
    Cambridgeshire
    practitioner
    The Platinum Building St Johns Innovation Park
    Cowley Road
    CB4 0DS Cambridge
    Cambridgeshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0