PREMIUM OUTDOOR LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPREMIUM OUTDOOR LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03828581
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PREMIUM OUTDOOR LIMITED ?

    • Agences de publicité (73110) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PREMIUM OUTDOOR LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Mazars Llp
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PREMIUM OUTDOOR LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    VAN WAGNER UK LIMITED16 août 199916 août 1999

    Quels sont les derniers comptes de PREMIUM OUTDOOR LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour PREMIUM OUTDOOR LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 sept. 2022

    11 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de C/O Mazars Llp Tower Bridge House St Katharine's Way London E1W 1DD à C/O Mazars Llp 30 Old Bailey London EC4M 7AU le 11 mai 2022

    2 pagesAD01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 33 Golden Square London W1F 9JT

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 33 Golden Square London Greater London W1F 9JT à C/O Mazars Llp Tower Bridge House St Katharine's Way London E1W 1DD le 06 oct. 2021

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    7 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 28 sept. 2021

    LRESSP

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    The director of the company and or the company prior to the date of this resolution of the company prior to the date of the res including but not LIMITED to any acts 31/08/2021
    RES13
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Statuts

    9 pagesMA

    Déclaration de confirmation établie le 16 août 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Notification de Clear Channel Overseas Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 mars 2021

    2 pagesPSC02

    Cessation de Clear Channel Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 mars 2021

    1 pagesPSC07

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    8 pagesAA

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 22 déc. 2020

    • Capital: GBP 0.10
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share premium account of the company of £15,498,000 to be cancelled in its entirety 15/12/2020
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 16 août 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Byron Kee Chye Hoo en tant que directeur le 04 mai 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Adam Paul Raymond Tow en tant qu'administrateur le 04 mai 2020

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    6 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de PREMIUM OUTDOOR LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COCHRANE, Justin Malcolm Brian
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    C/O Mazars Llp
    Administrateur
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    C/O Mazars Llp
    EnglandEnglishDirector Of Finance110390650002
    TOW, Adam Paul Raymond
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    C/O Mazars Llp
    Administrateur
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    C/O Mazars Llp
    EnglandBritishGeneral Counsel66766420004
    ANDREWS, Nick
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT Greater London
    Secrétaire
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT Greater London
    BritishHead Of Legal113343460002
    JORDAN COMPANY SECRETARIES LIMITED
    21 St Thomas Street
    BS1 6JS Bristol
    Avon
    Secrétaire désigné
    21 St Thomas Street
    BS1 6JS Bristol
    Avon
    900008790001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ANDREWS, Nicholas James
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT Greater London
    Administrateur
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT Greater London
    United KingdomBritishSolicitor168572900001
    ATKINSON, Robert Nigel
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT Greater London
    Administrateur
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT Greater London
    United KingdomBritishManaging Director128922360001
    BEVAN, Jonathan David
    15 Denning Road
    Hampstead
    NW3 1ST London
    Administrateur
    15 Denning Road
    Hampstead
    NW3 1ST London
    United KingdomBritishAccountant110358490001
    BROWN, Alexander Michael
    74 Undercliff Gardens
    SS9 1ED Leigh On Sea
    Essex
    Administrateur
    74 Undercliff Gardens
    SS9 1ED Leigh On Sea
    Essex
    EnglandBritishAdvertising Manager325069550002
    HAMLIN, Charles Borden
    The Croft
    Station Road Lower Shiplake
    RG9 3JS Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Croft
    Station Road Lower Shiplake
    RG9 3JS Henley On Thames
    Oxfordshire
    AmericanMedia Executive77971600002
    HIGGINS, Michael
    2 Woodman Villas
    Fawkham Green Road
    DA3 8NS Fawkham
    Kent
    Administrateur
    2 Woodman Villas
    Fawkham Green Road
    DA3 8NS Fawkham
    Kent
    United KingdomBritishAdvertising80065670001
    HOO, Byron Kee Chye
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT Greater London
    Administrateur
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT Greater London
    EnglandBritishCfo214640470001
    JOHNSTON, Anne Elizabeth
    5-7 Carnaby Street
    W1F 9PB London
    Administrateur
    5-7 Carnaby Street
    W1F 9PB London
    AmericanDirector111128570001
    JOHNSTON, Mark Haynes
    C/O Van Wagner Enterprises, Llc
    28th Floor, 800 Third Avenue, 10022-7604
    Newyork
    Usa
    Administrateur
    C/O Van Wagner Enterprises, Llc
    28th Floor, 800 Third Avenue, 10022-7604
    Newyork
    Usa
    AmericanMedia Executive103898840001
    MCCONVILLE, Coline Lucille, Ms.
    South Hill Park
    NW3 2PX London
    105
    Administrateur
    South Hill Park
    NW3 2PX London
    105
    EnglandAustralianChief Operations Officer163576580001
    MEYER, Paul Joseph
    5109 N 34th Place
    Phoenix
    Az 85018
    United States Of America
    Administrateur
    5109 N 34th Place
    Phoenix
    Az 85018
    United States Of America
    AmericanDirector107504500001
    OLIVER, David Henry Maxwell
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT Greater London
    Administrateur
    33 Golden Square
    London
    W1F 9JT Greater London
    United KingdomBritishAccountant67052550001
    SAYER, Barry
    81 Carlmarie Road Hydepark
    Sandtown
    Johannesburg
    2196
    South Africa
    Administrateur
    81 Carlmarie Road Hydepark
    Sandtown
    Johannesburg
    2196
    South Africa
    IrishDirector110737510001
    SCHAPS, Jordan Benjamin
    5-7 Carnaby Street
    W1F 9PB London
    Administrateur
    5-7 Carnaby Street
    W1F 9PB London
    AmericanChief Executive110972420001
    SCHAPS, Richard
    C/O Van Wagner Enterprises Llc
    800 Third Ave
    28th Floor
    New York 10022-7604
    Administrateur
    C/O Van Wagner Enterprises Llc
    800 Third Ave
    28th Floor
    New York 10022-7604
    AmericanPresident Media Company65629960001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PREMIUM OUTDOOR LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Clear Channel Overseas Limited
    Golden Square
    W1F 9JT London
    33
    England
    03 mars 2021
    Golden Square
    W1F 9JT London
    33
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House Uk
    Numéro d'enregistrement01441672
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Clear Channel Uk Limited
    Golden Square
    W1F 9JT London
    33
    England
    06 déc. 2016
    Golden Square
    W1F 9JT London
    33
    England
    Oui
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEnglish Law
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement950526
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Premium Holdings Limited
    Golden Square
    W1F 9JT London
    33
    England
    16 août 2016
    Golden Square
    W1F 9JT London
    33
    England
    Oui
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEnglish Law
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales Companies House
    Numéro d'enregistrement5397214
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    PREMIUM OUTDOOR LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge over receivables
    Créé le 26 juil. 2005
    Livré le 12 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each credit party (including the company) to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights in respect of any amount standing to the credit of any account, all book and other debts, all moneys due and owing to the company and the benefit of all rights securities or guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • General Electric Capital Corporation Acting Individually and in Its Capacity as Agent for Thelenders (The Security Agent)
    Transactions
    • 12 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of rental deposit
    Créé le 15 mars 2005
    Livré le 22 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the companys interest in the interest account.
    Personnes ayant droit
    • Beetham Limited
    Transactions
    • 22 mars 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 déc. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Licence fee deposit agreement
    Créé le 29 avr. 2004
    Livré le 08 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    £25,000 plus vat.
    Personnes ayant droit
    • The Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London
    Transactions
    • 08 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 déc. 2002
    Livré le 06 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill intellectual property rights uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • General Electric Capital Corporation Acting Individually and in Its Capacity as Agent for Thelenders (The Security Trustee)
    Transactions
    • 06 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 avr. 2001
    Livré le 28 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of any of the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bank One Na
    Transactions
    • 28 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 06 nov. 2000
    Livré le 24 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the licence and the due performance of all obligations and liabilities
    Brèves mentions
    A deposit of £1,013 together with any interest accrued.
    Personnes ayant droit
    • Posthouse Hotels Limited
    Transactions
    • 24 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 02 nov. 1999
    Livré le 04 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the lease dated 2 november 1999
    Brèves mentions
    The sum deposit is £54,006.01.
    Personnes ayant droit
    • Allied Commercial Exporters Limited
    Transactions
    • 04 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 déc. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)

    PREMIUM OUTDOOR LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    28 sept. 2021Commencement of winding up
    12 mars 2024Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    practitioner
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Simon David Chandler
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    practitioner
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0