MCLEAN TW ESTATES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMCLEAN TW ESTATES LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03829197
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MCLEAN TW ESTATES LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe MCLEAN TW ESTATES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Gate House
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Buckinghamshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MCLEAN TW ESTATES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WAIN ESTATES LIMITED30 sept. 199930 sept. 1999
    M M & S (2570) LIMITED20 août 199920 août 1999

    Quels sont les derniers comptes de MCLEAN TW ESTATES LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MCLEAN TW ESTATES LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au03 avr. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation17 avr. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au03 avr. 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour MCLEAN TW ESTATES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Cessation de la nomination de Michael Andrew Lonnon en tant que directeur le 09 déc. 2024

    1 pagesTM01

    Nomination de Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh en tant qu'administrateur le 09 déc. 2024

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2023

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Omolola Olutomilayo Adedoyin en tant que directeur le 24 avr. 2024

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Omolola Olutomilayo Adedoyin en tant que secrétaire le 24 avr. 2024

    1 pagesTM02

    Nomination de Jennifer Canty en tant que secrétaire le 24 avr. 2024

    2 pagesAP03

    Nomination de Jennifer Canty en tant qu'administrateur le 24 avr. 2024

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 03 avr. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Molly Banham en tant que secrétaire le 29 nov. 2023

    1 pagesTM02

    Nomination de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin en tant que secrétaire le 29 nov. 2023

    2 pagesAP03

    Nomination de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin en tant qu'administrateur le 01 sept. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Katherine Elizabeth Hindmarsh en tant que directeur le 01 sept. 2023

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 03 avr. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr. Michael Andrew Lonnon en tant qu'administrateur le 26 août 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de Miss Molly Banham en tant que secrétaire le 26 août 2022

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Alice Hannah Black en tant que directeur le 26 août 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael Andrew Lonnon en tant que secrétaire le 26 août 2022

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 03 avr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Alice Hannah Marsden le 30 mai 2021

    2 pagesCH01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Elder House St Georges Business Park 207 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TS United Kingdom à Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH

    1 pagesAD02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 03 avr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de MCLEAN TW ESTATES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CANTY, Jennifer
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    322316170001
    CANTY, Jennifer
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Secretary322288120001
    HINDMARSH, Katherine Elizabeth
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary330353690001
    ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    Secrétaire
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    316494170001
    ATTERBURY, Karen Lorraine
    Chestnut Drive
    HP4 2JL Berkhamsted
    11
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Chestnut Drive
    HP4 2JL Berkhamsted
    11
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British175715660001
    BANHAM, Molly
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    299540150001
    CARR, Peter Anthony
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    Secrétaire
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    British130306120001
    DE FEO, Caterina
    42 The Crescent
    Hampton In Arden
    B92 0BP Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    42 The Crescent
    Hampton In Arden
    B92 0BP Solihull
    West Midlands
    British58246930001
    HASTINGS, Jonathan Philip
    7 Hanger Court
    Hanger Green
    W5 3ER London
    Secrétaire
    7 Hanger Court
    Hanger Green
    W5 3ER London
    British4733610001
    JORDAN, James John
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British120602100002
    LONNON, Michael Andrew, Mr.
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    147316940001
    NUNN, Carol Jayne
    4 Juniper Close
    NN12 6XP Towcester
    Northamptonshire
    Secrétaire
    4 Juniper Close
    NN12 6XP Towcester
    Northamptonshire
    British116824870001
    OWEN, Stephen John
    1 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    Secrétaire
    1 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    British66776040001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Secrétaire désigné
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    Administrateur
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director193735640001
    AINSCOUGH, William
    High Moor Lane
    Wrightington
    WN6 9QA Wigan
    Harrock Hall
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    High Moor Lane
    Wrightington
    WN6 9QA Wigan
    Harrock Hall
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director18332250011
    ANDREW, Peter Robert
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishRegional Managing Director113503830003
    BLACK, Alice Hannah
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor264031110002
    CARNEY, Christopher
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director125216670001
    CLAPHAM, Colin Richard
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary9684390001
    GREEN, Robert David
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    Administrateur
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    EnglandBritishDirector76720550003
    HINDMARSH, Katherine Elizabeth
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary257671040002
    JOHNSON, Peter Thomas
    34 Homewood Road
    AL1 4BQ St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    34 Homewood Road
    AL1 4BQ St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant8895880004
    JORDAN, James John
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Secretary120602100002
    LONNON, Michael Andrew, Mr.
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary34521340004
    MCCALLUM, Graeme Reid
    The Poplars
    Whinfield Road Dodford
    B61 9BG Bromsgrove
    Worcestershire
    Administrateur
    The Poplars
    Whinfield Road Dodford
    B61 9BG Bromsgrove
    Worcestershire
    United KingdomBritishCompany Director152856250001
    MURRIN, Jonathan Charles
    10 Silhill Hall Road
    B91 1JU Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    10 Silhill Hall Road
    B91 1JU Solihull
    West Midlands
    BritishChartered Accountant115863170001
    PEACOCK, Raymond Anthony
    9 Grosvenor Road
    Finchley
    N3 1EY London
    Administrateur
    9 Grosvenor Road
    Finchley
    N3 1EY London
    United KingdomBritishDirector75750250002
    ROBINSON, Stephen
    23a Central Drive
    Penwortham
    PR1 0NL Preston
    Administrateur
    23a Central Drive
    Penwortham
    PR1 0NL Preston
    EnglandBritishChartered Builder46489270001
    TUTTE, John Frederick
    Peters Barn
    West End, Scaldwell
    NN6 9JX Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Peters Barn
    West End, Scaldwell
    NN6 9JX Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritishDirector56012720002
    WATTS, Christopher Philip
    Halycon Lodge
    Field Close Ufton
    CV33 9PH Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    Halycon Lodge
    Field Close Ufton
    CV33 9PH Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishAccountant83391430001
    VINDEX LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Administrateur
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    64555080001
    VINDEX SERVICES LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Administrateur
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    64555070001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MCLEAN TW ESTATES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03621554
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    MCLEAN TW ESTATES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 26 janv. 2001
    Livré le 01 févr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Further sums due from the company to the chargee pursuant to an agreement of even date (as defined)
    Brèves mentions
    Land on south side of durton lane broughton preston lancs.
    Personnes ayant droit
    • The Solicitor for the Affails of the Duchy of Lancaster
    Transactions
    • 01 févr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 21 nov. 2000
    Livré le 07 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £65,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Sydling sector lane axminster devon.
    Personnes ayant droit
    • A D J Jefford
    Transactions
    • 07 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 26 janv. 2000
    Livré le 09 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or as principal debtor, guarantor surety or otherwise or as the equivalent obligor under the laws of any jurisdiction) of each obligor to the security trustee and/or all or any of the banks under all or any of the financing documents
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for Itself Andfor Each of the Banks
    Transactions
    • 09 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0