LUCITE INTERNATIONAL FINCO LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | LUCITE INTERNATIONAL FINCO LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03830160 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LUCITE INTERNATIONAL FINCO LIMITED ?
Adresse du siège social | C/O Suite 5 Bulman House Regent Centre Gosforth NE3 3LS Newcastle Upon Tyne |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LUCITE INTERNATIONAL FINCO LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour LUCITE INTERNATIONAL FINCO LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 12 pages | LIQ13 | ||||||||||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 déc. 2022 | 11 pages | LIQ03 | ||||||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Cassel Works New Road Billingham TS23 1LE England à C/O Suite 5 Bulman House Regent Centre Gosforth Newcastle upon Tyne NE3 3LS le 23 déc. 2021 | 2 pages | AD01 | ||||||||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 août 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
Modification des détails de Mitsubishi Chemical Lucite Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 avr. 2021 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||||||||||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2020 | 26 pages | AA | ||||||||||||||||||
Nomination de Ms Melanie Jane Jury en tant qu'administrateur le 01 avr. 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Philip James Bailey en tant que directeur le 01 avr. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Cassel Works New Road Billingham TS23 1LE England à Monomer House 9 Cheltenham Road Portrack Interchange Business Park Stockton-on-Tees TS18 2AD | 1 pages | AD02 | ||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 août 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Fusion House Haslingden Road Blackburn BB1 2FD England à Cassel Works New Road Billingham TS23 1LE | 1 pages | AD02 | ||||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2019 | 23 pages | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 août 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
Statuts | 6 pages | MA | ||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 22 mars 2019
| 8 pages | SH01 | ||||||||||||||||||
legacy | 2 pages | SH20 | ||||||||||||||||||
État du capital au 25 mars 2019
| 4 pages | SH19 | ||||||||||||||||||
legacy | 2 pages | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
|
Qui sont les dirigeants de LUCITE INTERNATIONAL FINCO LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTHILL, Colin Neil | Secrétaire | Regent Centre Gosforth NE3 3LS Newcastle Upon Tyne C/O Suite 5 Bulman House | 241211250001 | |||||||
CUTHILL, Colin Neil | Administrateur | Regent Centre Gosforth NE3 3LS Newcastle Upon Tyne C/O Suite 5 Bulman House | United Kingdom | British | Accountant | 161168950001 | ||||
JURY, Melanie Jane | Administrateur | Regent Centre Gosforth NE3 3LS Newcastle Upon Tyne C/O Suite 5 Bulman House | England | British | Company Director | 227689900001 | ||||
OYAMA, Dai | Administrateur | Regent Centre Gosforth NE3 3LS Newcastle Upon Tyne C/O Suite 5 Bulman House | Japan | Japanese | Company Director | 229741580001 | ||||
ARBUTHNOTT, Geoffrey James | Secrétaire | Lower Gustard Wood Wheathampstead AL4 8RX St Albans Lamer Hill Hertfordshire | British | Investment Banker | 66364270001 | |||||
LAMBERT, Ian Robin | Secrétaire | The White Cottage Hook Road SO51 9BY Ampfield Hampshire | British | Director | 71289480003 | |||||
VEERMAN, Annie Sophia | Secrétaire | New Road TS23 1LE Billingham Cassel Works England | Dutch | Chief Finance Officer | 90566780002 | |||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
ARBUTHNOTT, Geoffrey James | Administrateur | Lower Gustard Wood Wheathampstead AL4 8RX St Albans Lamer Hill Hertfordshire | United Kingdom | British | Investment Banker | 66364270001 | ||||
BAILEY, Philip James | Administrateur | New Road TS23 1LE Billingham Cassel Works England | England | British | Chemical Site Manager | 128766340001 | ||||
DAVIDSON, Scott | Administrateur | 54 Burgess Wood Road South HP9 1EJ Beaconsfield Buckinghamshire | British | Chief Executive Office | 14566540001 | |||||
DENISON, Janette Louise | Administrateur | 15-17 Cumberland Place SO15 2BG Southampton Cumberland House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 189250950001 | ||||
HENDERSON, Andrew Paul | Administrateur | Overton Coach House Overton Lane, Heaton BL1 5BZ Bolton Lancashire | British | Director | 118088100001 | |||||
JACKSON, Nigel Scott | Administrateur | New Road TS23 1LE Billingham Cassel Works England | England | British | Finance Manager | 173411160001 | ||||
LAMBERT, Ian Robin | Administrateur | 15-17 Cumberland Place SO15 2BG Southampton Cumberland House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 71289480007 | ||||
RATCLIFFE, James Arthur, Sir | Administrateur | Greatfield Bucklers Hard SO42 7XE Beaulieu Hampshire | England | British | Company Director | 66214720001 | ||||
ROWLAND, Marie Anne | Administrateur | New Road TS23 1LE Billingham Cassel Works England | England | British | Accountant | 128765980002 | ||||
SAYERS, Neil Lawson | Administrateur | 15-17 Cumberland Place SO15 2BG Southampton Cumberland House Hampshire United Kingdom | England | British | Director | 68514560002 | ||||
VEERMAN, Annie Sophia | Administrateur | New Road TS23 1LE Billingham Cassel Works England | Australia | Dutch | Chief Financial Officer | 90566780005 | ||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LUCITE INTERNATIONAL FINCO LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi Chemical Methacrylates Limited | 06 avr. 2016 | New Road TS23 1LE Billingham Cassel Works England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
LUCITE INTERNATIONAL FINCO LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Security over cash agreement | Créé le 16 juil. 2009 Livré le 28 juil. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the secured party on any account whatsoever | |
Brèves mentions All sums (including interest ) from time to time standing to the credit of the chargors account no:0412268 account name db london blocked deposit account re:li finco LTD open or to be opened in the secured party's books including any sub-account and redesignation of that account and any account substituted for it. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 07 juil. 2006 Livré le 24 juil. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each loan party to the chargee and/or the secured parties and/or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Composite debenture | Créé le 02 nov. 1999 Livré le 09 nov. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All money and liabilities now or hereafter due,owing or incurred to the secured parties (as defined),or any of them,by the charging company and each of the other obligors (as defined) under the senior finance documents (as defined),or any of them,and under the deed in any currency whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
LUCITE INTERNATIONAL FINCO LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0