LUCITE INTERNATIONAL FINCO LIMITED

LUCITE INTERNATIONAL FINCO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLUCITE INTERNATIONAL FINCO LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03830160
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LUCITE INTERNATIONAL FINCO LIMITED ?

    • Autre octroi de crédit n.c.a. (64929) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe LUCITE INTERNATIONAL FINCO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Suite 5 Bulman House Regent Centre
    Gosforth
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LUCITE INTERNATIONAL FINCO LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INEOS ACRYLICS UK FINCO LIMITED 30 sept. 199930 sept. 1999
    USERSTYLE LIMITED23 août 199923 août 1999

    Quels sont les derniers comptes de LUCITE INTERNATIONAL FINCO LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour LUCITE INTERNATIONAL FINCO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    12 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 déc. 2022

    11 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de Cassel Works New Road Billingham TS23 1LE England à C/O Suite 5 Bulman House Regent Centre Gosforth Newcastle upon Tyne NE3 3LS le 23 déc. 2021

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 14 déc. 2021

    LRESSP

    Déclaration de confirmation établie le 23 août 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de Mitsubishi Chemical Lucite Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 avr. 2021

    2 pagesPSC05

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 mars 2020

    26 pagesAA

    Nomination de Ms Melanie Jane Jury en tant qu'administrateur le 01 avr. 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Philip James Bailey en tant que directeur le 01 avr. 2021

    1 pagesTM01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Cassel Works New Road Billingham TS23 1LE England à Monomer House 9 Cheltenham Road Portrack Interchange Business Park Stockton-on-Tees TS18 2AD

    1 pagesAD02

    Déclaration de confirmation établie le 23 août 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Fusion House Haslingden Road Blackburn BB1 2FD England à Cassel Works New Road Billingham TS23 1LE

    1 pagesAD02

    Comptes annuels établis au 31 mars 2019

    23 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 août 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Statuts

    6 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    État du capital après une attribution d'actions au 22 mars 2019

    • Capital: GBP 2
    8 pagesSH01

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 25 mars 2019

    • Capital: GBP 2
    4 pagesSH19

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduction of the share premium account to nil 22/03/2019
    RES13

    Qui sont les dirigeants de LUCITE INTERNATIONAL FINCO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CUTHILL, Colin Neil
    Regent Centre
    Gosforth
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    C/O Suite 5 Bulman House
    Secrétaire
    Regent Centre
    Gosforth
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    C/O Suite 5 Bulman House
    241211250001
    CUTHILL, Colin Neil
    Regent Centre
    Gosforth
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    C/O Suite 5 Bulman House
    Administrateur
    Regent Centre
    Gosforth
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    C/O Suite 5 Bulman House
    United KingdomBritishAccountant161168950001
    JURY, Melanie Jane
    Regent Centre
    Gosforth
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    C/O Suite 5 Bulman House
    Administrateur
    Regent Centre
    Gosforth
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    C/O Suite 5 Bulman House
    EnglandBritishCompany Director227689900001
    OYAMA, Dai
    Regent Centre
    Gosforth
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    C/O Suite 5 Bulman House
    Administrateur
    Regent Centre
    Gosforth
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    C/O Suite 5 Bulman House
    JapanJapaneseCompany Director229741580001
    ARBUTHNOTT, Geoffrey James
    Lower Gustard Wood
    Wheathampstead
    AL4 8RX St Albans
    Lamer Hill
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Lower Gustard Wood
    Wheathampstead
    AL4 8RX St Albans
    Lamer Hill
    Hertfordshire
    BritishInvestment Banker66364270001
    LAMBERT, Ian Robin
    The White Cottage
    Hook Road
    SO51 9BY Ampfield
    Hampshire
    Secrétaire
    The White Cottage
    Hook Road
    SO51 9BY Ampfield
    Hampshire
    BritishDirector71289480003
    VEERMAN, Annie Sophia
    New Road
    TS23 1LE Billingham
    Cassel Works
    England
    Secrétaire
    New Road
    TS23 1LE Billingham
    Cassel Works
    England
    DutchChief Finance Officer90566780002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ARBUTHNOTT, Geoffrey James
    Lower Gustard Wood
    Wheathampstead
    AL4 8RX St Albans
    Lamer Hill
    Hertfordshire
    Administrateur
    Lower Gustard Wood
    Wheathampstead
    AL4 8RX St Albans
    Lamer Hill
    Hertfordshire
    United KingdomBritishInvestment Banker66364270001
    BAILEY, Philip James
    New Road
    TS23 1LE Billingham
    Cassel Works
    England
    Administrateur
    New Road
    TS23 1LE Billingham
    Cassel Works
    England
    EnglandBritishChemical Site Manager128766340001
    DAVIDSON, Scott
    54 Burgess Wood Road South
    HP9 1EJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    54 Burgess Wood Road South
    HP9 1EJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishChief Executive Office14566540001
    DENISON, Janette Louise
    15-17 Cumberland Place
    SO15 2BG Southampton
    Cumberland House
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    15-17 Cumberland Place
    SO15 2BG Southampton
    Cumberland House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant189250950001
    HENDERSON, Andrew Paul
    Overton Coach House
    Overton Lane, Heaton
    BL1 5BZ Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    Overton Coach House
    Overton Lane, Heaton
    BL1 5BZ Bolton
    Lancashire
    BritishDirector118088100001
    JACKSON, Nigel Scott
    New Road
    TS23 1LE Billingham
    Cassel Works
    England
    Administrateur
    New Road
    TS23 1LE Billingham
    Cassel Works
    England
    EnglandBritishFinance Manager173411160001
    LAMBERT, Ian Robin
    15-17 Cumberland Place
    SO15 2BG Southampton
    Cumberland House
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    15-17 Cumberland Place
    SO15 2BG Southampton
    Cumberland House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive Officer71289480007
    RATCLIFFE, James Arthur, Sir
    Greatfield
    Bucklers Hard
    SO42 7XE Beaulieu
    Hampshire
    Administrateur
    Greatfield
    Bucklers Hard
    SO42 7XE Beaulieu
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director66214720001
    ROWLAND, Marie Anne
    New Road
    TS23 1LE Billingham
    Cassel Works
    England
    Administrateur
    New Road
    TS23 1LE Billingham
    Cassel Works
    England
    EnglandBritishAccountant128765980002
    SAYERS, Neil Lawson
    15-17 Cumberland Place
    SO15 2BG Southampton
    Cumberland House
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    15-17 Cumberland Place
    SO15 2BG Southampton
    Cumberland House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector68514560002
    VEERMAN, Annie Sophia
    New Road
    TS23 1LE Billingham
    Cassel Works
    England
    Administrateur
    New Road
    TS23 1LE Billingham
    Cassel Works
    England
    AustraliaDutchChief Financial Officer90566780005
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LUCITE INTERNATIONAL FINCO LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    New Road
    TS23 1LE Billingham
    Cassel Works
    England
    06 avr. 2016
    New Road
    TS23 1LE Billingham
    Cassel Works
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement05671799
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    LUCITE INTERNATIONAL FINCO LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security over cash agreement
    Créé le 16 juil. 2009
    Livré le 28 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the secured party on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All sums (including interest ) from time to time standing to the credit of the chargors account no:0412268 account name db london blocked deposit account re:li finco LTD open or to be opened in the secured party's books including any sub-account and redesignation of that account and any account substituted for it.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Secured Party)
    Transactions
    • 28 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 juin 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 07 juil. 2006
    Livré le 24 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each loan party to the chargee and/or the secured parties and/or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Merrill Lynch Capital Corporation (The "Collateral Agent")
    Transactions
    • 24 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite debenture
    Créé le 02 nov. 1999
    Livré le 09 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money and liabilities now or hereafter due,owing or incurred to the secured parties (as defined),or any of them,by the charging company and each of the other obligors (as defined) under the senior finance documents (as defined),or any of them,and under the deed in any currency whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag London Branch,as Security Agent
    Transactions
    • 09 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    LUCITE INTERNATIONAL FINCO LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 déc. 2021Commencement of winding up
    23 mai 2023Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Steven Phillip Ross
    Suite 5, 2nd Floor Bulman House
    Regent Centre
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    practitioner
    Suite 5, 2nd Floor Bulman House
    Regent Centre
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0