REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03830216 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 2 Browns Road NN11 4NS Daventry England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2022 |
Quels sont les derniers dépôts pour REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 2 pages | DS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2022 | 6 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021 | 6 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2020 | 6 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Changement d'adresse du siège social de The Forge Blisworth Hill Farm Stoke Road Blisworth Northampton NN7 3DB England à 2 Browns Road Daventry NN11 4NS le 17 juil. 2020 | 1 pages | AD01 | ||
Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2019 au 31 mars 2020 | 1 pages | AA01 | ||
Cessation de la nomination de Mark Carnegie-Brown en tant que directeur le 10 oct. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Paul Mccluskey en tant que directeur le 10 oct. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Paul Mcclusky en tant que directeur le 10 oct. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Matthew James Hanson en tant que directeur le 10 oct. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Jonathan Matthew Clements en tant qu'administrateur le 10 oct. 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Gregory John Kirkman en tant qu'administrateur le 10 oct. 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Richard Allen Assenheim en tant qu'administrateur le 10 oct. 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Changement d'adresse du siège social de One St Peter's Square Manchester M2 3DE United Kingdom à The Forge Blisworth Hill Farm Stoke Road Blisworth Northampton NN7 3DB le 15 oct. 2019 | 1 pages | AD01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 5 pages | AA | ||
Nomination de Dr Mark Carnegie-Brown en tant qu'administrateur le 05 août 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Nomination de Matthew James Hanson en tant qu'administrateur le 03 juin 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Mark Calderbank en tant que directeur le 14 juin 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 10 pages | AA | ||
Qui sont les dirigeants de REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSENHEIM, Richard Allen | Administrateur | Kettering Road NN2 7DU Northampton 263 England | United Kingdom | British | 107134790001 | |||||
| CLEMENTS, Jonathan Matthew | Administrateur | Carrs Way Harpole NN7 4DA Northampton 66 England | England | British | 148425870001 | |||||
| KIRKMAN, Gregory John | Administrateur | Duston Wildes NN5 6NR Northampton 73 England | United Kingdom | British | 43067380003 | |||||
| ELLIS, Andrew Clive | Secrétaire | 34 Merafield Drive Plympton PL7 1TP Plymouth Devon | British | 83349650001 | ||||||
| MCCLUSKEY, Paul | Secrétaire | Barbirolli Square M2 3AB Manchester 100 United Kingdom | 191004950001 | |||||||
| MOSS, Karl Alan | Secrétaire | 9 Hadfield Street Cornbrook M16 9FE Old Trafford Hadfield House Manchester United Kingdom | 148196340001 | |||||||
| SUTHERLAND, Ronald Macnoughton | Secrétaire | Flat 9 67 Cambridge Road PR9 9NG Southport | British | 67412270002 | ||||||
| SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED | Secrétaire désigné | 16 Churchill Way CF10 2DX Cardiff | 900017270001 | |||||||
| CALDERBANK, Mark | Administrateur | 19 Spring Gardens M2 1FB Manchester C/O 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 250111160001 | |||||
| CARNEGIE-BROWN, Mark, Dr | Administrateur | Block 35s Alderley Park SK10 4TG Cheshire C/O Concept Life Sciences United Kingdom | United Kingdom | British | 224430380001 | |||||
| COLL, David Daniel | Administrateur | Barbirolli Square M2 3AB Manchester 100 United Kingdom | Scotland | British | 146924840001 | |||||
| ELLIS, Andrew Clive | Administrateur | 9 Hadfield Street Cornbrook M16 9FE Old Trafford Hadfield House Manchester United Kingdom | England | British | 83349650001 | |||||
| ELLIS, Andrew Clive | Administrateur | 34 Merafield Drive Plympton PL7 1TP Plymouth Devon | England | British | 83349650001 | |||||
| FORT, Michael John | Administrateur | M2 3DE Manchester One St Peter's Square United Kingdom | United Kingdom | British | 189303790003 | |||||
| HANSON, Matthew James | Administrateur | Stoke Road Blisworth NN7 3DB Northampton The Forge Blisworth Hill Farm England | United Kingdom | British | 276583410001 | |||||
| JENKINS, Daniel | Administrateur | M2 3DE Manchester One St Peter's Square United Kingdom | United Kingdom | British | 170241030001 | |||||
| MCCLUSKEY, Paul | Administrateur | Stoke Road Blisworth NN7 3DB Northampton The Forge Blisworth Hill Farm England | United Kingdom | British | 156519370001 | |||||
| MORGAN, Alan Stuart | Administrateur | Barbirolli Square M2 3AB Manchester 100 United Kingdom | England | British | 72916280001 | |||||
| SUTHERLAND, Bruce | Administrateur | The Hilt Clobells TQ10 9JW South Brent Devon | United Kingdom | British | 67642630001 | |||||
| WOOD, David | Administrateur | Barbirolli Square M2 3AB Manchester 100 United Kingdom | England | British | 24194630001 | |||||
| CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED | Administrateur désigné | 16 Churchill Way CF10 2DX Cardiff | 900017260001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noble Health & Safety Training Limited | 01 août 2016 | St. Peters Square M2 3DE Manchester One England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| All assets debenture | Créé le 27 janv. 2012 Livré le 31 janv. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture deed | Créé le 07 juin 2010 Livré le 11 juin 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of fixed equitable charge all purchased debts; all other debts and all associated rights; by way of floating charge all the undertaking and all the rights and assets of the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 18 juin 2004 Livré le 22 juin 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0