TURNKEY MORTGAGES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTURNKEY MORTGAGES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03830494
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TURNKEY MORTGAGES LIMITED ?

    • Intermédiation financière n.c.a. (64999) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe TURNKEY MORTGAGES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    St Crispins House
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    Norfolk
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TURNKEY MORTGAGES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MORTGAGE LIFE & LOANS LIMITED01 nov. 201101 nov. 2011
    CENTRAL MORTGAGES LIMITED16 mai 200716 mai 2007
    CENTRAL MORTGAGE PROCESSING LIMITED19 juil. 200519 juil. 2005
    PROGRESSIVE MORTGAGE PROCESSING SERVICES LIMITED31 mai 200131 mai 2001
    CENTRAL MORTGAGE CORPORATION LIMITED22 janv. 200122 janv. 2001
    JOBSEND LIMITED24 août 199924 août 1999

    Quels sont les derniers comptes de TURNKEY MORTGAGES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour TURNKEY MORTGAGES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 16 mai 2016

    • Capital: GBP 10
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share prem a/c 12/05/2016
    RES13

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    15 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 sept. 2015

    État du capital au 17 sept. 2015

    • Capital: GBP 10
    SH01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Résolutions

    Resolutions
    45 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    18 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    État du capital après une attribution d'actions au 27 févr. 2015

    • Capital: GBP 10
    4 pagesSH01

    État du capital après une attribution d'actions au 22 janv. 2015

    • Capital: GBP 9
    5 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    État du capital après une attribution d'actions au 23 déc. 2014

    • Capital: GBP 8
    4 pagesSH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jonathan David Painter le 15 sept. 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Graham Charles Eke le 09 juil. 2014

    3 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    18 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Anthony Richardson le 20 déc. 2013

    1 pagesCH03

    État du capital au 17 déc. 2013

    • Capital: GBP 7
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share prem a/c 16/12/2013
    RES13

    Qui sont les dirigeants de TURNKEY MORTGAGES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RICHARDSON, Anthony
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins House
    Norfolk
    United Kingdom
    Secrétaire
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins House
    Norfolk
    United Kingdom
    British129062580001
    EKE, Graham Charles
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins House
    Norfolk
    United Kingdom
    Administrateur
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins House
    Norfolk
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant161097690002
    PAINTER, Jonathan David
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins House
    Norfolk
    United Kingdom
    Administrateur
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins House
    Norfolk
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant Risk Manager139075290001
    TURNER, Andrew Clive
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins House
    Norfolk
    United Kingdom
    Administrateur
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins House
    Norfolk
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant66089250001
    SULLIVAN, John Terance
    Sparrow Green Barn
    Gressenhall
    NR19 2QL Dereham
    Norfolk
    Secrétaire
    Sparrow Green Barn
    Gressenhall
    NR19 2QL Dereham
    Norfolk
    BritishAccountant106553270001
    TURNER, Sharon Leigh
    Drayton House
    Costessey Lane, Drayton
    NR8 6HA Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    Drayton House
    Costessey Lane, Drayton
    NR8 6HA Norwich
    Norfolk
    BritishDirector66089320001
    TURNER, Sharon Leigh
    Drayton House
    Costessey Lane, Drayton
    NR8 6HA Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    Drayton House
    Costessey Lane, Drayton
    NR8 6HA Norwich
    Norfolk
    British66089320001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secrétaire désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    CHAPMAN, Nicholas James Alfred
    2 Mast Close
    Carlton Colville
    NR33 8GU Lowestoft
    Suffolk
    Administrateur
    2 Mast Close
    Carlton Colville
    NR33 8GU Lowestoft
    Suffolk
    BritishCompany Director106553150001
    EKE, Graham Charles
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins House
    Norfolk
    United Kingdom
    Administrateur
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    St Crispins House
    Norfolk
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant161097690001
    FAIRMAN, Richard William Mark
    The Homestead
    High Common Swardeston
    NR14 8DL Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    The Homestead
    High Common Swardeston
    NR14 8DL Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishAccountant104921040001
    FORSTER, Joanne
    12 Wilks Farm Drive
    NR7 8RG Sprowston
    Norfolk
    Administrateur
    12 Wilks Farm Drive
    NR7 8RG Sprowston
    Norfolk
    BritishDirector122977500001
    MASDING, Jeremy John
    100 Low Road
    Hellesdon
    NR6 5AS Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    100 Low Road
    Hellesdon
    NR6 5AS Norwich
    Norfolk
    United KingdomWelshChief Executive127041650001
    ROWETT, Charles Francis Sam
    5 White Woman's Lane
    Eyke
    IP12 2SY Woodbridge
    The Farmhouse
    Suffolk
    Administrateur
    5 White Woman's Lane
    Eyke
    IP12 2SY Woodbridge
    The Farmhouse
    Suffolk
    UkBritishGroup Hr Director88506000001
    SULLIVAN, John Terance
    Sparrow Green Barn
    Gressenhall
    NR19 2QL Dereham
    Norfolk
    Administrateur
    Sparrow Green Barn
    Gressenhall
    NR19 2QL Dereham
    Norfolk
    BritishAccountant106553270001
    TURNER, Sharon Leigh
    Drayton House
    Costessey Lane, Drayton
    NR8 6HA Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Drayton House
    Costessey Lane, Drayton
    NR8 6HA Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishAccountant66089320001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Administrateur désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    TURNKEY MORTGAGES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 13 sept. 2005
    Livré le 21 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The benefit of all investments key accounts intellectual property shares and any warrants options and other rights debts the transaction documents goodwill and uncalled capital. By way of floating charge its undertaking and all property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Australia Bank Limited
    Transactions
    • 21 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Second debenture
    Créé le 13 sept. 2005
    Livré le 21 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The benefit of all investments key accounts intellectual property shares and any warrants options and other rights debts the transaction documents goodwill and uncalled capital. By way of floating charge its undertaking and all property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 21 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 29 août 2001
    Livré le 07 sept. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 07 sept. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0