EQUITON GP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEQUITON GP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03837119
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EQUITON GP LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe EQUITON GP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Cunard House
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EQUITON GP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INTERCEDE 1479 LIMITED07 sept. 199907 sept. 1999

    Quels sont les derniers comptes de EQUITON GP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour EQUITON GP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2017 avec mises à jour

    7 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    33 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 juin 2016

    État du capital au 28 juin 2016

    • Capital: GBP 300
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    29 pagesAA

    Nomination de Mr Simon Christian Pursey en tant qu'administrateur le 20 juil. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Richard Proctor en tant que directeur le 20 juil. 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 juil. 2015

    État du capital au 13 juil. 2015

    • Capital: GBP 300
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    29 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 juin 2014

    État du capital au 19 juin 2014

    • Capital: GBP 300
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Richard Proctor le 20 janv. 2014

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    24 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Philip Anthony Redding le 06 févr. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Richard Proctor le 04 oct. 2012

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de David Emburey en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Peter Cooper-Parry en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Susan Clayton en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alastair Hughes en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    25 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02

    Qui sont les dirigeants de EQUITON GP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BLEASE, Elizabeth Ann
    Cunard House
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    Secrétaire
    Cunard House
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    Other132060350001
    PURSEY, Simon Christian
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    258
    Administrateur
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    258
    United KingdomBritishDirector190915460001
    REDDING, Philip Anthony
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    Administrateur
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    EnglandBritishDirector126099150003
    DIXON, Susan Elizabeth
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    Secrétaire
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    BritishChartered Secretary90007990001
    HOWELL, Richard
    Flat 7 Kilmeny House
    36 Arterberry Road Wimbledon
    SW20 8AQ London
    Secrétaire
    Flat 7 Kilmeny House
    36 Arterberry Road Wimbledon
    SW20 8AQ London
    BritishFinancial Controller164790590001
    SILVER, Helen Frances
    68 Glenwood Gardens
    IG2 6XU Ilford
    Essex
    Secrétaire
    68 Glenwood Gardens
    IG2 6XU Ilford
    Essex
    British120878580001
    WATTS, Nigel Anthony
    32 Springfield Park
    North Parade
    RH12 2BF Horsham
    West Sussex
    Secrétaire
    32 Springfield Park
    North Parade
    RH12 2BF Horsham
    West Sussex
    BritishChartered Accountant6864530001
    WHALLEY, Amanda
    12 Merchant Court
    61 Wapping Wall Wapping
    E1W 3SD London
    Secrétaire
    12 Merchant Court
    61 Wapping Wall Wapping
    E1W 3SD London
    British124348320001
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British125719290002
    YOUNG, Mark Lees
    30 Southway
    Totteridge
    N20 8DB London
    Secrétaire
    30 Southway
    Totteridge
    N20 8DB London
    British85330350001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Secrétaire désigné
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900004680001
    AGNEW, Julian Michael, Mr.
    2 Blythwood Road
    N4 4EU Stroud Green
    London
    Administrateur
    2 Blythwood Road
    N4 4EU Stroud Green
    London
    EnglandBritishDirector151724030001
    ANDREWS, Michael John
    Elm Grove Road
    Ealing
    W5 3JJ London
    14
    Administrateur
    Elm Grove Road
    Ealing
    W5 3JJ London
    14
    BritishChartered Surveyor98009700001
    BRIDSON, Thomas Paul Ridgway
    8 Crafts Lane
    GU31 4QQ Petersfield
    Hampshire
    Administrateur
    8 Crafts Lane
    GU31 4QQ Petersfield
    Hampshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor87931170001
    CLAYTON, Susan Vivien
    11 Patten Road
    SW18 3RH London
    Administrateur
    11 Patten Road
    SW18 3RH London
    EnglandBritishChartered Surveyor98599620001
    COOPER-PARRY, Peter Roger
    76 Lambton Road
    West Wimbledon
    SW20 0LP London
    Administrateur
    76 Lambton Road
    West Wimbledon
    SW20 0LP London
    BritishChartered Accountant64390460001
    DAWSON, Peter Allan
    9 St James Close
    St Johns Wood
    NW8 7LG London
    Administrateur
    9 St James Close
    St Johns Wood
    NW8 7LG London
    BritishChartered Surveyor64472530003
    EMBUREY, David
    Franconia Road
    SW4 9NB London
    23
    Administrateur
    Franconia Road
    SW4 9NB London
    23
    BritishCompany Director140324000001
    HUGHES, Alastair
    42 Achilles Road
    NW6 1EA London
    Administrateur
    42 Achilles Road
    NW6 1EA London
    BritishDirector66863880001
    PROCTOR, David Richard
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    258
    Administrateur
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    258
    UkBritishDirector125387760001
    RICH, Michael William
    Hillfield
    Gorse Hill
    DA4 0JU Farningham
    Kent
    Administrateur désigné
    Hillfield
    Gorse Hill
    DA4 0JU Farningham
    Kent
    British900015380001
    WARNER, William
    2 Honeysuckle Gardens
    CR0 8XU Croydon
    Administrateur
    2 Honeysuckle Gardens
    CR0 8XU Croydon
    BritishChartered Secretary62351120001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur EQUITON GP LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    06 avr. 2016
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 1985
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03837112
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Warwick Street
    W1B 5NH London
    30
    England
    06 avr. 2016
    Warwick Street
    W1B 5NH London
    30
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 1985
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement01188567
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    10 Paternoster Row
    EC4M 7HP London
    St Martin's Court
    England
    06 avr. 2016
    10 Paternoster Row
    EC4M 7HP London
    St Martin's Court
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 1985 To 1989
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement02704074
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.

    EQUITON GP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Jersey mortgage of shares
    Créé le 23 juil. 2004
    Livré le 13 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the issued shares in the share capital of each subsidiary obligor listed in schedule to form 395 together with all related rights (inclusive of dividend interest and bonus).. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • `
    • Hsbc Bank PLC (As Agent and Trustee for the Finance Parties)
    Transactions
    • 13 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security assignment
    Créé le 23 juil. 2004
    Livré le 13 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities of each obligor to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed security over all the company's interest in and to all moneys standing to the credit of any account (including, without limitation, any account but excluding the LP rent account) with any person and the debts represented by them. All book debts and other debts the proceeds of the same and all other moneys due or owing to it and the benefit of all rights securities and guarantees of any nature enjoyed or held by it in relation to any of the foregoing, but excluding any of the foregoing which relate to the excluded properties (including the excluded rental income). All it's rights under any hedging agreements (to the extent they are not subject to an effective assignment under clause 2.2 of the deed), together with uncalled capital .floating security over all assets of the company not charged by way of fixed security. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC (As Agent)
    Transactions
    • 13 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement
    Créé le 23 juil. 2004
    Livré le 13 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities of each obligor to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed security over all the company's interest in and to all moneys standing to the credit of any account (including, without limitation, any account but excluding the LP rent account) with any person and the debts represented by them all book debts and other debts the proceeds of the same and all other moneys due or owing to it and the benefit of all rights securities and guarantees of any nature enjoyed or held by it in relation to any of the foregoing, but excluding any of the foregoing which relate to the excluded properties (including the excluded rental income). All it's rights under any hedging agreements (to the extent they are not subject to an effective assignment under clause 2.2 of the deed), together with uncalled capital .floating security over all assets of the company not charged by way of fixed security. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC (As Agent)
    Transactions
    • 13 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement made between the chargor as general partner of the limited partnership known as equiton industrial partnership and the agent
    Créé le 12 déc. 2003
    Livré le 16 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land on the east side of wintersell road, weybridge k/a units A301-A305, brooklands industrial park t/no. SY563436. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC (The "Agent")
    Transactions
    • 16 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement made between the chargor and the agent
    Créé le 12 déc. 2003
    Livré le 16 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land on the east side of wintersell road, weybridge k/a units A301-A305, brooklands industrial park t/no. SY563436. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC (The "Agent")
    Transactions
    • 16 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement
    Créé le 30 sept. 2003
    Livré le 20 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The leasehold property being land and buildings to the east side of wintersell road, weybridge. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 20 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement
    Créé le 30 sept. 2003
    Livré le 20 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The leasehold property being land and buildings to the east side of wintersell road weybridge. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 20 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement
    Créé le 05 juin 2003
    Livré le 25 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 25 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement
    Créé le 05 juin 2003
    Livré le 25 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 25 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Jersey mortgage of shares
    Créé le 31 mars 2003
    Livré le 04 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Its right title and interest in and to the shares and the related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 04 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement
    Créé le 06 févr. 2003
    Livré le 20 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Imperial park randalls way leatherhead t/n SY695464. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 20 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement
    Créé le 24 juin 2002
    Livré le 12 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Link 20 bellingham way aylesford maidstone kent t/nos K816776 and K715460. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC (The Agent)
    Transactions
    • 12 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement
    Créé le 24 juin 2002
    Livré le 12 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Link 20 bellingham way aylesford maidstone kent t/nos K816776 and K715460. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC (The Agent)
    Transactions
    • 12 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement between, among others, the company and hsbc investment bank PLC (the "agent")
    Créé le 24 déc. 2001
    Livré le 28 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due on any account whatsoever from each obligor to each finance party under each finance document (all terms as defined)
    Brèves mentions
    The f/h property k/a maxted corner 77 eaton road hemel hempstead t/n HD309649. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsb Investment Bank PLC
    Transactions
    • 28 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement between, among others, the company as general partner of the limited partnership under the name of equiton industrial partnership and hsbc investment bank PLC (the "agent")
    Créé le 24 déc. 2001
    Livré le 28 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due on any account whatsoever from each obligor to each finance party under each finance document (all terms as defined)
    Brèves mentions
    The f/h property k/a maxted corner 77 eaton road hemel hempstead t/n HD309649. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsb Investment Bank PLC
    Transactions
    • 28 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement between, among others, the company and hsbc investment bank PLC (the "agent")
    Créé le 19 déc. 2001
    Livré le 28 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due on any account whatsoever from each obligor to each finance party under each finance document (all terms as defined)
    Brèves mentions
    Falcon park industrial estate neasden lane neasden middlesex t/n NGL788033. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsb Investment Bank PLC
    Transactions
    • 28 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement between, among others, the company as general partner of the limited partnership under the name of equiton industrial partnership and hsbc investment bank PLC (the "agent")lloyds tsb bank PLC
    Créé le 19 déc. 2001
    Livré le 28 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due on any account whatsoever from each obligor to each finance party under each finance document (all terms as defined)
    Brèves mentions
    Falcon park industrial estate neasden lane neasden middlesex t/n NGL788033. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsb Investment Bank PLC
    Transactions
    • 28 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement
    Créé le 14 déc. 2001
    Livré le 20 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the chargee under each finance document
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC
    Transactions
    • 20 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement
    Créé le 14 déc. 2001
    Livré le 20 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the chargee under each finance document
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC
    Transactions
    • 20 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement between,among others,the company and the agent (as defined)
    Créé le 06 déc. 2001
    Livré le 19 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from each obligor (as defined) to each finance party (as defined) under each finance document (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC
    Transactions
    • 19 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement between,among others,the company and the agent (as defined)
    Créé le 06 déc. 2001
    Livré le 19 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from each obligor (as defined) to each finance party (as defined) under each finance document (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC
    Transactions
    • 19 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0