ASHLEY CENTRE TWO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéASHLEY CENTRE TWO LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03840768
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ASHLEY CENTRE TWO LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe ASHLEY CENTRE TWO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    22 Chapter Street
    SW1P 4NP London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ASHLEY CENTRE TWO LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour ASHLEY CENTRE TWO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2017

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 sept. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 52 Grosvenor Gardens London SW1W 0AU à 22 Chapter Street London SW1P 4NP le 07 févr. 2018

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Kenneth Charles Ford en tant que directeur le 20 déc. 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 08 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Notification de The Mall (General Partner) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02

    Cessation de Ashley Epsom Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    1 pagesPSC07

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2016

    6 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Charles Andrew Rover Staveley le 12 juin 2017

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kenneth Charles Ford le 12 juin 2017

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr James Maltby Ryman en tant qu'administrateur le 22 déc. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mark Richard Bourgeois en tant que directeur le 22 déc. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2015

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 sept. 2015

    État du capital au 08 sept. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2014

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de Ian Bryan Womack en tant que directeur le 15 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 sept. 2014

    État du capital au 08 sept. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2013

    6 pagesAA

    Nomination de Mr Mark Richard Bourgeois en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Xavier Pullen en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 sept. 2013

    État du capital au 09 sept. 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Qui sont les dirigeants de ASHLEY CENTRE TWO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WETHERLY, Stuart Andrew
    Chapter Street
    SW1P 4NP London
    22
    England
    Secrétaire
    Chapter Street
    SW1P 4NP London
    22
    England
    177484510001
    RYMAN, James Maltby
    Chapter Street
    SW1P 4NP London
    22
    England
    Administrateur
    Chapter Street
    SW1P 4NP London
    22
    England
    United KingdomBritishChartered Surveyor218328080001
    STAVELEY, Charles Andrew Rover
    Chapter Street
    SW1P 4NP London
    22
    England
    Administrateur
    Chapter Street
    SW1P 4NP London
    22
    England
    EnglandBritishChartered Accountant133771640001
    CORAL, Lynda Sharon
    26 Dene Road
    HA6 2BT Northwood
    Middlesex
    Secrétaire
    26 Dene Road
    HA6 2BT Northwood
    Middlesex
    BritishChartered Accountant34029880002
    DESAI, Falguni Rameshchandra
    Apartment 108
    20 Palace Street
    SW1E 5BA London
    Secrétaire
    Apartment 108
    20 Palace Street
    SW1E 5BA London
    British77755390004
    FETTER SECRETARIES LIMITED
    C/O Kendall Freeman
    43 Fetter Lane
    EC4A 1JU London
    Secrétaire
    C/O Kendall Freeman
    43 Fetter Lane
    EC4A 1JU London
    71203580001
    BARBER, Martin
    8 Highfields Grove
    N6 6HN London
    Administrateur
    8 Highfields Grove
    N6 6HN London
    BritishCompany Director35534320006
    BOURGEOIS, Mark Richard
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0AU London
    52
    Administrateur
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0AU London
    52
    EnglandBritishChartered Surveyor60776880004
    BOYLAND, Roger Michael
    Flat 5 Wellesley House
    Lower Sloane Street
    SW1W 8AL London
    Administrateur
    Flat 5 Wellesley House
    Lower Sloane Street
    SW1W 8AL London
    BritishChartered Accountant33984480006
    CLARK, Philip John
    26 Bourne Avenue
    Southgate
    N14 6PD London
    Administrateur
    26 Bourne Avenue
    Southgate
    N14 6PD London
    United KingdomBritishCompany Director101932350001
    COPELAND, Anne Marie
    3 The Manor House
    Roxwell Road
    CM1 3RY Writtle
    Essex
    Administrateur
    3 The Manor House
    Roxwell Road
    CM1 3RY Writtle
    Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor87679960001
    CORAL, Lynda Sharon
    Westacre
    1a Sandy Lodge Road
    WD3 1LP Moor Park
    Hertfordshire
    Administrateur
    Westacre
    1a Sandy Lodge Road
    WD3 1LP Moor Park
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant34029880004
    FORD, Kenneth Charles
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0AU London
    52
    Administrateur
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0AU London
    52
    EnglandBritishChartered Surveyor52710005
    FOX, Karen Julia
    The Roost
    Chinnor Road
    OX9 3QY Towersey
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Roost
    Chinnor Road
    OX9 3QY Towersey
    Oxfordshire
    BritishFund Manager116116000001
    JONES, Richard Peter
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    Administrateur
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    EnglandBritishChartered Surveyor76584200002
    LAXTON, Chris James Wentworth
    The Green
    Saxlingham
    NR15 1TH Nethergate
    Grove Farm House
    Norfolk
    Administrateur
    The Green
    Saxlingham
    NR15 1TH Nethergate
    Grove Farm House
    Norfolk
    United KingdomBritishInsurance Company Official198871760001
    LEWIS PRATT, Andrew
    Westacre
    1a Sandy Lodge Road
    WD3 1LP Moor Park
    Hertfordhire
    Administrateur
    Westacre
    1a Sandy Lodge Road
    WD3 1LP Moor Park
    Hertfordhire
    BritishChartered Surveyor60050050003
    NELL, Philip John Payton
    Bury Lodge
    Bury Lane Elmdon
    CB11 4NQ Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    Bury Lodge
    Bury Lane Elmdon
    CB11 4NQ Saffron Walden
    Essex
    EnglandBritishFund Manager105566370001
    PATTERSON, Christopher Lindsay
    17 Chatsworth Avenue
    SW20 8JZ London
    Administrateur
    17 Chatsworth Avenue
    SW20 8JZ London
    BritishFund Manager86029780001
    PULLEN, Xavier
    65 Studdridge Street
    SW6 3SL London
    Administrateur
    65 Studdridge Street
    SW6 3SL London
    EnglandBritishCompany Director78912170008
    SUNNUCKS, William D'Urban
    East Gores Farm
    Salmons Lane
    CO6 1RZ Coggeshall
    Essex
    Administrateur
    East Gores Farm
    Salmons Lane
    CO6 1RZ Coggeshall
    Essex
    EnglandBritishChart Accountant32866350001
    WOMACK, Ian Bryan
    6 Southwood Lawn Road
    Highgate
    N6 5SF London
    Administrateur
    6 Southwood Lawn Road
    Highgate
    N6 5SF London
    EnglandBritishChartered Surveyor33902000006
    FETTER INCORPORATIONS LIMITED
    C/O Kendall Freeman
    43 Fetter Lane
    EC4A 1JU London
    Administrateur
    C/O Kendall Freeman
    43 Fetter Lane
    EC4A 1JU London
    71203570001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ASHLEY CENTRE TWO LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Ashley Epsom Limited
    The Esplanade
    St. Helier
    JE2 3QA Jersey
    One
    Channel Islands
    06 avr. 2016
    The Esplanade
    St. Helier
    JE2 3QA Jersey
    One
    Channel Islands
    Oui
    Forme juridiqueLimited Liability Company
    Pays d'enregistrementJersey
    Autorité légaleJersey Law
    Lieu d'enregistrementJfsc
    Numéro d'enregistrement80728
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0AU London
    52
    England
    06 avr. 2016
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0AU London
    52
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement04331119
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    ASHLEY CENTRE TWO LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of charge (security and intercreditor deed)
    Créé le 05 mai 2005
    Livré le 23 mai 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company the borrower or any other obligor or any limited obligor to the obligor security trustee or any of the other obligor secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H and l/h property, specified assets, book debts, obligor security group shares, intellectual property, insurances, obligor transaction documents, net rental income, agreements floating charge all undertaking property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • J.P. Morgan Corporate Trustee Services Limited (For Itself and as Trustee for the Obligorsecured Creditors)
    Transactions
    • 23 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Obligor/issuer floating charge agreement
    Créé le 05 mai 2005
    Livré le 18 mai 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company, the borrower or (in the case of the obligors only)any other obligor or any limited obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first floating charge, the whole of its undertaking and all property assets and rights present and future (including all stock in trade f/h and l/h property and balance standing to the credit of any client accounts),. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Mall Funding PLC
    Transactions
    • 18 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 06 avr. 2004
    Livré le 16 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee and each of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land and buildings to the south of main road romford (now k/a the dolphin centre) havering t/n EGL416981. L/h land and buildings lying to the north of western road romford (now k/a liberty ii shopping centre) havering t/n EGL347983. L/h land the upper deck car park mercury gardens romford t/n EGL435359 for details of further property charged please refer to form 395.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Security Trustee and Agentfor the Finance Parties
    Transactions
    • 16 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed
    Créé le 20 oct. 2003
    Livré le 07 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee and each of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All assets rights and property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Security Trustee for Itselfand as Agent for the Finance Parties
    Transactions
    • 07 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 oct. 2003
    Livré le 25 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and each of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All that f/h land being 93-95A high street, epsom in the county of surrey t/n SY720308. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent and Security Trusteefor the Finance Parties (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 25 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 févr. 2003
    Livré le 05 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All of its present and future obligations and liabilities of the company to the security trustee and each of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All that f/h land being 109,111 and 113 high street epsom surrey t/n SY490462. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent and Security Trusteefor the Finance Parties
    Transactions
    • 05 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 févr. 2002
    Livré le 20 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee and each of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All that leasehold land being broadway shopping centre broadway bexleyheath in the london borough of bexley t/n SGL553179, all that freehold land being land and buildings to the south of main road romford (now known as the dolphin centre) havering t/n EGL416981 and all that leasehold land being land and buildings lying to the north of western road romford (known as liberty ii shopping centre) havering EGL347983 (for further details of property charged see schedule 3 of form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Security Trustee for Thefinance Parties (The Security Trustee) and (Theagent)
    Transactions
    • 20 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental legal charge pursuant to a mortgage debenture dated 4 october 1999
    Créé le 23 déc. 1999
    Livré le 07 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys obligations and liabilities due or to become due from ashley centre limited partnership (acting by its general partner meaning ashley centre gp limited) and/or the company to the chargee on any account whatsoever in relation to the debenture or the loan agreement constituted by the company's acceptance on 30 september 1999 of the lender's facility letter dated 29 september 1999 (the "loan agreement")
    Brèves mentions
    (I) l/hold land being the ashley centre epsom; t/no sy 547501; (ii) l/hold land being 120 car parking spaces at the ashley centre ashley avenue epsom; sy 549664; (iii) f/hold land being king's shade walk high street epsom; t/no sy 155051 and (iv) f/hold land being the white hart high street epsom; sy 473553. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Halifax PLC
    Transactions
    • 07 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 oct. 1999
    Livré le 12 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company and/or ashley centre limited partnership (acting by its general partner being ashley centre gp limited) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the debenture or any other finance document
    Brèves mentions
    All that l/h land being the ashley centre epsom. T/no.sy 547501. the l/h land being 120 car parking spaces at the ashley centre ashley avenue epsom. T/no. SY549664. F/h land being king's shade walk high street epsom. T/no.SY155051. F/h land being the white hart high street epsom. T/no.SY473553.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Halifax PLC
    Transactions
    • 12 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0