COSFORCE SHIPPING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOSFORCE SHIPPING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03841870
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COSFORCE SHIPPING LIMITED ?

    • Transport maritime et côtier de marchandises (50200) / Transports et stockage

    Où se situe COSFORCE SHIPPING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Cosco House
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Essex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COSFORCE SHIPPING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ALLCO SEAGAS LIMITED18 nov. 199918 nov. 1999
    VALLEYCLOSE LIMITED15 sept. 199915 sept. 1999

    Quels sont les derniers comptes de COSFORCE SHIPPING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour COSFORCE SHIPPING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2022

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 avr. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 21 avr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2021

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de Romeo Abenes Mendoza en tant que secrétaire le 30 sept. 2021

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Romeo Abenes Mendoza en tant que directeur le 30 sept. 2021

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 21 avr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2020

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 avr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2019

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 avr. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2018

    3 pagesAA

    Nomination de Mr Romeo Abenes Mendoza en tant qu'administrateur le 22 janv. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Gang Wang en tant qu'administrateur le 22 janv. 2018

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 21 avr. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2017

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de Jing Guo en tant que directeur le 22 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Shicheng Cheng Yang en tant que directeur le 01 juil. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Jing Guo en tant qu'administrateur le 17 mai 2017

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 21 avr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2016

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 juin 2016

    État du capital au 07 juin 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Qui sont les dirigeants de COSFORCE SHIPPING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NOROSE COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AQ London
    3
    Secrétaire
    More London Riverside
    SE1 2AQ London
    3
    138492980001
    WANG, Gang
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    Administrateur
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    United KingdomChineseDirector242944050001
    CARON DELION, Patrick
    First Floor Flat
    39 Nevern Square
    SW5 9PE London
    Secrétaire
    First Floor Flat
    39 Nevern Square
    SW5 9PE London
    BritishSolicitor/Lease Arranger95892040001
    LEWIN, Alastair Giles
    19 Severnake Close
    Isle Of Dogs
    E14 9WE London
    Secrétaire
    19 Severnake Close
    Isle Of Dogs
    E14 9WE London
    British73905180001
    MENDOZA, Romeo Abenes
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    Secrétaire
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    British66998480001
    SWANNELL, David William
    5c Hyde Park Mansions
    Transept Street
    NW1 5ES London
    Secrétaire
    5c Hyde Park Mansions
    Transept Street
    NW1 5ES London
    BritishLease Packager72665990002
    THORP, Richard Simon
    26 Murray Mews
    Camden
    NW1 9RJ London
    Secrétaire
    26 Murray Mews
    Camden
    NW1 9RJ London
    British98514070001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire désigné
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    CARON DELION, Patrick
    4 Esmond Road
    W4 1JQ London
    Administrateur
    4 Esmond Road
    W4 1JQ London
    EnglandOtherFinancier95892040003
    CHARLTON, Peter John
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur désigné
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    British900005610001
    DONG, Ming, Captain
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    Administrateur
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    ChineseChief Executive Officer And Director90829700001
    GRIFFIN, Philip Mark
    51 Olola Avenue
    2030 Vaucluse
    Nsw
    Australia
    Administrateur
    51 Olola Avenue
    2030 Vaucluse
    Nsw
    Australia
    AustralianFinancier49828980005
    GUO, Jing
    Herrengraben
    20459 Hamburg
    74
    Germany
    Administrateur
    Herrengraben
    20459 Hamburg
    74
    Germany
    GermanyChineseShipping231810330001
    HARRIS, Braden
    Flat D
    41 Lancaster Grove
    NW3 4HB London
    Administrateur
    Flat D
    41 Lancaster Grove
    NW3 4HB London
    United KingdomBritishFinancier72069860002
    JOBANPUTRA, Sandip
    7 High Holborn
    Flat 110
    WC1V 6DR London
    Administrateur
    7 High Holborn
    Flat 110
    WC1V 6DR London
    UkBritishFinancier83069380001
    KAYSER, Simon Philip
    Apartment 91
    Cinnabar Wharf East, 28 Wapping High Street
    E1W 1NG London
    Administrateur
    Apartment 91
    Cinnabar Wharf East, 28 Wapping High Street
    E1W 1NG London
    EnglandBritishFinancier99475270002
    MENDOZA, Romeo Abenes
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    Administrateur
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    EnglandBritishAccounts Manager66998480001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Administrateur désigné
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    SWANNELL, David William
    55 Albion Gate
    Hyde Park Place
    W2 2LG London
    Administrateur
    55 Albion Gate
    Hyde Park Place
    W2 2LG London
    BritishFinancier72665990003
    YANG, Shicheng Cheng
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    Administrateur
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    United KingdomChineseChief Executive Officer147770930003
    ZHAO, Lei, Mister
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    Administrateur
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    United KingdomChineseAccounts Manager127091490001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COSFORCE SHIPPING LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement4013305
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    COSFORCE SHIPPING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Second priority mortgage relating to M.V."cosco rotterdam",kawasaki hull no.1505 (Registered under the bahamas flag) as supplemented by collateral deed of covenant dated 11TH december 2000 and
    Créé le 13 févr. 2002
    Livré le 05 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All 64/64TH shares in the vessel and all boats,gun,etc.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Maritime Leasing (No.1) Limited
    Transactions
    • 05 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Transfer of mortgage executed by nedship bank N.V. (the "prior mortgagee") in favour of dvb group merchant bank (asia) limited transferring a first priority bahamas statutory mortgage in respect of M.V. "cosco rotterdam" executed by the owner in favour of the prior mortgagee
    Créé le 13 févr. 2002
    Livré le 27 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest in and to the vessel registered under the flag of the bahamas at the port of nassau with official number 8000417. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dvb Group Merchant Bank (Asia) LTD (as Security Trustee for the Banks)
    Transactions
    • 27 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    First priority bahamas statutory mortgage in respect of M.V. "cosco rotterdam" by the company (as owner) to nedship bank N.V.
    Créé le 13 févr. 2002
    Livré le 27 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest in and to the vessel registered under the flag of the bahamas at the port of nassau with official number 8000417. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nedship Bank N.V. (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 27 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A third priority assignment of insurances and requisition proceeds
    Créé le 13 févr. 2002
    Livré le 20 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The assigned property all right title interest and benefit in respect of the vessel all policies and contracts of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cosco (UK) Limited
    Transactions
    • 20 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of covenant
    Créé le 13 févr. 2002
    Livré le 20 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The right title and interest in and to the ship "cosco rotterdam" and in her equipment and appurtenances and in any proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cosco (U.K) Limited
    Transactions
    • 20 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 13 févr. 2002
    Livré le 20 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to the ship "cosco rotterdam" official no. 8000417 and in her equipment and appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Cosco (U.K.) Limited
    Transactions
    • 20 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of general assignment dated 6TH april 2001 between the company allco finance limited (afl) ,allco finance (UK) limited (afuk) and lloyds tsb maritime leasing (no.1) limited (the "assignee")
    Créé le 06 avr. 2001
    Livré le 12 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company, afl or afuk to the chargee under the terms of the security document
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest present and future in and to (I) the insurances including all payments to the company in respect of all claims rights and remedies of the company arising therefrom (ii) any requisition compensation (iii) all sums standing to the credit of the account in the name of the company (iv) the bareboat charter (other than the b charterhire payable thereunder) and the bareboat charterers assignment and all claims rights and remedies of the company arising therefrom (v) the refund guarantees (vi) the novated shipbuilding contract and novation agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Maritime Leasing (No.1 ) Limited
    Transactions
    • 12 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Investor assignment (owner) (the "security document") dated 6TH april 2001 between the company, cosforce shipping limited (the "owner") and lloyds tsb maritime leasing (no.1) limited (the "assignee")
    Créé le 06 avr. 2001
    Livré le 12 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security document
    Brèves mentions
    All rights title and interest present and future actual or contingent of the company and the owner in and under (I) the bareboat charter to the extent that the same relates to the obligation of the bareboat charterer to pay b charthire and (ii) the agreement to charter and the time charter to the extent as the same relates to the obligation of the time charterers to pay certain amounts (together with b charterhire, the "relevant amounts") referred in the agreement to charter. Including in each case all payments to the owner pursuant thereto and all claims rights and remedies of the owner arisiarising therefrom including a).all damages and compensation payable for or in respect thereof.b). The right to amend, vary or supplement the bareboat charter, the agreement to charter or the time charter as they relate to the relevant amounts c). The right to grant any consent, approval waiver or confirmation under the bareboat charter the agreement to charter or the time charter as they relate to the relevant amounts. (The "assigned property"),. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Maritime Leasing (No.1) Limited
    Transactions
    • 12 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of general assignment and covenant relating to hull no 1505 (T.B.N. "river cosforce") executed by cosforce shipping limited (the "owner"), allco finance limited ("afl") and allco finance (UK) limited ("afuk") in favour or nedship bank N.V. (the "assignee")
    Créé le 11 déc. 2000
    Livré le 22 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies, liabilities and obligations (whether actual or contingent, whether now existing or hereafter arising, whether as principal or surety, whether or not for the payment of money and including any obligation or liability to pay damages) which are now or which may at any time and from time to time hereafter be due, owing, payable or incurred from or by afuk to the assignee (in its own capacity or in its capacity as security trusteee for the beneficiaries)
    Brèves mentions
    All right title and interest in to any under the account, the agreement and the insurances and any requisitions compensation the vessel all sums to the credit of the account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nedship Bank N.V. (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 22 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture creating a floating charge postponed to all other security interests
    Créé le 11 déc. 2000
    Livré le 22 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies, liabilities and obligations (whether actual or contingent, whether now existing or hereafter arising, whether as principal or surety, whether or not for the payment of money and including any obligation or liability to pay damages) which are now or which may at any time and from time to time hereafter be due, owing, payable or incurred from or by the security party (as defined) to the chargee and/or any of the beneficiaries (as defined) under the transaction documents (as defined)
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Nedship Bank N.V. (Acting as Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 22 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0