PADRINO PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPADRINO PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03854092
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PADRINO PROPERTIES LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction
    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe PADRINO PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Bucks
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de PADRINO PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour PADRINO PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    16 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 23 nov. 2018

    17 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de 105 Wigmore Street London W1U 1QY à 81 Station Road Marlow Bucks SL7 1NS le 13 déc. 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 24 nov. 2017

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 06 oct. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    2 pagesMR04

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2016

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 oct. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2015

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 oct. 2015

    État du capital au 07 oct. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    15 pagesAA

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2014 au 30 avr. 2015

    1 pagesAA01

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 19 déc. 2014

    2 pages3.6

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 oct. 2014

    État du capital au 27 oct. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr George Raymond Iestyn Llewellyn Smith le 01 sept. 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr William James Killick le 01 sept. 2014

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de 20 Balderton Street London W1K 6TL à 105 Wigmore Street London W1U 1QY le 02 sept. 2014

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de PADRINO PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KILLICK, William James
    Station Road
    SL7 1NS Marlow
    81
    Bucks
    Administrateur
    Station Road
    SL7 1NS Marlow
    81
    Bucks
    EnglandBritish71352980002
    LLEWELLYN SMITH, George Raymond Iestyn
    Station Road
    SL7 1NS Marlow
    81
    Bucks
    Administrateur
    Station Road
    SL7 1NS Marlow
    81
    Bucks
    United KingdomBritish161701390001
    GOLDSMITH, Christopher William
    Warehouse
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The
    United Kingdom
    Secrétaire
    Warehouse
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The
    United Kingdom
    British13230340005
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secrétaire désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    BARNES, Sara Anne
    Warehouse
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The
    United Kingdom
    Administrateur
    Warehouse
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The
    United Kingdom
    United KingdomBritish98921440001
    CARTER, Andrew Stewart
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    Administrateur
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    United KingdomBritish145669000001
    CARTER, Andrew Stewart
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    Administrateur
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    United KingdomBritish145669000001
    GOLDSMITH, Christopher William
    Balderton Street
    W1K 6TL London
    20
    England
    Administrateur
    Balderton Street
    W1K 6TL London
    20
    England
    EnglandBritish13230340006
    HUGHSON, David Callum
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    Administrateur
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    British62284790002
    MARTIN, Julia Helen
    79 Streathbourne Road
    SW17 8RA London
    Administrateur
    79 Streathbourne Road
    SW17 8RA London
    British84688790001
    MARTIN, Julia Helen
    79 Streathbourne Road
    SW17 8RA London
    Administrateur
    79 Streathbourne Road
    SW17 8RA London
    British84688790001
    MAXEY, Christopher John
    Elmsted Skreens Park Road
    Roxwell
    CM1 4NL Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    Elmsted Skreens Park Road
    Roxwell
    CM1 4NL Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritish46329910002
    MOULDER, Stuart Christopher
    Uvongo House Blackmore Road
    Blackmore
    CM4 0QX Ingatestone
    Essex
    Administrateur
    Uvongo House Blackmore Road
    Blackmore
    CM4 0QX Ingatestone
    Essex
    EnglandBritish46329920001
    PARDOE, Richard Grenville
    Cherry Tree Cottage
    17 West Avenue
    HP10 8AE Penn
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Cherry Tree Cottage
    17 West Avenue
    HP10 8AE Penn
    Buckinghamshire
    EnglandBritish141544990001
    PETTIT, Andrew John
    Balderton Street
    W1K 6TL London
    20
    Administrateur
    Balderton Street
    W1K 6TL London
    20
    EnglandBritish62947400004
    SCOTT, Nicholas Peter
    7 Poplar Close
    Great Gransden
    SG19 3AX Sandy
    Bedfordshire
    Administrateur
    7 Poplar Close
    Great Gransden
    SG19 3AX Sandy
    Bedfordshire
    EnglandBritish108455130001
    TAME, Russell
    Orchard House
    1a Mill Road
    CB21 5LT West Wratting
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Orchard House
    1a Mill Road
    CB21 5LT West Wratting
    Cambridgeshire
    British117422530001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PADRINO PROPERTIES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Wigmore Street
    W1U 1QY London
    105
    England
    18 avr. 2016
    Wigmore Street
    W1U 1QY London
    105
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Liability Partnership
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleLimited Liability Partnerships Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementOc332586
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    PADRINO PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 31 juil. 2012
    Livré le 06 août 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All that f/h land k/a 63-69 (odd) westgate streeet ipswich t/no.SK49426.
    Personnes ayant droit
    • Kbc Bank N.V
    Transactions
    • 06 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 107 févr. 2014Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
    • 123 sept. 2017Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
    • 14 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
      • Numéro de dossier 1
    Legal charge
    Créé le 31 juil. 2012
    Livré le 03 août 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrower and the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land and buildings k/a civic centre westgate street ipswich t/no SK297768 and f/h property k/a 63-69 (odd) westgate street ipswich t/no SK49426 by way of first fixed charge all it rights in each insurance policy the benefit of all other contracts guarantees appointments and warranties see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Turnstone Estates Limited
    Transactions
    • 03 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 oct. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 31 juil. 2012
    Livré le 03 août 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrower and the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land and buildings k/a civic centre westgate street ipswich t/no by way of fixed charge all its rights in each insurance policy the benefit of all other contracts guarantees appointments and warranties SK297768 f/h property k/a 63-69 (odd) westgate street ipswich t/no SK49426 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Revcap Properties 101 LLP
    Transactions
    • 03 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 oct. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 31 juil. 2007
    Livré le 07 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kbc Bank N.V.
    Transactions
    • 07 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 221 févr. 2014Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
    • 223 sept. 2017Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
    • 14 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
      • Numéro de dossier 2
    Charge deed
    Créé le 02 avr. 2001
    Livré le 18 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H proeprty k/a 136-138 lower mortlake road richmond - SY103299 SGL417634 and SGL201977 and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property and the proceeds of sale..assigned to the lender the related rights..fixed charge the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery..floating charge the undertaking all property and assets..assigned the goodwill and the intellectual property.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Northern Rock PLC
    Transactions
    • 18 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge deed
    Créé le 06 nov. 2000
    Livré le 10 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Clarendon house london road chelmsford t/n EX411282 and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property and the proceeds of sale..assigned to the lender the related rights..fixed charge the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery..floating charge the undertaking all property and assets..assigned the goodwill and the intellectual property.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Northern Rock PLC
    Transactions
    • 10 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge deed
    Créé le 22 sept. 2000
    Livré le 05 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a part ground floor and mezzanine floor the quays concordia street leeds west yorkshire. Assigns the goodwill of the business the benefit of the licences and by way of floating charge the undertaking and all other property and assets both present and future.
    Personnes ayant droit
    • Northern Rock PLC
    Transactions
    • 05 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge deed
    Créé le 17 déc. 1999
    Livré le 07 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Ambassador house brigstok road bensham moor road thornton heath croydon also ground floor parking spaces 194 to 216 chancellor court bensham moor road together. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. Assigns the goodwill of the business the benefit of the licences and by way of floating charge the undertaking and all other property and assets both present and future.
    Personnes ayant droit
    • Northern Rock PLC
    Transactions
    • 07 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    PADRINO PROPERTIES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Simon Robert Thomas
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    receiver manager
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    2Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Simon Robert Thomas
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    receiver manager
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    3
    DateType
    24 nov. 2017Commencement of winding up
    23 avr. 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Simon James Bonney
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Bucks
    practitioner
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Bucks
    Christopher Newell
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Bucks
    practitioner
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Bucks

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0