EAST CENTRAL DISTRIBUTION LIMITED

EAST CENTRAL DISTRIBUTION LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEAST CENTRAL DISTRIBUTION LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03854389
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EAST CENTRAL DISTRIBUTION LIMITED ?

    • (5164) /

    Où se situe EAST CENTRAL DISTRIBUTION LIMITED ?

    Adresse du siège social
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EAST CENTRAL DISTRIBUTION LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TRIGLOBAL LIMITED06 oct. 199906 oct. 1999

    Quels sont les derniers comptes de EAST CENTRAL DISTRIBUTION LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2004

    Quels sont les derniers dépôts pour EAST CENTRAL DISTRIBUTION LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    4 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 31 mars 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 sept. 2010

    5 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de 51 Tallon Road Hutton Industrial Estate Brentwood Essex CM13 1TG le 06 juil. 2010

    2 pagesAD01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 31 mars 2010

    5 pages4.68

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order insolvency:court order - removal of liquidator
    27 pagesLIQ MISC OC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 sept. 2009

    5 pages4.68

    Dépôt d'insolvabilité

    INSOLVENCY:secretary of state release of liquidator
    1 pagesLIQ MISC

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 31 mars 2009

    8 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 sept. 2008

    5 pages4.68

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    8 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    4 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    5 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    20 pages2.17B

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    5 pages2.24B

    Déclaration des affaires

    20 pages2.16B

    legacy

    9 pages363s

    Nomination d'un administrateur

    2 pages2.12B

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    5 pages395

    legacy

    9 pages395

    Qui sont les dirigeants de EAST CENTRAL DISTRIBUTION LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SHAND, Richard Edward
    Tibenham Farm
    Long Row, Tibenham
    NR16 1PD Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    Tibenham Farm
    Long Row, Tibenham
    NR16 1PD Norwich
    Norfolk
    BritishFinancial Director67118680001
    BYRNE, Matthew
    29 Herbert Street
    HP2 5HP Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Administrateur
    29 Herbert Street
    HP2 5HP Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    BritishOperations Director95491690001
    CHAFFEY, John Christian Mark
    3 Keswick Avenue
    RM11 1XR Hornchurch
    Essex
    Administrateur
    3 Keswick Avenue
    RM11 1XR Hornchurch
    Essex
    BritishSales Director67118740001
    DUCKHAM, Jonathan Robert
    2 Brook Park
    DA1 1NG Dartford
    Kent
    Administrateur
    2 Brook Park
    DA1 1NG Dartford
    Kent
    EnglandBritishTrade Sales Director76920040001
    KAY, Robert Clifton Boyd
    Leafy Grove House
    Heathfield Road Keston
    BR2 6BF Bromley
    Kent
    Administrateur
    Leafy Grove House
    Heathfield Road Keston
    BR2 6BF Bromley
    Kent
    EnglandBritishSales Director101990920001
    LANE, Stephen John
    56 Cadwell Drive
    SL6 3YR Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    56 Cadwell Drive
    SL6 3YR Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritishSales Director67118920001
    NEWCOMB, Philip Tryeve
    14 Great Ashby Way
    SG1 6AW Stevenage
    Hertfordshire
    Administrateur
    14 Great Ashby Way
    SG1 6AW Stevenage
    Hertfordshire
    BritishSales Director67166370001
    SHAND, Richard Edward
    Tibenham Farm
    Long Row, Tibenham
    NR16 1PD Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Tibenham Farm
    Long Row, Tibenham
    NR16 1PD Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishFinancial Director67118680001
    SHORT, John Richard
    The Cottage
    Church Lane
    CB23 8HE Lolworth
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    The Cottage
    Church Lane
    CB23 8HE Lolworth
    Cambridgeshire
    BritishSolicitor8407810001
    RM REGISTRARS LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Secrétaire désigné
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900000760001
    KEMPF, Meyer Isaac
    86 Church Lane
    Cheshunt
    EN8 0EA Waltham Cross
    Hertfordshire
    Administrateur
    86 Church Lane
    Cheshunt
    EN8 0EA Waltham Cross
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector90937820001
    MILNE, David John
    Thistle Hall
    Mope Lane Wickham Bishops
    CM8 3JP Witham
    Essex
    Administrateur
    Thistle Hall
    Mope Lane Wickham Bishops
    CM8 3JP Witham
    Essex
    United KingdomBritishDirector67118980002
    SARGOOD, John Patrick
    57 Navarre Gardens
    RM5 2HL Romford
    Essex
    Administrateur
    57 Navarre Gardens
    RM5 2HL Romford
    Essex
    BritishSales Director67118770001
    SHORT, John Richard
    The Cottage
    Church Lane
    CB23 8HE Lolworth
    Cambridgeshire
    Administrateur
    The Cottage
    Church Lane
    CB23 8HE Lolworth
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishSolicitor8407810001
    WOMACK, Michael Thomas, Mr.
    12 De Freville Avenue
    CB4 1HR Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    12 De Freville Avenue
    CB4 1HR Cambridge
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishSolicitor40606140002
    RM NOMINEES LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Administrateur désigné
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900009140001

    EAST CENTRAL DISTRIBUTION LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 17 mai 2005
    Livré le 28 mai 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Barclays bank PLC re east central distribution limited business premium account account number 60802425. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee & debenture
    Créé le 17 mai 2005
    Livré le 27 mai 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Fixed and floating charge
    Créé le 31 déc. 2002
    Livré le 17 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 17 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Keyman insurance assignment
    Créé le 28 févr. 2000
    Livré le 06 mars 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Interest in the life insurance policy: policy number L0195825811 and all monies payable thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Keyman insurance assignment
    Créé le 14 janv. 2000
    Livré le 19 janv. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The policies (1) david milne-dated-29.10.99 Term of 5 years policy number L0195115811DT sum assured £1,500,000 assurance society grardian financial serveces; (2) john sargood-dated-29.10.99 Term of 5 years policy number L0194215811DW sum assured £530,000 assurance society grardian financial services. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC as Security Trustee on Behalf of the Secured Parties
    Transactions
    • 19 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 02 nov. 1999
    Livré le 08 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 août 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    EAST CENTRAL DISTRIBUTION LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    01 oct. 2007Administration ended
    26 sept. 2005Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Martin Gilbert Ellis
    Grant Thornton Uk Llp
    Grant Thornton House
    NW1 2EP Melton Street
    Euston Square London
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    Grant Thornton House
    NW1 2EP Melton Street
    Euston Square London
    Anthony Norman Flynn
    Grant Thornton House
    Melton Street
    Euston Square
    London Nw1 2ep
    practitioner
    Grant Thornton House
    Melton Street
    Euston Square
    London Nw1 2ep
    Ian Stewart Carr
    Grant Thornton Uk Llp
    Byron House
    Cambridge Business Park
    Cowley Road Cambridge Cb4 Owz
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    Byron House
    Cambridge Business Park
    Cowley Road Cambridge Cb4 Owz
    2
    DateType
    24 sept. 2011Dissolved on
    01 oct. 2007Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Martin Gilbert Ellis
    Grant Thornton Uk Llp
    Grant Thornton House
    NW1 2EP Melton Street
    Euston Square London
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    Grant Thornton House
    NW1 2EP Melton Street
    Euston Square London
    Anthony Norman Flynn
    Grant Thornton House
    Melton Street
    Euston Square
    London Nw1 2ep
    practitioner
    Grant Thornton House
    Melton Street
    Euston Square
    London Nw1 2ep

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0