ML2020 LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéML2020 LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03854474
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ML2020 LTD ?

    • Autres activités d'ingénierie (71129) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe ML2020 LTD ?

    Adresse du siège social
    10 Fleet Place
    EC4M 7QS London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ML2020 LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MOUNTUNE LIMITED06 août 201906 août 2019
    REVOLVE TECHNOLOGIES LIMITED05 déc. 200805 déc. 2008
    ROUSH TECHNOLOGIES LIMITED07 oct. 199907 oct. 1999

    Quels sont les derniers comptes de ML2020 LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour ML2020 LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    30 pagesAM23

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    30 pagesAM10

    Changement d'adresse du siège social de 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL à 10 Fleet Place London EC4M 7QS le 18 déc. 2021

    2 pagesAD01

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    23 pagesAM10

    Changement d'adresse du siège social de C/O Kpmg Llp 2 Forbury Place 33 Forbury Road Reading Berkshire RG1 3AD à 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL le 15 oct. 2021

    2 pagesAD01

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    25 pagesAM10

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA/AM02SOC

    13 pagesAM02

    Changement d'adresse du siège social de Prospect Way Hutton Brentwood Essex CM13 1XA à C/O Kpmg Llp 2 Forbury Place 33 Forbury Road Reading Berkshire RG1 3AD le 29 déc. 2020

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    12 pagesAM02

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Avis d'approbation réputée des propositions

    3 pagesAM06

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    60 pagesAM03

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesAM01

    Déclaration de confirmation établie le 07 oct. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Inscription de la charge 038544740022, créée le 23 sept. 2020

    31 pagesMR01

    Inscription de la charge 038544740025, créée le 23 sept. 2020

    31 pagesMR01

    Inscription de la charge 038544740024, créée le 23 sept. 2020

    31 pagesMR01

    Inscription de la charge 038544740026, créée le 23 sept. 2020

    31 pagesMR01

    Inscription de la charge 038544740023, créée le 23 sept. 2020

    31 pagesMR01

    Inscription de la charge 038544740021, créée le 14 sept. 2020

    31 pagesMR01

    Cessation de la nomination de David Joseph Mountain en tant que directeur le 01 juil. 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Andrew Paul Williams en tant qu'administrateur le 20 févr. 2020

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de ML2020 LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILLIAMS, Andrew Paul
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    Secrétaire
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    175482350001
    PELL JOHNSON, Alec Thomas
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    Administrateur
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    EnglandBritishEngineer174948580001
    WILLIAMS, Andrew Paul
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    Administrateur
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    EnglandBritishChartered Accountant64482890001
    LYALL, Evan Douglas
    12445 Levan Road
    Livonia
    Michigan 48150
    Usa
    Secrétaire
    12445 Levan Road
    Livonia
    Michigan 48150
    Usa
    British66363280001
    ROBERTSON, Gary Stewart
    Prospect Way
    Hutton
    CM13 1XA Brentwood
    Essex
    Secrétaire
    Prospect Way
    Hutton
    CM13 1XA Brentwood
    Essex
    BritishAccountant100732200002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ANGELL JAMES, Henry James
    Berwick House
    SY4 3HW Shrewsbury
    Shropshire
    Administrateur
    Berwick House
    SY4 3HW Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor101460430001
    CORN, Robert Marian
    12445 Levan Road
    Livonia
    Michigan 48150
    Usa
    Administrateur
    12445 Levan Road
    Livonia
    Michigan 48150
    Usa
    UsaGroup President66363260002
    CRAWSHAY, Howard Huw Robin
    Llanfair Court
    Monmouth Road
    NP7 9SW Abergavenny
    Monmouthshire
    Administrateur
    Llanfair Court
    Monmouth Road
    NP7 9SW Abergavenny
    Monmouthshire
    BritishSolicitor80581170001
    GARETSON, Thomas Jeffrey
    53 Hainault Court
    Forest Rise Walthamstow
    E17 3NW London
    Administrateur
    53 Hainault Court
    Forest Rise Walthamstow
    E17 3NW London
    UsaDirector66363240002
    MITCHELL, John David
    Prospect Way
    Hutton
    CM13 1XA Brentwood
    Essex
    Administrateur
    Prospect Way
    Hutton
    CM13 1XA Brentwood
    Essex
    United KingdomBritishManaging Director100912170001
    MOORE, David Robert
    Prospect Way
    Hutton
    CM13 1XA Brentwood
    Essex
    Administrateur
    Prospect Way
    Hutton
    CM13 1XA Brentwood
    Essex
    EnglandBritishManager252849460001
    MOUNTAIN, David Joseph
    Prospect Way
    Hutton
    CM13 1XA Brentwood
    Essex
    Administrateur
    Prospect Way
    Hutton
    CM13 1XA Brentwood
    Essex
    United KingdomBritishTechnical Director275151850001
    ROBERTSON, Gary Stewart
    Prospect Way
    Hutton
    CM13 1XA Brentwood
    Essex
    Administrateur
    Prospect Way
    Hutton
    CM13 1XA Brentwood
    Essex
    EnglandBritishDirector100732200002
    ROUSH, Jack Ernest
    12445 Levan Road
    Livonia
    Michigan 48150
    Usa
    Administrateur
    12445 Levan Road
    Livonia
    Michigan 48150
    Usa
    UsaChief Executive Officer66363230002
    SMITH, Douglas Eugene
    12445 Levan Road
    Livonia
    Michigan 48150
    Usa
    Administrateur
    12445 Levan Road
    Livonia
    Michigan 48150
    Usa
    UsaExecutive Vice-President66363250001
    TURNER, Paul John
    Prospect Way
    Hutton
    CM13 1XA Brentwood
    Essex
    Administrateur
    Prospect Way
    Hutton
    CM13 1XA Brentwood
    Essex
    EnglandBritishEngineer127565880001
    WILLIAMS, Andrew Paul
    Prospect Way
    Hutton
    CM13 1XA Brentwood
    Essex
    Administrateur
    Prospect Way
    Hutton
    CM13 1XA Brentwood
    Essex
    United KingdomBritishAccountant126355500001
    WOODLAND, Ronald Cope
    12445 Levan Road
    Livonia
    Michigan 48150
    Usa
    Administrateur
    12445 Levan Road
    Livonia
    Michigan 48150
    Usa
    UsaGroup President66363270001
    YAGLEY, James Michael
    429 Eckford
    Troy
    Michigan
    48085
    Usa
    Administrateur
    429 Eckford
    Troy
    Michigan
    48085
    Usa
    UsaVice President100732070001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ML2020 LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Nitec Limited
    Prospect Way
    Hutton
    CM13 1XA Brentwood
    Prospect Way
    England
    06 avr. 2016
    Prospect Way
    Hutton
    CM13 1XA Brentwood
    Prospect Way
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEngland
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement06141055
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    ML2020 LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 23 sept. 2020
    Livré le 23 sept. 2020
    En cours
    Brève description
    Trade marks with the registered numbers EU007262462; EU007262553;. EU015348113 and EU015348063. Please refer to the instrument for further details.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rockpool (Security Trustee) Limited
    Transactions
    • 23 sept. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 23 sept. 2020
    Livré le 23 sept. 2020
    En cours
    Brève description
    Trade marks with the registered numbers EU007262462; EU007262553;. EU015348113 and EU015348063. Please refer to the instrument for further details.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rockpool (Security Trustee) Limited
    Transactions
    • 23 sept. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 23 sept. 2020
    Livré le 23 sept. 2020
    En cours
    Brève description
    Trade marks with the registered numbers EU007262462; EU007262553;. EU015348113 and EU015348063. Please refer to the instrument for further details.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rockpool (Security Trustee) Limited
    Transactions
    • 23 sept. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 23 sept. 2020
    Livré le 23 sept. 2020
    En cours
    Brève description
    Trade marks with the registered numbers EU007262462; EU007262553;. EU015348113 and EU015348063. Please refer to the instrument for further details.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rockpool (Security Trustee) Limited
    Transactions
    • 23 sept. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 23 sept. 2020
    Livré le 23 sept. 2020
    En cours
    Brève description
    Trade marks with the registered numbers EU007262462; EU007262553;. EU015348113 and EU015348063. Please refer to the instrument for further details.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rockpool (Security Trustee) Limited
    Transactions
    • 23 sept. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 14 sept. 2020
    Livré le 16 sept. 2020
    En cours
    Brève description
    Registered trade mark numbers EU007262462, EU007262553, EU015348113, EU015348063.. Unregistered intellectual property: mountune, mountune performance, mountune racing, M52.. Design rights to the products manufactured by the company in relation: ford fiesta st MK8, ford focus st MK4, mountune racing engines being engines used solely on a race track or other off road venue.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Tc Loans I Limited
    Transactions
    • 16 sept. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 24 déc. 2019
    Livré le 08 janv. 2020
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rockpool (Security Trustee) Limited
    Transactions
    • 08 janv. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 24 déc. 2019
    Livré le 08 janv. 2020
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rockpool (Security Trustee) Limited
    Transactions
    • 08 janv. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 12 oct. 2018
    Livré le 18 oct. 2018
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Tc Loans I Limited
    Transactions
    • 18 oct. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 03 oct. 2018
    Livré le 05 oct. 2018
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 oct. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 23 févr. 2018
    Livré le 28 févr. 2018
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rockpool (Security Trustee) Limited
    Transactions
    • 28 févr. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 23 févr. 2018
    Livré le 28 févr. 2018
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rockpool (Security Trustee) Limited
    Transactions
    • 28 févr. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 26 mai 2017
    Livré le 31 mai 2017
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rockpool (Security Trustee) Limited
    Transactions
    • 31 mai 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 28 févr. 2017
    Livré le 01 mars 2017
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 01 mars 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 31 oct. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 21 déc. 2016
    Livré le 28 déc. 2016
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 déc. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 31 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 10 juin 2015
    Livré le 13 juin 2015
    En cours
    Brève description
    Units a + b prospect way industrial estate prospect way hutton brentwood essex t/no. EX839973.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rockpool (Security Trustee) Limited
    Transactions
    • 13 juin 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 10 avr. 2014
    Livré le 15 avr. 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 avr. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 28 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    All assets debenture
    Créé le 17 févr. 2012
    Livré le 21 févr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 21 févr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 17 juin 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of rental deposit
    Créé le 23 févr. 2009
    Livré le 27 févr. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The initial deposit of £100,000 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Merchant Investors Assurance Company Limited
    Transactions
    • 27 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 07 janv. 2009
    Livré le 15 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 janv. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 13 nov. 2007
    Livré le 30 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Provident Capital Indemnity Limited
    Transactions
    • 30 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 13 nov. 2007
    Livré le 24 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Regency Factors PLC
    Transactions
    • 24 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 déc. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 13 nov. 2007
    Livré le 17 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £175,000 and all other monies due or to become due
    Brèves mentions
    Equipment - acoustic panels, cell structure. Borghi & saveri waterbreak dyno s/no 6154-98-1&2, schenck dynas 220 dyno's s/no M0058267.01, For details of further equipment charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • European Corporate Finance PLC
    Transactions
    • 17 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 13 nov. 2007
    Livré le 17 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £175,000 and all other monies due or to become due
    Brèves mentions
    Payment and discharge of all liabilities including all costs, expenses and charges incurred. All machinery, book debts. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • European Corporate Finance PLC
    Transactions
    • 17 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of rental deposit
    Créé le 05 avr. 2006
    Livré le 21 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The interest earning deposit account in which the chargee shall place the deposit of £120,000,. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Merchant Investors Assurance Company Limited
    Transactions
    • 21 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    ML2020 LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    16 oct. 2020Administration started
    18 mai 2022Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Christopher Robert Pole
    2 Forbury Place
    33 Forbury Road
    RG1 3AD Reading
    Berkshire
    practitioner
    2 Forbury Place
    33 Forbury Road
    RG1 3AD Reading
    Berkshire
    Sarah Elizabeth Collins
    2 Forbury Place, 33 Forbury Road
    Reading
    practitioner
    2 Forbury Place, 33 Forbury Road
    Reading

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0