HV REALISATIONS ONE 2009 LIMITED

HV REALISATIONS ONE 2009 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHV REALISATIONS ONE 2009 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03858180
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HV REALISATIONS ONE 2009 LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe HV REALISATIONS ONE 2009 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Old Barn
    Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke-On-Trent
    Staffordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HV REALISATIONS ONE 2009 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HENRY VENABLES LIMITED25 nov. 199925 nov. 1999
    ARWINSIDE LIMITED13 oct. 199913 oct. 1999

    Quels sont les derniers comptes de HV REALISATIONS ONE 2009 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour HV REALISATIONS ONE 2009 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    3 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 mai 2012

    18 pages4.68

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 20 avr. 2011

    17 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    17 pages2.34B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Résultat de la réunion des créanciers

    14 pages2.23B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 08 mai 2010

    14 pages2.24B

    Résultat de la réunion des créanciers

    24 pages2.23B

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Changement d'adresse du siège social de Wolverhampton Road Penkridge Stafford ST19 5NS United Kingdom le 28 nov. 2009

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2008

    16 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages190

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2007

    16 pagesAA

    legacy

    3 pages395

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    18 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de HV REALISATIONS ONE 2009 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    IMM, Sharon Ann
    The Woodhouse
    Hopton Wafers
    DY14 0EE Cleobury Mortimer
    Worcestershire
    Secrétaire
    The Woodhouse
    Hopton Wafers
    DY14 0EE Cleobury Mortimer
    Worcestershire
    British97805950001
    HADDRELL, David John
    18 Squirrels Hollow
    Boney Hay
    WS7 8YS Burntwood
    Staffordshire
    Administrateur
    18 Squirrels Hollow
    Boney Hay
    WS7 8YS Burntwood
    Staffordshire
    United KingdomBritish73281920001
    IMM, Julian Andrew
    The Woodhouse
    Hopton Wafers
    DY14 0EE Cleobury Mortimer
    Shropshire
    Administrateur
    The Woodhouse
    Hopton Wafers
    DY14 0EE Cleobury Mortimer
    Shropshire
    EnglandBritish97166280001
    DEAKIN, Susan
    23 Cliftondrive
    ST16 3UZ Stafford
    Staffordshire
    England
    Secrétaire
    23 Cliftondrive
    ST16 3UZ Stafford
    Staffordshire
    England
    British62561110001
    JONES, Keith
    16 Rokholt Crescent
    WS11 1HS Cannock
    Staffordshire
    Secrétaire
    16 Rokholt Crescent
    WS11 1HS Cannock
    Staffordshire
    British43297050002
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secrétaire désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    GERRISH, Philip Llewellyn
    Woodside Cottage
    Cranham
    GL4 8HB Gloucester
    Gloucestershire
    Administrateur
    Woodside Cottage
    Cranham
    GL4 8HB Gloucester
    Gloucestershire
    British46130530002
    HOLT, Shaun Bernard
    157 Corporation Street
    ST16 3LJ Stafford
    Staffordshire
    Administrateur
    157 Corporation Street
    ST16 3LJ Stafford
    Staffordshire
    United KingdomBritish86962510001
    JONES, Keith
    16 Rokholt Crescent
    WS11 1HS Cannock
    Staffordshire
    Administrateur
    16 Rokholt Crescent
    WS11 1HS Cannock
    Staffordshire
    EnglandBritish43297050002
    VENABLES, Timothy James
    4 Crescent Road
    ST17 9AW Stafford
    Staffordshire
    Administrateur
    4 Crescent Road
    ST17 9AW Stafford
    Staffordshire
    United KingdomBritish59420440002
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Administrateur désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    HV REALISATIONS ONE 2009 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent deposit deed
    Créé le 16 mai 2008
    Livré le 23 mai 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company charges £17,000.00 plus vat with full title guarantee charges by way of a fixed charge to all its right, title and interest see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Trw Pensions Trust Limited
    Transactions
    • 23 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mai 2008
    Legal charge
    Créé le 09 juin 2004
    Livré le 15 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Premises at tollgate industrial estate staff t/no SF457303.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 29 mars 2004
    Livré le 16 avr. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 21 juin 2002
    Livré le 12 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £635,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Premises at tollgate drive tollgate industrial estate stafford ST16 3NS.
    Personnes ayant droit
    • Julian Imm
    Transactions
    • 12 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 juin 2002
    Livré le 25 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £635,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Julian Andrew Imm
    Transactions
    • 25 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 mai 2002
    Livré le 06 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The f/h property at tollgate drive tollgate industrial estate stafford ST16 3HS.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 06 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 mai 2002
    Livré le 06 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The f/h property at tollgate drive tollgate industrial estate stafford ST16 3HS.
    Personnes ayant droit
    • The Stafford Railway Building Society
    Transactions
    • 06 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 juin 2001
    Livré le 20 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 20 juin 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    HV REALISATIONS ONE 2009 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 nov. 2009Administration started
    04 mai 2011Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Steven John Currie
    The Old Barn Caverswall Park
    Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    Staffordshire
    practitioner
    The Old Barn Caverswall Park
    Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    Staffordshire
    Robert Michael Young
    Currie Young Limited The Old Barn
    Caverswall Park, Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    practitioner
    Currie Young Limited The Old Barn
    Caverswall Park, Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    2
    DateType
    04 mai 2011Commencement of winding up
    09 juil. 2013Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Robert Michael Young
    Currie Young Limited The Old Barn
    Caverswall Park, Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    practitioner
    Currie Young Limited The Old Barn
    Caverswall Park, Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    Steven John Currie
    The Old Barn Caverswall Park
    Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    Staffordshire
    practitioner
    The Old Barn Caverswall Park
    Caverswall Lane
    ST3 6HP Stoke On Trent
    Staffordshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0