ULTRACOMP LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | ULTRACOMP LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03864176 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ULTRACOMP LIMITED ?
Adresse du siège social | 2nd Floor Burleigh House 375 The Strand WC2R 0HS London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ULTRACOMP LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2009 |
Quels sont les derniers dépôts pour ULTRACOMP LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2009 | 13 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 25 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de David Wright en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Gray en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Gray en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Speers en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Chester House 76-86 Chertsey Road Woking Surrey GU21 5BJ United Kingdom | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Speers en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Wright en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Gray en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Gray en tant que secrétaire | 2 pages | TM02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Chester House 76-86 Chertsey Road Woking Surrey GU21 5BJ le 05 nov. 2010 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 25 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Edward Speers le 25 nov. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Alistair Henton Wright le 25 nov. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Martin Gray le 25 nov. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 287 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2008 | 13 pages | AA | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2007 | 13 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288a | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de ULTRACOMP LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARLAND, David William Romanis | Administrateur | OX11 9AF South Moreton The Old Rectory Oxon | United Kingdom | British | Accountant | 136594420001 | ||||
BLOOMER, James Marian | Secrétaire | 34 Margerison Road Ilkley LS29 8QU Leeds West Yorkshire | British | Solicitor | 74570610001 | |||||
CONDIE, Aidan Scott | Secrétaire | 56 Ramworth Way HP21 7EX Aylesbury Buckinghamshire | British | Director | 74834880001 | |||||
GRAY, Andrew Martin | Secrétaire | 11 Holm Close KT15 3QN Woodham Surrey | British | Accountant | 118013850001 | |||||
KAY, Jonathan Walton | Secrétaire | 15 Carrwood WA16 8NB Knutsford Cheshire | United Kingdom | Accountant | 84667460002 | |||||
MYERS, Sarah Jane Louise | Secrétaire | 55 Northcote Crescent KT24 6LX West Horsley Surrey | British | Accountant | 113932490001 | |||||
PALFREYMAN, Debra (Aka Debbie) | Secrétaire | 19 Gerrards Fold Abbey Village PR6 8DL Chorley Lancashire | British | Director | 92373380001 | |||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||
CONDIE, Aidan Scott | Administrateur | 56 Ramworth Way HP21 7EX Aylesbury Buckinghamshire | England | British | Director | 74834880001 | ||||
GRAY, Andrew Martin | Administrateur | 11 Holm Close KT15 3QN Woodham Surrey | United Kingdom | British | Accountant | 118013850001 | ||||
HOWAT, Ian | Administrateur | 7 Long Meadows LS16 9DA Leeds West Yorkshire | British | Group Ceo Fox It Limited | 72871090001 | |||||
KAY, Jonathan Walton | Administrateur | 15 Carrwood WA16 8NB Knutsford Cheshire | England | United Kingdom | Accountant | 84667460002 | ||||
MOULDING, Nigel Philip | Administrateur | 4 Bodbury Close SY6 6EN Church Stretton Shropshire | United Kingdom | British | Accountant | 64672290003 | ||||
PALFREYMAN, Debra (Aka Debbie) | Administrateur | 19 Gerrards Fold Abbey Village PR6 8DL Chorley Lancashire | England | British | Director | 92373380001 | ||||
SPEERS, Paul Edward | Administrateur | 7 Seaton Close Putney SW15 3TJ London | United Kingdom | British | Director | 113360190001 | ||||
THOMPSON, John Reginald | Administrateur | 4 St. James Court Brooks Road W4 3BB London | British | Director | 75810970003 | |||||
WRIGHT, David Alistair Henton | Administrateur | Durham Road East Finchley N2 9DR London 101 United Kingdom | United Kingdom | British | Consulting Director | 133400440001 | ||||
DLA NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Administrateur désigné | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 |
ULTRACOMP LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Security over shares agreement | Créé le 19 déc. 2002 Livré le 03 janv. 2003 | En cours | Montant garanti All obligations due or to become due from fox it holdings limited to the new noteholders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The charged portfolio. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Floating charge created by way of debenture | Créé le 19 déc. 2002 Livré le 03 janv. 2003 | En cours | Montant garanti All obligations due or to become due from fox it holdings limited to the new noteholders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The whole of the company's undertaking and assets present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 14 août 2002 Livré le 28 août 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Floating charge | Créé le 13 déc. 1999 Livré le 17 déc. 1999 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the note and the mezzanine facility documents (as defined) | |
Brèves mentions Floating charge the whole of the company's undertaking and assets, present and future and any other assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A security over shares agreement | Créé le 13 déc. 1999 Livré le 17 déc. 1999 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the note and under the mezzanine facility documents (as defined) | |
Brèves mentions First fixed charge all the shares and all dividends interest and other monies payable in respect of the shares. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0