ULTRACOMP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéULTRACOMP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03864176
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ULTRACOMP LIMITED ?

    • (7260) /

    Où se situe ULTRACOMP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2nd Floor Burleigh House 375 The Strand
    WC2R 0HS London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ULTRACOMP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BROOMCO (1978) LIMITED25 oct. 199925 oct. 1999

    Quels sont les derniers comptes de ULTRACOMP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour ULTRACOMP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 déc. 2010

    État du capital au 15 déc. 2010

    • Capital: GBP 12,850,002
    SH01

    Cessation de la nomination de David Wright en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Gray en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Gray en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Paul Speers en tant que directeur

    1 pagesTM01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Chester House 76-86 Chertsey Road Woking Surrey GU21 5BJ United Kingdom

    1 pagesAD02

    Cessation de la nomination de Paul Speers en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Wright en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Gray en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Gray en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de Chester House 76-86 Chertsey Road Woking Surrey GU21 5BJ le 05 nov. 2010

    2 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Edward Speers le 25 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Alistair Henton Wright le 25 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Martin Gray le 25 nov. 2009

    2 pagesCH01

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    13 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    13 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    Qui sont les dirigeants de ULTRACOMP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HARLAND, David William Romanis
    OX11 9AF South Moreton
    The Old Rectory
    Oxon
    Administrateur
    OX11 9AF South Moreton
    The Old Rectory
    Oxon
    United KingdomBritishAccountant136594420001
    BLOOMER, James Marian
    34 Margerison Road
    Ilkley
    LS29 8QU Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    34 Margerison Road
    Ilkley
    LS29 8QU Leeds
    West Yorkshire
    BritishSolicitor74570610001
    CONDIE, Aidan Scott
    56 Ramworth Way
    HP21 7EX Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    56 Ramworth Way
    HP21 7EX Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishDirector74834880001
    GRAY, Andrew Martin
    11 Holm Close
    KT15 3QN Woodham
    Surrey
    Secrétaire
    11 Holm Close
    KT15 3QN Woodham
    Surrey
    BritishAccountant118013850001
    KAY, Jonathan Walton
    15 Carrwood
    WA16 8NB Knutsford
    Cheshire
    Secrétaire
    15 Carrwood
    WA16 8NB Knutsford
    Cheshire
    United KingdomAccountant84667460002
    MYERS, Sarah Jane Louise
    55 Northcote Crescent
    KT24 6LX West Horsley
    Surrey
    Secrétaire
    55 Northcote Crescent
    KT24 6LX West Horsley
    Surrey
    BritishAccountant113932490001
    PALFREYMAN, Debra (Aka Debbie)
    19 Gerrards Fold
    Abbey Village
    PR6 8DL Chorley
    Lancashire
    Secrétaire
    19 Gerrards Fold
    Abbey Village
    PR6 8DL Chorley
    Lancashire
    BritishDirector92373380001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Secrétaire désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    CONDIE, Aidan Scott
    56 Ramworth Way
    HP21 7EX Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    56 Ramworth Way
    HP21 7EX Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector74834880001
    GRAY, Andrew Martin
    11 Holm Close
    KT15 3QN Woodham
    Surrey
    Administrateur
    11 Holm Close
    KT15 3QN Woodham
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant118013850001
    HOWAT, Ian
    7 Long Meadows
    LS16 9DA Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    7 Long Meadows
    LS16 9DA Leeds
    West Yorkshire
    BritishGroup Ceo Fox It Limited72871090001
    KAY, Jonathan Walton
    15 Carrwood
    WA16 8NB Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    15 Carrwood
    WA16 8NB Knutsford
    Cheshire
    EnglandUnited KingdomAccountant84667460002
    MOULDING, Nigel Philip
    4 Bodbury Close
    SY6 6EN Church Stretton
    Shropshire
    Administrateur
    4 Bodbury Close
    SY6 6EN Church Stretton
    Shropshire
    United KingdomBritishAccountant64672290003
    PALFREYMAN, Debra (Aka Debbie)
    19 Gerrards Fold
    Abbey Village
    PR6 8DL Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    19 Gerrards Fold
    Abbey Village
    PR6 8DL Chorley
    Lancashire
    EnglandBritishDirector92373380001
    SPEERS, Paul Edward
    7 Seaton Close
    Putney
    SW15 3TJ London
    Administrateur
    7 Seaton Close
    Putney
    SW15 3TJ London
    United KingdomBritishDirector113360190001
    THOMPSON, John Reginald
    4 St. James Court
    Brooks Road
    W4 3BB London
    Administrateur
    4 St. James Court
    Brooks Road
    W4 3BB London
    BritishDirector75810970003
    WRIGHT, David Alistair Henton
    Durham Road
    East Finchley
    N2 9DR London
    101
    United Kingdom
    Administrateur
    Durham Road
    East Finchley
    N2 9DR London
    101
    United Kingdom
    United KingdomBritishConsulting Director133400440001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Administrateur désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Administrateur désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    ULTRACOMP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security over shares agreement
    Créé le 19 déc. 2002
    Livré le 03 janv. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All obligations due or to become due from fox it holdings limited to the new noteholders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The charged portfolio. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Indigo Capital Limited (As Trustee for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 03 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Floating charge created by way of debenture
    Créé le 19 déc. 2002
    Livré le 03 janv. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All obligations due or to become due from fox it holdings limited to the new noteholders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The whole of the company's undertaking and assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Indigo Capital Limited (As Trustee for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 03 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 14 août 2002
    Livré le 28 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 13 déc. 1999
    Livré le 17 déc. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the note and the mezzanine facility documents (as defined)
    Brèves mentions
    Floating charge the whole of the company's undertaking and assets, present and future and any other assets.
    Personnes ayant droit
    • Kleinwort Benson Limited as Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 17 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    A security over shares agreement
    Créé le 13 déc. 1999
    Livré le 17 déc. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the note and under the mezzanine facility documents (as defined)
    Brèves mentions
    First fixed charge all the shares and all dividends interest and other monies payable in respect of the shares. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kleinwort Benson Limited as Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 17 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0