ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03869350 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED ?
| Adresse du siège social | Suite A Ground Floor Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 30 mars 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 juin 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 nov. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 15 nov. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 nov. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Période comptable actuelle raccourcie du 31 mars 2025 au 30 mars 2025 | 1 pages | AA01 | ||
Notification de Sonderwell Bidco Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 janv. 2026 | 2 pages | PSC02 | ||
Cessation de Enviva Care Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 janv. 2026 | 1 pages | PSC07 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Inscription de la charge 038693500008, créée le 28 mars 2025 | 52 pages | MR01 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2024 | 25 pages | AA | ||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Senate Court Southernhay Gardens Exeter United Kingdom EX1 1NT | 1 pages | AD03 | ||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Senate Court Southernhay Gardens Exeter United Kingdom EX1 1NT | 1 pages | AD02 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Alistair Miller en tant qu'administrateur le 20 juin 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Changement d'adresse du siège social de Suite a, Ground Floor Trinity Court Molly Millars Lane Wokingham RG14 2PY United Kingdom à Suite a Ground Floor Trinity Court Molly Millars Lane Wokingham RG41 2PY le 03 mai 2024 | 1 pages | AD01 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2023 | 24 pages | AA | ||
Changement d'adresse du siège social de Indigo House Fishponds Road Wokingham RG41 2GY England à Suite a, Ground Floor Trinity Court Molly Millars Lane Wokingham RG14 2PY le 26 mars 2024 | 1 pages | AD01 | ||
Modification des détails de Enviva Care Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 mars 2024 | 2 pages | PSC05 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Ajay Patel en tant que directeur le 02 nov. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr John Michael Lee en tant qu'administrateur le 20 sept. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Paul Hayes en tant que directeur le 19 sept. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr David John Cole en tant qu'administrateur le 01 juil. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Gregory Leslie Minns en tant que directeur le 02 juin 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Ajay Patel en tant qu'administrateur le 02 juin 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Changement d'adresse du siège social de 11-15 st. Mary at Hill London EC3R 8EE England à Indigo House Fishponds Road Wokingham RG41 2GY le 05 juin 2023 | 1 pages | AD01 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2022 | 25 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Fiona Sheelagh Williams en tant que directeur le 18 mars 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Qui sont les dirigeants de ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLE, David John | Administrateur | Ground Floor Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Suite A United Kingdom | England | British | 194885080001 | |||||
| LEE, John Michael | Administrateur | Ground Floor Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Suite A United Kingdom | United Kingdom | British | 244871760002 | |||||
| MILLER, Alistair Mckenzie | Administrateur | Ground Floor Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Suite A United Kingdom | United Kingdom | British | 324274530001 | |||||
| ADDISON, Alina Dana | Secrétaire | 2 Maldon Close Camberwell SE5 8DD London | Romanian | 66758610001 | ||||||
| BATEMAN, Stephen John | Secrétaire | c/o C/O Housing21 Baring Road HP9 2NA Beaconsfield The Triangle Buckinghamshire England | 181014700001 | |||||||
| BROOKE BARNETT, Per John | Secrétaire | Flat 3 56 Langham Street W1W 7BB London | British | 16134520007 | ||||||
| BRUNT, Sarah | Secrétaire | Avoncroft Road Stoke Heath B60 4NG Bromsgrove 67 West Midlands | British | 130638250001 | ||||||
| BURTON, David | Secrétaire | Edney House Poachers Gate, Dawley TF4 3PZ Telford Shropshire | British | 86446240001 | ||||||
| COYLE, Clare | Secrétaire | 37 Margaret Street W1G 0JF London | British | 76303140003 | ||||||
| HAMPTON, Delyth | Secrétaire | c/o C/O Housing21 Baring Road HP9 2NA Beaconsfield The Triangle Buckinghamshire England | 171462770001 | |||||||
| HAMPTON, Sarah Delyth | Secrétaire | c/o C/O Housing21 Baring Road HP9 2NA Beaconsfield The Triangle Buckinghamshire England | 151897440001 | |||||||
| HUTTON, Paul Marcus | Secrétaire | SS1 1EH Southend On Sea 7 Nelson Street Essex United Kingdom | 183506140001 | |||||||
| JACKSON, David | Secrétaire | Institute Cottage Church Road Great Milton OX44 7PD Oxford Oxfordshire | British | 280628560001 | ||||||
| LUXTON, Claire | Secrétaire | c/o C/O Housing21 Baring Road HP9 2NA Beaconsfield The Triangle Buckinghamshire England | 171462820001 | |||||||
| SAMSON, Richard | Secrétaire | 21 Coldharbour Lane SE5 9NR London | British | 66891460001 | ||||||
| TOWNEND, Nicholas Adam | Secrétaire | c/o C/O Housing21 Baring Road HP9 2NA Beaconsfield The Triangle Buckinghamshire England | British | 154577090001 | ||||||
| FIRST SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 72 New Bond Street W1S 1RR London | 900000780001 | |||||||
| ADAMS, Mark Ian | Administrateur | 3 D'Abernon Close Esher Place KT10 8PT Esher Surrey | British | 100846890003 | ||||||
| ADDISON, Philip | Administrateur | 2 Maldon Close Camberwell SE5 8DD London | United Kingdom | British | 66758600001 | |||||
| BARTYZEL, Ilona Joanna | Administrateur | Monks Walk GU9 8HT Farnham Unit 5 Abbey Business Park England | England | Polish,British | 251159800001 | |||||
| BOOTY, Stephen Martin | Administrateur | Angel Gate 326 City Road EC1V 2PT London 30 England | England | British | 147928010001 | |||||
| BOWDEN, Sheila Elisabeth | Administrateur | c/o C/O Housing21 Baring Road HP9 2NA Beaconsfield The Triangle Buckinghamshire England | United Kingdom | British | 86445700001 | |||||
| BROOKE BARNETT, Per John | Administrateur | Flat 3 56 Langham Street W1W 7BB London | British | 16134520007 | ||||||
| BURTON, David | Administrateur | 40 Vicarage Road Edgbaston B15 3EZ Birmingham Claimar House West Midlands | England | British | 236544840001 | |||||
| CLARKE, Leslie Patrick | Administrateur | c/o C/O Housing21 Baring Road HP9 2NA Beaconsfield The Triangle Buckinghamshire England | England | British | 123317050001 | |||||
| COYLE, Clare | Administrateur | 37 Margaret Street W1G 0JF London | British | 76303140003 | ||||||
| CURL, Andrew Robert | Administrateur | Standford Lane Standford GU35 8RA Bordon Wood House Hampshire England | United Kingdom | English | 17346800001 | |||||
| EWERS, Andrew William | Administrateur | Monks Walk GU9 8HT Farnham Unit 5 Abbey Business Park England | England | British | 57655000001 | |||||
| HALES, Mark | Administrateur | 40 Vicarage Road Edgbaston B15 3EZ Birmingham Claimar House West Midlands | England | British | 115420980001 | |||||
| HAMMER, Sian Lynne | Administrateur | Monks Walk GU9 8HT Farnham Unit 5 Abbey Business Park England | England | British | 253845010001 | |||||
| HAYES, Paul | Administrateur | St. Mary At Hill EC3R 8EE London 11-15 England | England | Irish | 281195300001 | |||||
| HUMPHRIES, Richard | Administrateur | SS1 1EH Southend On Sea 7 Nelson Street Essex United Kingdom | England | British | 156574000001 | |||||
| JACKSON, David | Administrateur | Institute Cottage Church Road Great Milton OX44 7PD Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | 280628560001 | |||||
| KELLY, James | Administrateur | 68 Great Portland Street W1N 5AL London | Irish | 88294390001 | ||||||
| MINNS, Gregory Leslie | Administrateur | St Mary At Hill EC3R 8EE London 11-15 United Kingdom | England | British | 257024330001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonderwell Bidco Limited | 27 janv. 2026 | Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Suite A, Ground Floor United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Enviva Care Limited | 06 avr. 2016 | Trinity Court Molly Millars Lane RG14 2PY Wokingham Suite A, Ground Floor United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0